MALAIKA4 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMALAIKA4 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02190848
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MALAIKA4 LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe MALAIKA4 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MALAIKA4 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WIPAC GROUP LIMITED26 juil. 198826 juil. 1988
    CALLRESERVE LIMITED10 nov. 198710 nov. 1987

    Quels sont les derniers comptes de MALAIKA4 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour MALAIKA4 LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour MALAIKA4 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    GAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2013

    6 pagesAA

    État du capital au 30 avr. 2014

    • Capital: GBP 0.004
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2012

    6 pagesAA

    Nomination de Graham Middlemiss en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Nomination de Graham Middlemiss en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Tom Brophy en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2011

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Tom Brophy en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Alison Drew en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2010

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination d'un directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Robert Andrew Ross Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2009

    5 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Stephen Paul Webster le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de MALAIKA4 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MIDDLEMISS, Graham
    Spindle Lane
    Dickens Heath
    B90 1RP Solihull
    20
    West Midlands
    United Kingdom
    Secrétaire
    Spindle Lane
    Dickens Heath
    B90 1RP Solihull
    20
    West Midlands
    United Kingdom
    174237020001
    SMITH, Robert Andrew Ross
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    Administrateur
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    United KingdomBritish150753930001
    WOLSELEY DIRECTORS LIMITED
    Parkview 1220
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4GA Reading
    Administrateur
    Parkview 1220
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4GA Reading
    122185200001
    BRANSON, David Anthony
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    British272310001
    BROPHY, Tom
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Secrétaire
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    162242400001
    BUSHNELL, Adrian John
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    Secrétaire
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    British43046230002
    DREW, Alison
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Secrétaire
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    British86845230002
    FITZGERALD, Christopher John
    Field View Cottage
    Main Street Farthingstone
    NN12 8EZ Towcester
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Field View Cottage
    Main Street Farthingstone
    NN12 8EZ Towcester
    Northamptonshire
    British86703050001
    MARKANDAY, Vijay
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British49523130001
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    Secrétaire
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    British37378570013
    TURNER, John Patrick
    3 High Beeches
    Frimley
    GU16 8UG Camberley
    Surrey
    Secrétaire
    3 High Beeches
    Frimley
    GU16 8UG Camberley
    Surrey
    British53281480001
    WHITE, Mark Jonathan
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    British82978250001
    BRANSON, David Anthony
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    British272310001
    BROWN, Alan James
    2 Church Road
    CV8 3AR Baginton
    Lucy Price House
    Warwickshire
    Administrateur
    2 Church Road
    CV8 3AR Baginton
    Lucy Price House
    Warwickshire
    United KingdomBritish124294280002
    BUSHNELL, Adrian John
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    British43046230002
    BUTLER, Alan Frederick
    Cotswold House 5a Southlands
    Aston
    OX18 2DA Bampton
    Oxfordshire
    Administrateur
    Cotswold House 5a Southlands
    Aston
    OX18 2DA Bampton
    Oxfordshire
    British39813510001
    EARL, Geoffrey James
    3 Holcutt Close
    Wootton
    NN4 6AE Northampton
    Administrateur
    3 Holcutt Close
    Wootton
    NN4 6AE Northampton
    United KingdomBritish86673550001
    FERRIS, William Cyril
    2 Westwood Close
    WR9 0BD Droitwich
    Worcestershire
    Administrateur
    2 Westwood Close
    WR9 0BD Droitwich
    Worcestershire
    British1210060001
    FITZGERALD, Christopher John
    Field View Cottage
    Main Street Farthingstone
    NN12 8EZ Towcester
    Northamptonshire
    Administrateur
    Field View Cottage
    Main Street Farthingstone
    NN12 8EZ Towcester
    Northamptonshire
    United KingdomBritish86703050001
    JONES, Keith
    13 Hunt Close
    OX6 7HX Bicester
    Oxon
    Administrateur
    13 Hunt Close
    OX6 7HX Bicester
    Oxon
    British45399990002
    LANDSBERG, Kenneth William
    1 Lower Common Road
    SW15 1BP London
    Administrateur
    1 Lower Common Road
    SW15 1BP London
    British67271850002
    MARKANDAY, Vijay
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    20 Birchdale
    SL9 7JA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British49523130001
    MASTERS, Alexander Frank
    Grove Spring Nightingales Lane
    HP8 4SG Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Grove Spring Nightingales Lane
    HP8 4SG Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British9424220001
    MONK, Brian
    Wichita Shoppenhangers Road
    SL6 2QE Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Wichita Shoppenhangers Road
    SL6 2QE Maidenhead
    Berkshire
    British19699310001
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    Administrateur
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    British37378570013
    PEDERSEN, Alan Nicholson Val
    29 Queen Street
    HP20 1LU Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    29 Queen Street
    HP20 1LU Aylesbury
    Buckinghamshire
    British22165640001
    ROBERTSON-SMITH, Michael John
    42 Mansell Street
    CV37 6NR Stratford Upon Avon
    Administrateur
    42 Mansell Street
    CV37 6NR Stratford Upon Avon
    United KingdomBritish85369940001
    SHEPHERD, David Nigel
    1 Brookside
    Woodford Halse
    NN11 3RU Daventry
    Northamptonshire
    Administrateur
    1 Brookside
    Woodford Halse
    NN11 3RU Daventry
    Northamptonshire
    British40976920001
    SOUTHAM, Ivor Kenneth
    39 Galsworthy Place
    HP19 3LQ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    39 Galsworthy Place
    HP19 3LQ Aylesbury
    Buckinghamshire
    British60815430001
    STERNE, Dermot Desmond
    24 North End Square
    MK18 1NX Buckingham
    Administrateur
    24 North End Square
    MK18 1NX Buckingham
    British45376070002
    TURNER, John Patrick
    3 High Beeches
    Frimley
    GU16 8UG Camberley
    Surrey
    Administrateur
    3 High Beeches
    Frimley
    GU16 8UG Camberley
    Surrey
    GbBritish53281480001
    WANSBROUGH, David George Rawdon
    Acorns
    Thursley
    GU8 6NJ Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Acorns
    Thursley
    GU8 6NJ Godalming
    Surrey
    British47849990001
    WARD, Malcolm Stuart
    Blakes Cottage Horn Street
    Winslow
    MK18 3AP Buckingham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Blakes Cottage Horn Street
    Winslow
    MK18 3AP Buckingham
    Buckinghamshire
    British35014310003
    WEBSTER, Stephen Paul
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Administrateur
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    United KingdomBritish40201730005
    WHITE, Mark Jonathan
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    Administrateur
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    EnglandBritish82978250002

    MALAIKA4 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 31 mars 1993
    Livré le 08 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Eci Developments
    Transactions
    • 08 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 févr. 1991
    Livré le 01 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for itself and the holders of the loan notes (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge, all the company's present and future undertaking and assets, whatsoever and wherever including its uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Trust Company of Canada Limited
    Transactions
    • 01 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 07 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 04 déc. 1989
    Livré le 14 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    • 08 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 nov. 1989
    Livré le 29 nov. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 nov. 1989Enregistrement d'une charge
    • 08 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0