RMAC 1999-NS2

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRMAC 1999-NS2
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité illimitée
    Numéro de société 02195220
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RMAC 1999-NS2 ?

    • (6523) /

    Où se situe RMAC 1999-NS2 ?

    Adresse du siège social
    5 Arlington Square
    Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RMAC 1999-NS2 ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RMAC 1999-NS2 LIMITED24 sept. 200924 sept. 2009
    RMAC 1999-NS2 PLC19 mai 199919 mai 1999
    THE MORTGAGE ACCEPTANCE CORPORATION LIMITED26 janv. 198826 janv. 1988
    PROBEFINAL LIMITED17 nov. 198717 nov. 1987

    Quels sont les derniers comptes de RMAC 1999-NS2 ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour RMAC 1999-NS2 ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Cessation de la nomination de Jefrey Lundgren en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Résolutions

    Resolutions
    14 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Certificat de réimmatriculation de société à responsabilité limitée à société de personnes à responsabilité illimitée

    1 pagesCERT3

    Re-enregistrement de l'assentiment

    1 pagesFOA-RR

    Réenregistrement des statuts

    13 pagesMAR

    Re-enregistrement d'une société à responsabilité limitée privée en société à responsabilité illimitée privée

    2 pagesRR05

    Cessation de la nomination de Eileen Mcmillan en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    1 pages403a

    Certificat de réimmatriculation de société anonyme à responsabilité limitée

    1 pagesCERT10

    Réenregistrement des statuts

    13 pagesMAR

    legacy

    1 pages53

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de réimmatriculation

    RES02

    legacy

    2 pages288a

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    auditors

    Résolution d'exemption de la nomination des commissaires aux comptes

    RES03

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    7 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages190

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    Qui sont les dirigeants de RMAC 1999-NS2 ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SIMPSON, Phillip Bertram
    16 Gatscombe Crescent
    Hanover Park
    SL5 7HA Ascot
    Secrétaire
    16 Gatscombe Crescent
    Hanover Park
    SL5 7HA Ascot
    BritishSolicitor54705580002
    BLIGHT, Godfrey
    Arlington Square
    Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    5
    Berkshire
    Administrateur
    Arlington Square
    Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    5
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector135102120001
    COX, Kenneth Geoffrey
    3 Spencer Park
    SW18 2SX London
    Secrétaire
    3 Spencer Park
    SW18 2SX London
    British45253390001
    EDMONDS, Karen Britt
    Badgers Barn
    Farthings Paddock
    BA7 7QA Alford
    Somerset
    Secrétaire
    Badgers Barn
    Farthings Paddock
    BA7 7QA Alford
    Somerset
    British42484650004
    HAMZEHPOUR, Tammy
    7816 Bush Lake Drive
    Bloomington
    Minnesota Mn 55438
    Usa
    Secrétaire
    7816 Bush Lake Drive
    Bloomington
    Minnesota Mn 55438
    Usa
    American64501790002
    ACHESON, William Brian
    Eastern Gate
    Brants Bridge
    RG12 9BZ Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    Eastern Gate
    Brants Bridge
    RG12 9BZ Bracknell
    Berkshire
    AmericanDirector100315920003
    APPEL, Robert Louis
    2 Sheridan Grange
    Broomhall Lane
    SL5 0BX Sunningdale
    Berkshire
    Administrateur
    2 Sheridan Grange
    Broomhall Lane
    SL5 0BX Sunningdale
    Berkshire
    AmericanDirector86709370001
    BEST, Simon Peter Francis
    The Hollies
    Peters Green
    LU2 9QW Luton
    Bedfordshire
    Administrateur
    The Hollies
    Peters Green
    LU2 9QW Luton
    Bedfordshire
    United KingdomAustralianMerchant Banker7869940001
    BRADLEY, Colin Walter
    Williamsgate
    The Street
    RG27 0PJ Eversley
    Hampshire
    Administrateur
    Williamsgate
    The Street
    RG27 0PJ Eversley
    Hampshire
    BritishDirector70001440003
    COX, Kenneth Geoffrey
    3 Spencer Park
    SW18 2SX London
    Administrateur
    3 Spencer Park
    SW18 2SX London
    United KingdomBritishMerchant Banker45253390001
    DUGGLEBY, Colin
    Red Cottages
    Pilcot Hill
    RG27 8SZ Dogmersfield
    Hampshire
    Administrateur
    Red Cottages
    Pilcot Hill
    RG27 8SZ Dogmersfield
    Hampshire
    BritishDirector69027230001
    FREEMAN, Timothy, Mr.
    94 Oak Hill Crescent
    IG8 9PQ Woodford Green
    Essex
    Administrateur
    94 Oak Hill Crescent
    IG8 9PQ Woodford Green
    Essex
    EnglandBritishDirector141863550001
    FREEMAN, Timothy
    8 Raymond Avenue
    South Woodford
    E18 2HG London
    Administrateur
    8 Raymond Avenue
    South Woodford
    E18 2HG London
    BritishBanker56917840001
    HIGGINS, Christopher James
    24 Ennismore Avenue
    GU1 1SR Guildford
    Surrey
    Administrateur
    24 Ennismore Avenue
    GU1 1SR Guildford
    Surrey
    BritishFinance Director115417740001
    HYNES, Stephen
    Oaklands The Rowans
    TW16 7QG Sunbury On Thames
    Middlesex
    Administrateur
    Oaklands The Rowans
    TW16 7QG Sunbury On Thames
    Middlesex
    BritishBanker55171110001
    LUNDGREN, Jefrey Andrew
    Arlington Square
    Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    5
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Arlington Square
    Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    5
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector130391340002
    MCMILLAN, Eileen
    Arlington Square
    Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    5
    Berkshire
    Administrateur
    Arlington Square
    Downshire Way
    RG12 1WA Bracknell
    5
    Berkshire
    BritishDirector118951850003
    MELLOR, Luke Bartholomew
    55 Albion Drive
    EC2N 4AE London
    Administrateur
    55 Albion Drive
    EC2N 4AE London
    BritishMerchant Banker48782560001
    NORDEEN, Christopher Jon
    9413 Brooke Drive
    Bethesda
    Maryland 20817 2109
    Usa
    Administrateur
    9413 Brooke Drive
    Bethesda
    Maryland 20817 2109
    Usa
    GermanDirector61535870005
    SEARLE, Barry Roy
    Eastern Gate
    Brants Bridge
    RG12 9BZ Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    Eastern Gate
    Brants Bridge
    RG12 9BZ Bracknell
    Berkshire
    BritishDirector70897720003

    RMAC 1999-NS2 a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A deed of charge and assignment (the "deed of charge")
    Créé le 21 sept. 1999
    Livré le 27 sept. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    (A) all moneys and liabilities whatsoever which from time to time become due, owing or payable by the issuer: (i)to the order of the trustee and/or any receiver under the deed of charge, the trust deed or the conditions at the times and in the manner provided therein; (ii)under or in respect of the notes; and (iii)to the trustee under the transaction documents, whether as principal or surety and whether or not directly with another. (B) all moneys and liabilities whatsoever which from time to time become due, owing or payable by the issuer to each of the other secured creditors in accordance respectively with each of the other documents (together the "secured amounts")
    Brèves mentions
    All right title interest and benefit present and future in, to and under the english mortgage loans and the english mortgages in the mortgage pool and all monies assured by or to become payable under the same and benefit of all covenants relating thereto - for full details see form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Chase Manhattan Trustees Limited (As Trustee for the Secured Creditors)
    Transactions
    • 27 sept. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0