RMAC 1999-NS2
Vue d'ensemble
Nom de la société | RMAC 1999-NS2 |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société privée à responsabilité illimitée |
Numéro de société | 02195220 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RMAC 1999-NS2 ?
Adresse du siège social | 5 Arlington Square Downshire Way RG12 1WA Bracknell Berkshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RMAC 1999-NS2 ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2008 |
Quels sont les derniers dépôts pour RMAC 1999-NS2 ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jefrey Lundgren en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 14 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Certificat de réimmatriculation de société à responsabilité limitée à société de personnes à responsabilité illimitée | 1 pages | CERT3 | ||||||||||
Re-enregistrement de l'assentiment | 1 pages | FOA-RR | ||||||||||
Réenregistrement des statuts | 13 pages | MAR | ||||||||||
Re-enregistrement d'une société à responsabilité limitée privée en société à responsabilité illimitée privée | 2 pages | RR05 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Eileen Mcmillan en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 403a | ||||||||||
Certificat de réimmatriculation de société anonyme à responsabilité limitée | 1 pages | CERT10 | ||||||||||
Réenregistrement des statuts | 13 pages | MAR | ||||||||||
legacy | 1 pages | 53 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2008 | 7 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288c | ||||||||||
legacy | 1 pages | 190 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288c | ||||||||||
legacy | 1 pages | 353 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 287 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de RMAC 1999-NS2 ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMPSON, Phillip Bertram | Secrétaire | 16 Gatscombe Crescent Hanover Park SL5 7HA Ascot | British | Solicitor | 54705580002 | |||||
BLIGHT, Godfrey | Administrateur | Arlington Square Downshire Way RG12 1WA Bracknell 5 Berkshire | United Kingdom | British | Director | 135102120001 | ||||
COX, Kenneth Geoffrey | Secrétaire | 3 Spencer Park SW18 2SX London | British | 45253390001 | ||||||
EDMONDS, Karen Britt | Secrétaire | Badgers Barn Farthings Paddock BA7 7QA Alford Somerset | British | 42484650004 | ||||||
HAMZEHPOUR, Tammy | Secrétaire | 7816 Bush Lake Drive Bloomington Minnesota Mn 55438 Usa | American | 64501790002 | ||||||
ACHESON, William Brian | Administrateur | Eastern Gate Brants Bridge RG12 9BZ Bracknell Berkshire | American | Director | 100315920003 | |||||
APPEL, Robert Louis | Administrateur | 2 Sheridan Grange Broomhall Lane SL5 0BX Sunningdale Berkshire | American | Director | 86709370001 | |||||
BEST, Simon Peter Francis | Administrateur | The Hollies Peters Green LU2 9QW Luton Bedfordshire | United Kingdom | Australian | Merchant Banker | 7869940001 | ||||
BRADLEY, Colin Walter | Administrateur | Williamsgate The Street RG27 0PJ Eversley Hampshire | British | Director | 70001440003 | |||||
COX, Kenneth Geoffrey | Administrateur | 3 Spencer Park SW18 2SX London | United Kingdom | British | Merchant Banker | 45253390001 | ||||
DUGGLEBY, Colin | Administrateur | Red Cottages Pilcot Hill RG27 8SZ Dogmersfield Hampshire | British | Director | 69027230001 | |||||
FREEMAN, Timothy, Mr. | Administrateur | 94 Oak Hill Crescent IG8 9PQ Woodford Green Essex | England | British | Director | 141863550001 | ||||
FREEMAN, Timothy | Administrateur | 8 Raymond Avenue South Woodford E18 2HG London | British | Banker | 56917840001 | |||||
HIGGINS, Christopher James | Administrateur | 24 Ennismore Avenue GU1 1SR Guildford Surrey | British | Finance Director | 115417740001 | |||||
HYNES, Stephen | Administrateur | Oaklands The Rowans TW16 7QG Sunbury On Thames Middlesex | British | Banker | 55171110001 | |||||
LUNDGREN, Jefrey Andrew | Administrateur | Arlington Square Downshire Way RG12 1WA Bracknell 5 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 130391340002 | ||||
MCMILLAN, Eileen | Administrateur | Arlington Square Downshire Way RG12 1WA Bracknell 5 Berkshire | British | Director | 118951850003 | |||||
MELLOR, Luke Bartholomew | Administrateur | 55 Albion Drive EC2N 4AE London | British | Merchant Banker | 48782560001 | |||||
NORDEEN, Christopher Jon | Administrateur | 9413 Brooke Drive Bethesda Maryland 20817 2109 Usa | German | Director | 61535870005 | |||||
SEARLE, Barry Roy | Administrateur | Eastern Gate Brants Bridge RG12 9BZ Bracknell Berkshire | British | Director | 70897720003 |
RMAC 1999-NS2 a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A deed of charge and assignment (the "deed of charge") | Créé le 21 sept. 1999 Livré le 27 sept. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti (A) all moneys and liabilities whatsoever which from time to time become due, owing or payable by the issuer: (i)to the order of the trustee and/or any receiver under the deed of charge, the trust deed or the conditions at the times and in the manner provided therein; (ii)under or in respect of the notes; and (iii)to the trustee under the transaction documents, whether as principal or surety and whether or not directly with another. (B) all moneys and liabilities whatsoever which from time to time become due, owing or payable by the issuer to each of the other secured creditors in accordance respectively with each of the other documents (together the "secured amounts") | |
Brèves mentions All right title interest and benefit present and future in, to and under the english mortgage loans and the english mortgages in the mortgage pool and all monies assured by or to become payable under the same and benefit of all covenants relating thereto - for full details see form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0