TYNE PIPE FABRICATORS LIMITED

TYNE PIPE FABRICATORS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTYNE PIPE FABRICATORS LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02196331
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TYNE PIPE FABRICATORS LIMITED ?

    • (1120) /

    Où se situe TYNE PIPE FABRICATORS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 St James' Gate
    Newcastle Upon Tyne
    NE99 1YQ Tyne And Wear
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TYNE PIPE FABRICATORS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AKER TYNE LIMITED30 avr. 199930 avr. 1999
    AKER MCNULTY LIMITED04 févr. 199704 févr. 1997
    MCNULTY OFFSHORE SERVICES LIMITED19 nov. 198719 nov. 1987

    Quels sont les derniers comptes de TYNE PIPE FABRICATORS LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2004
    Date d'échéance des prochains comptes31 oct. 2005
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2003

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour TYNE PIPE FABRICATORS LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au01 mai 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation15 mai 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TYNE PIPE FABRICATORS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour TYNE PIPE FABRICATORS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de Wb Company Secretaries Limited en tant que secrétaire le 21 avr. 2021

    2 pagesTM02

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Gunnar Jan Oma en tant que directeur le 10 sept. 2018

    1 pagesTM01

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    legacy

    1 pages652a

    legacy

    2 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2003

    12 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    7 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2002

    12 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2001

    13 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2000

    15 pagesAA

    legacy

    6 pages363a

    legacy

    2 pages244

    Qui sont les dirigeants de TYNE PIPE FABRICATORS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KEYWORTH, Stephen
    Farndale
    Hepscott
    NE61 6LQ Morpeth
    Northumberland
    Administrateur
    Farndale
    Hepscott
    NE61 6LQ Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritish110833960001
    COLLETT, Brian
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    Secrétaire
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    British32267100002
    MCNULTY, David Brian
    The Grange
    8 Westoe Village
    NE33 3DZ South Shields
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    The Grange
    8 Westoe Village
    NE33 3DZ South Shields
    Tyne & Wear
    British42050750001
    WB COMPANY SECRETARIES LIMITED
    1 St James Gate
    NE99 1YQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    1 St James Gate
    NE99 1YQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    37945630014
    CASSIE, David
    32 Westholme Avenue
    AB15 6AB Aberdeen
    Administrateur
    32 Westholme Avenue
    AB15 6AB Aberdeen
    ScotlandBritish50942380001
    GULAKER, Harald
    2 Coldstone Avenue
    Kingswells
    AB15 8TT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    2 Coldstone Avenue
    Kingswells
    AB15 8TT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Norwegian71640790001
    HANSEN, Egil
    Peter Aas Vei 30a
    Oslo 0667
    FOREIGN Norway
    Administrateur
    Peter Aas Vei 30a
    Oslo 0667
    FOREIGN Norway
    Norwegian49296090001
    KLEV, Jens Andreas
    Kvernveien 12
    FOREIGN Oslo 0383
    Norway
    Administrateur
    Kvernveien 12
    FOREIGN Oslo 0383
    Norway
    Norwegian90065440001
    MCNULTY, David Brian
    The Grange
    8 Westoe Village
    NE33 3DZ South Shields
    Tyne & Wear
    Administrateur
    The Grange
    8 Westoe Village
    NE33 3DZ South Shields
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish42050750001
    MCNULTY, Peter Mitchell
    The White House
    18 Westoe Village
    NE33 3EB South Shields
    Tyne & Wear
    Administrateur
    The White House
    18 Westoe Village
    NE33 3EB South Shields
    Tyne & Wear
    British33388950001
    OMA, Gunnar Jan
    10 Cornmoor Road
    Whickham
    NE16 4PU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    10 Cornmoor Road
    Whickham
    NE16 4PU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomNorwegian83630750001
    PETTERSON, Lasse
    8 Springdale Road
    Bieldside
    AB15 9FA Aberdeen
    Scotland
    Administrateur
    8 Springdale Road
    Bieldside
    AB15 9FA Aberdeen
    Scotland
    Norwegian53719030002
    ROLSTAD, Lars
    7 Earlspark Gardens
    Bieldside
    AB1 9AZ Aberdeen
    Administrateur
    7 Earlspark Gardens
    Bieldside
    AB1 9AZ Aberdeen
    Norwegian39614660002
    SMITH, Phillip John
    Minarloch
    Ballater Road
    AB34 5JE Aboyne
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Minarloch
    Ballater Road
    AB34 5JE Aboyne
    Aberdeenshire
    British82478380001
    WAAGE, Rolf Thomas
    Sjoarbakken 26
    Stord 5400
    Norway
    Administrateur
    Sjoarbakken 26
    Stord 5400
    Norway
    Norwegian68596080001

    TYNE PIPE FABRICATORS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over contract
    Créé le 16 nov. 1992
    Livré le 26 nov. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that benefit of an agreement dated 18/12/91 between the company and amerada hess limited.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 nov. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juil. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Agreement
    Créé le 22 sept. 1992
    Livré le 22 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the blanket indemnity
    Brèves mentions
    Its right title and interest to and in the credit balances on the security account and account no. 403229/41 at bank julius baer & co.
    Personnes ayant droit
    • London & Mercantile International Mercantile Limited
    Transactions
    • 22 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Agreement
    Créé le 12 mars 1992
    Livré le 27 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the blanket indemnity (as defined)
    Brèves mentions
    Its rights title and interest in the receivables and credit balance on the security account and on account no.403229/41 At bank julius baer & co limited.
    Personnes ayant droit
    • London & International Mercantile Limited
    Transactions
    • 27 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Agreement
    Créé le 31 janv. 1992
    Livré le 14 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the indemnity
    Brèves mentions
    All rights title and interest to and in the receivables and any credit balances on the security account and bank julius baer account from time to time.
    Personnes ayant droit
    • London & International Mercantile Limited
    Transactions
    • 14 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Agreement
    Créé le 30 août 1991
    Livré le 17 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the banklet indemnity
    Brèves mentions
    Its right, title and interest to and in the receivables and credit balance on the security account and account no. 403229/41 at bank julius baer & co. LTD, london from time to time.
    Personnes ayant droit
    • London and International Mercantile LTD
    Transactions
    • 17 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 23 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 12 déc. 1989
    Livré le 19 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    • 03 juil. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 29 mars 1988
    Livré le 12 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 12 avr. 1988Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0