CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED

CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02197301
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CHARTERHOUSE SECOND VENTURE FUND MANAGEMENT LIMITED02 mars 198802 mars 1988
    LEGIBUS 1064 LIMITED20 nov. 198720 nov. 1987

    Quels sont les derniers comptes de CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration de confirmation établie le 17 janv. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    12 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de Warwick Court Paternoster Square London EC4M 7DX à 26-28 Bedford Row London WC1R 4HE le 23 oct. 2019

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 16 oct. 2019

    LRESSP

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    13 pagesAA

    Cessation de la nomination de Lionel Lucien Marie Giacomotto en tant que directeur le 11 juin 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James Gordon Bonnyman en tant que directeur le 11 juin 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James Simon Edward Arnell en tant que directeur le 11 juin 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Duncan Aldred en tant que directeur le 11 juin 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 17 janv. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Lionel Lucien Marie Giacomotto le 13 nov. 2018

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 janv. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2017

    13 pagesAA

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2018 au 31 déc. 2017

    1 pagesAA01

    legacy

    4 pagesRP04CS01

    Déclaration de confirmation établie le 17 janv. 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01
    Annotations
    DateAnnotation
    14 févr. 2017Clarification A SECOND FILED CS01 (PERSON WITH SIGNIFICANT CONTROL) WAS REGISTERED ON 14/02/2017

    Comptes annuels établis au 31 mars 2016

    14 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Nigel Burrow le 14 déc. 2016

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 janv. 2016

    État du capital au 19 janv. 2016

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    12 pagesAA

    Cessation de la nomination de Stuart Douglas Simpson en tant que directeur le 31 oct. 2015

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WATSON, Irina
    Bedford Row
    WC1R 4HE London
    26-28
    Secrétaire
    Bedford Row
    WC1R 4HE London
    26-28
    174677240001
    BURROW, Paul Nigel
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    Warwick Court
    United Kingdom
    Administrateur
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    Warwick Court
    United Kingdom
    EnglandBritish183952300002
    PATRICK, Thomas Spencer
    Bedford Row
    WC1R 4HE London
    26-28
    Administrateur
    Bedford Row
    WC1R 4HE London
    26-28
    United KingdomBritish88140270003
    DAS, Biswajit
    35 Lullington Garth
    N12 7LT London
    Secrétaire
    35 Lullington Garth
    N12 7LT London
    British32730500001
    GERMAN, Leslie Francis
    7 Chapel Lane
    Hempstead
    ME7 3TD Gillingham
    Kent
    Secrétaire
    7 Chapel Lane
    Hempstead
    ME7 3TD Gillingham
    Kent
    British3482110001
    LAW, Linda May
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    Secrétaire
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    English61157950002
    ALDRED, Duncan
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    Administrateur
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    EnglandBritish151584290001
    ARBUTHNOTT, Geoffrey James
    Lower Gustard Wood
    Wheathampstead
    AL4 8RX St Albans
    Lamer Hill
    Hertfordshire
    Administrateur
    Lower Gustard Wood
    Wheathampstead
    AL4 8RX St Albans
    Lamer Hill
    Hertfordshire
    United KingdomBritish66364270001
    ARNELL, James Simon Edward
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    Warwick Court
    United Kingdom
    Administrateur
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    Warwick Court
    United Kingdom
    EnglandBritish84362710004
    ARNELL, James Simon Edward
    Bounty Cottage
    The Street
    BN6 9DJ Albourne
    West Sussex
    Administrateur
    Bounty Cottage
    The Street
    BN6 9DJ Albourne
    West Sussex
    British84362710002
    BENNINGTON, William James
    37 Cheyne Court
    Flood Street
    SW3 5TR London
    Administrateur
    37 Cheyne Court
    Flood Street
    SW3 5TR London
    American42582130002
    BONNYMAN, James Gordon
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    Administrateur
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    EnglandBritish1250620002
    BRAKELL, John Russell
    19 Willows Path
    KT18 7TD Epsom
    Surrey
    Administrateur
    19 Willows Path
    KT18 7TD Epsom
    Surrey
    British33183840002
    COX, Edward George
    Sopwell Lodge
    15 Milehouse Lane
    AL1 1TH St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Sopwell Lodge
    15 Milehouse Lane
    AL1 1TH St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish23797950001
    DOCKERAY, William Bruce Denne
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    Administrateur
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    EnglandBritish66516980001
    DUNCAN, David Richard Louis
    12 Lansdowne Crescent
    W11 2NJ London
    Administrateur
    12 Lansdowne Crescent
    W11 2NJ London
    British2894030001
    GIACOMOTTO, Lionel Lucien Marie
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    Administrateur
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    United KingdomFrench65194340002
    GREENHALGH, Jeremy Edward
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    Administrateur
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    EnglandBritish176295030001
    GREENHALGH, Jeremy Edward
    4 West Side Common
    Wimbledon
    SW19 4TN London
    West Lodge
    Administrateur
    4 West Side Common
    Wimbledon
    SW19 4TN London
    West Lodge
    EnglandBritish128513820001
    JANNEY III, Stuart
    135 East Baltimore Street
    Baltimore
    Maryland 21202
    Usa
    Administrateur
    135 East Baltimore Street
    Baltimore
    Maryland 21202
    Usa
    American34498550001
    MAY, Anthony Roger
    Danefield Broom Park
    Langton Green
    TN3 0RF Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    Danefield Broom Park
    Langton Green
    TN3 0RF Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish19247140002
    NICHOLLS, Jill Nicola
    97 Noel Road
    N1 8HD London
    Administrateur
    97 Noel Road
    N1 8HD London
    British8485240002
    OFFORD, Malcolm Ian
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    Administrateur
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    United KingdomBritish58718940003
    PILGRIM, Roger Granville
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    Administrateur
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    EnglandBritish7357660004
    PLANT, Thomas Roland
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    Administrateur
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    EnglandBritish37560170003
    PLANT, Thomas Roland
    Marley Lodge
    Marley Heights
    GU27 3LU Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    Marley Lodge
    Marley Heights
    GU27 3LU Haslemere
    Surrey
    EnglandBritish37560170003
    SHELDON, Ronald Frank
    8 Oakland Avenue
    BR4 9LE West Wickham
    Kent
    Administrateur
    8 Oakland Avenue
    BR4 9LE West Wickham
    Kent
    British33770320002
    SIMPSON, Stuart Douglas
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    Administrateur
    Warwick Court
    Paternoster Square
    EC4M 7DX London
    United KingdomBritish99057720002
    SIMPSON, Stuart Douglas
    2 Wadham Gardens
    NW3 3DP London
    Administrateur
    2 Wadham Gardens
    NW3 3DP London
    EnglandBritish99057720001
    TYNE, William John
    4 St Albans Grove
    W8 5PN London
    Administrateur
    4 St Albans Grove
    W8 5PN London
    United KingdomBritish7771150001
    WALKER, John, Dr
    Fairlawn Christchurch Road
    GU25 4PJ Wentworth
    Surrey
    Administrateur
    Fairlawn Christchurch Road
    GU25 4PJ Wentworth
    Surrey
    British49739170001
    WHALLEY, Anthony
    322 Cromwell Tower
    Barbican
    EC2Y 8NB London
    Administrateur
    322 Cromwell Tower
    Barbican
    EC2Y 8NB London
    British1979060002

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    17 janv. 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 27 nov. 2002
    Livré le 04 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    CHARTERHOUSE GENERAL PARTNERS (VII) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 oct. 2019Commencement of winding up
    14 mars 2021Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Paul Robert Appleton
    1st Floor 26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London
    practitioner
    1st Floor 26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0