MARCHWOOD MOTORWAYS (SERVICES) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MARCHWOOD MOTORWAYS (SERVICES) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02201331 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MARCHWOOD MOTORWAYS (SERVICES) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 3rd Floor 41-51 Grey Street NE1 6EE Newcastle Upon Tyne Tyne And Wear |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MARCHWOOD MOTORWAYS (SERVICES) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 29 juin 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour MARCHWOOD MOTORWAYS (SERVICES) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 4 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 29 juin 2019 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 févr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Elodie Brian le 05 juin 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Elodie Brian en tant qu'administrateur le 05 juin 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 avr. 2019 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018 | 6 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Patrick Butcher en tant que directeur le 30 nov. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Richard Lee-Kong en tant qu'administrateur le 01 mai 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Edward Wills en tant que directeur le 17 févr. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 01 juil. 2017 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 juin 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Benjamin Matthew Murray le 23 févr. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 02 juil. 2016 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 oct. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Finance Director Benjamin Matthew Murray en tant qu'administrateur le 23 févr. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Patrick Butcher en tant qu'administrateur le 14 mars 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nicholas John Dillon Woods en tant que directeur le 12 févr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 27 juin 2015 | 5 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Keith Down en tant que directeur le 06 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires | 9 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 juin 2014 | 5 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de MARCHWOOD MOTORWAYS (SERVICES) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERGUSON, Carolyn | Secrétaire | 41-51 Grey Street NE1 6EE Newcastle Upon Tyne 3rd Floor | British | 140547110010 | ||||||
| BRIAN, Elodie Marie Francoise | Administrateur | 4 Matthew Parker Street Westminster SW1H 9NP London The Go-Ahead Group Plc United Kingdom | United Kingdom | French | 188712110002 | |||||
| BROWN, David Allen | Administrateur | 4 Matthew Parker Street SW1H 9NP London The Go-Ahead Group Plc United Kingdom | United Kingdom | British | 117080300001 | |||||
| HAMILTON, Steven John | Administrateur | Towngate House 2-8 Parkstone Road BH15 2PR Poole Go South Coast Dorset | United Kingdom | British | 123896660002 | |||||
| LEE-KONG, David Richard | Administrateur | Towngate House 2-8 Parkstone Road BH15 2PR Poole Go South Coast Dorset United Kingdom | United Kingdom | British | 246869500001 | |||||
| MURRAY, Benjamin Matthew | Administrateur | Towngate House 2-8 Parkstone Road BH15 2PR Poole Go South Coast Dorset | England | American | 207964220001 | |||||
| WICKHAM, Andrew Rodney | Administrateur | Parkstone Road BH15 2PR Poole Go South Coast Towngate House 2-8 Dorset United Kingdom | United Kingdom | British | 76754660002 | |||||
| WELBOURN, Susan Ethel | Secrétaire | The Beeches Lopperwood Calmore SO40 2RP Southampton Hants | British | 12692300001 | ||||||
| BUTCHER, Ian Philip | Administrateur | Church Farm High Row Caldwell DL11 7QQ Richmond North Yorkshire | British | 14256800003 | ||||||
| BUTCHER, Simon Patrick | Administrateur | 4 Matthew Parker Street Westminster SW1H 9NP London The Go-Ahead Group Plc United Kingdom | England | British | 164559000001 | |||||
| CARTER, Alex Paul | Administrateur | Towngate House 2-8 Parkstone Road BH15 2PR Poole Go South Coast Dorset | England | British | 92574750002 | |||||
| DOLPHIN, Matthew Stjohn | Administrateur | Towngate House 2-8 Parkstone Road BH15 2PR Poole Go South Coast Dorset | United Kingdom | British | 112253570003 | |||||
| DOWN, Keith | Administrateur | 4 Matthew Parker Street SW1H 9NP London The Go-Ahead Group Plc United Kingdom | United Kingdom | British | 158774520002 | |||||
| LUDEMAN, Keith Lawrence | Administrateur | 6th Floor 1 Warwick Row SW1E 5ER London The Go Ahead Group Plc | United Kingdom | British | 114461470001 | |||||
| OSBORNE, Dennis Peter | Administrateur | Rockram House New Inn Road Bartley Cadnam SO40 2LR Southampton Hampshire | England | British | 17082790002 | |||||
| OSBORNE, Ian Charles William | Administrateur | 12 Greenfields Avenue Totton SO40 3LS Southampton Hampshire | British | 12692320001 | ||||||
| PARSONS, Geoffrey Michael | Administrateur | 19 Harper Road SP2 7HG Salisbury Wiltshire | British | 77303940003 | ||||||
| SWIFT, Nicholas | Administrateur | 6th Floor 1 Warwick Row SW1E 5ER London The Go-Ahead Group Plc | United Kingdom | British | 90315200001 | |||||
| WELBOURN, Susan Ethel | Administrateur | The Beeches Lopperwood Calmore SO40 2RP Southampton Hants | England | British | 12692300001 | |||||
| WICKHAM, Andrew Rodney | Administrateur | Towngate House 2 - 8 Parkstone Road BH15 2PR Poole Go South Coast Dorset | United Kingdom | British | 76754660002 | |||||
| WILLS, Edward John Andrew | Administrateur | Towngate House 2-8 Parkstone Road BH15 2PR Poole Go South Coast Dorset United Kingdom | United Kingdom | British | 181954430001 | |||||
| WOODS, Nicholas John Dillon | Administrateur | Towngate House 2-8 Parkstone Road BH15 2PR Poole Go South Coast Dorset United Kingdom | United Kingdom | British | 171089700001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MARCHWOOD MOTORWAYS (SERVICES) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solent Blue Line Limited | 06 avr. 2016 | 41 - 51 Grey Street NE1 6EE Newcastle Upon Tyne 3rd Floor United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
MARCHWOOD MOTORWAYS (SERVICES) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Créé le 03 oct. 1997 Livré le 16 oct. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0