EXPRESS PRINTERS MANCHESTER LIMITED

EXPRESS PRINTERS MANCHESTER LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEXPRESS PRINTERS MANCHESTER LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02203666
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EXPRESS PRINTERS MANCHESTER LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe EXPRESS PRINTERS MANCHESTER LIMITED ?

    Adresse du siège social
    One Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AP London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EXPRESS PRINTERS MANCHESTER LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BROUGHTON PRINTERS LIMITED19 févr. 198819 févr. 1988
    TGP 32 LIMITED08 déc. 198708 déc. 1987

    Quels sont les derniers comptes de EXPRESS PRINTERS MANCHESTER LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au27 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour EXPRESS PRINTERS MANCHESTER LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 27 déc. 2020

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 déc. 2019

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 déc. 2018

    4 pagesAA

    Nomination de Mr James Joseph Mullen en tant qu'administrateur le 16 août 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Simon Richard Fox en tant que directeur le 16 août 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Mr Simon Jeremy Ian Fuller en tant qu'administrateur le 01 mars 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Vijay Lakhman Vaghela en tant que directeur le 01 mars 2019

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur T M Directors Limited le 04 mai 2018

    1 pagesCH02

    Modification des coordonnées du secrétaire T M Secretaries Limited le 04 mai 2018

    1 pagesCH04

    Cessation de Richard Clive Desmond en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 févr. 2018

    1 pagesPSC07

    Nomination de T M Directors Limited en tant qu'administrateur le 28 févr. 2018

    2 pagesAP02

    Nomination de Mr Simon Richard Fox en tant qu'administrateur le 28 févr. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Vijay Lakhman Vaghela en tant qu'administrateur le 28 févr. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Martin Stephen Ellice en tant que directeur le 28 févr. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Richard Clive Desmond en tant que directeur le 28 févr. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robert Sanderson en tant que directeur le 28 févr. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de T M Secretaries Limited en tant que secrétaire le 28 févr. 2018

    2 pagesAP04

    Qui sont les dirigeants de EXPRESS PRINTERS MANCHESTER LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    REACH SECRETARIES LIMITED
    Canary Wharf
    E14 5AP London
    One Canada Square
    United Kingdom
    Secrétaire
    Canary Wharf
    E14 5AP London
    One Canada Square
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement4333688
    82853180002
    FULLER, Simon Jeremy Ian
    Canary Wharf
    E14 5AP London
    One Canada Square
    United Kingdom
    Administrateur
    Canary Wharf
    E14 5AP London
    One Canada Square
    United Kingdom
    EnglandBritish181763320002
    MULLEN, James Joseph
    Canary Wharf
    E14 5AP London
    One Canada Square
    United Kingdom
    Administrateur
    Canary Wharf
    E14 5AP London
    One Canada Square
    United Kingdom
    EnglandScottish91567460002
    REACH DIRECTORS LIMITED
    Canary Wharf
    E14 5AP London
    One Canada Square
    United Kingdom
    Administrateur
    Canary Wharf
    E14 5AP London
    One Canada Square
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement4331538
    82853130002
    GILL, Maninder Singh
    Sisu
    Blagdens Lane Southgate
    N14 6DG London
    Secrétaire
    Sisu
    Blagdens Lane Southgate
    N14 6DG London
    Singaporean73020040002
    HILL, Robert Christopher
    9 Kingsley Close
    Sandal
    WF2 7EB Wakefield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    9 Kingsley Close
    Sandal
    WF2 7EB Wakefield
    West Yorkshire
    British72684940002
    SANDERSON, Robert
    Canary Wharf
    E14 5AP London
    One Canada Square
    United Kingdom
    Secrétaire
    Canary Wharf
    E14 5AP London
    One Canada Square
    United Kingdom
    British106663370001
    YEOMANS, Graham Arthur
    13 Beagle Ridge Drive
    Acomb
    YO2 3JH York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    13 Beagle Ridge Drive
    Acomb
    YO2 3JH York
    North Yorkshire
    British602760001
    CROSSWALL NOMINEES LIMITED
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Ludgate House
    Secrétaire
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Ludgate House
    992770004
    BRADBURY, Harold Kenneth
    158 Fleetwood Road South
    FY5 5NR Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Administrateur
    158 Fleetwood Road South
    FY5 5NR Thornton Cleveleys
    Lancashire
    British9421950001
    DESMOND, Richard Clive
    Canary Wharf
    E14 5AP London
    One Canada Square
    United Kingdom
    Administrateur
    Canary Wharf
    E14 5AP London
    One Canada Square
    United Kingdom
    EnglandBritish6577030003
    ELLICE, Martin Stephen
    The Northern & Shell Building
    Number 10 Lower Thames Street
    EC3R 6EN London
    Administrateur
    The Northern & Shell Building
    Number 10 Lower Thames Street
    EC3R 6EN London
    United KingdomBritish153564420001
    ELLICE, Martin Stephen
    Canary Wharf
    E14 5AP London
    One Canada Square
    United Kingdom
    Administrateur
    Canary Wharf
    E14 5AP London
    One Canada Square
    United Kingdom
    United KingdomBritish153564420001
    FOX, Simon Richard
    Canary Wharf
    E14 5AP London
    One Canada Square
    United Kingdom
    Administrateur
    Canary Wharf
    E14 5AP London
    One Canada Square
    United Kingdom
    United KingdomBritish58101280002
    GRAY, Donald Sinclair
    The Old Malt House
    The Street
    ME14 3DR Boxley
    Kent
    Administrateur
    The Old Malt House
    The Street
    ME14 3DR Boxley
    Kent
    British81115260001
    GRAYSTON, John Francis
    18 Crimple Meadows
    Pannal
    HG3 1EN Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    18 Crimple Meadows
    Pannal
    HG3 1EN Harrogate
    North Yorkshire
    British9421970001
    GRIEVE, John David
    141 Leeds Road
    HG2 8EZ Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    141 Leeds Road
    HG2 8EZ Harrogate
    North Yorkshire
    British602820001
    KENDALL, Charles Stephen
    10 Margate Road
    FY8 3EG St Annes
    Lancashire
    Administrateur
    10 Margate Road
    FY8 3EG St Annes
    Lancashire
    British47462160001
    MACKEL, David
    35 Gleneagles Drive
    Fulwood
    PR2 7ET Preston
    Lancashire
    Administrateur
    35 Gleneagles Drive
    Fulwood
    PR2 7ET Preston
    Lancashire
    British13275490001
    PEMBERTON, Peter Rodney
    Bushells Cottage Mill Lane
    Goosnargh
    PR3 2BJ Preston
    Lancashire
    Administrateur
    Bushells Cottage Mill Lane
    Goosnargh
    PR3 2BJ Preston
    Lancashire
    British26973950001
    SANDERSON, Robert
    Canary Wharf
    E14 5AP London
    One Canada Square
    United Kingdom
    Administrateur
    Canary Wharf
    E14 5AP London
    One Canada Square
    United Kingdom
    United KingdomBritish106663370001
    SHAW, Ronald Anthony
    36 Grizedale Road
    FY4 4TL Blackpool
    Lancashire
    Administrateur
    36 Grizedale Road
    FY4 4TL Blackpool
    Lancashire
    British9714710001
    TOULMIN, George Michael
    The West Wing
    Thorp Arch Hall
    LS23 7AW Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    The West Wing
    Thorp Arch Hall
    LS23 7AW Wetherby
    West Yorkshire
    British9253330001
    TREADGOLD, Philip Leslie
    The Chase
    Upper Rickeston
    SA62 3DJ Haverfordwest
    Dyfed
    Administrateur
    The Chase
    Upper Rickeston
    SA62 3DJ Haverfordwest
    Dyfed
    British47440810001
    VAGHELA, Vijay Kumar Lakhman Meghji
    Canary Wharf
    E14 5AP London
    One Canada Square
    United Kingdom
    Administrateur
    Canary Wharf
    E14 5AP London
    One Canada Square
    United Kingdom
    EnglandBritish60412210002
    WEST, William Michael
    Stanley Cottage 160 Cornwall Avenue
    FY2 9QR Blackpool
    Lancashire
    Administrateur
    Stanley Cottage 160 Cornwall Avenue
    FY2 9QR Blackpool
    Lancashire
    United KingdomBritish9262030001
    CROSSWALL NOMINEES LIMITED
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Ludgate House
    Administrateur
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Ludgate House
    992770004
    UNM INVESTMENTS LIMITED
    Ludgate House
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Administrateur
    Ludgate House
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    48157320003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EXPRESS PRINTERS MANCHESTER LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Richard Clive Desmond
    10 Lower Thames Street
    EC3R 6EN London
    The Northern & Shell Building
    England
    06 avr. 2016
    10 Lower Thames Street
    EC3R 6EN London
    The Northern & Shell Building
    England
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Broughton Printers Limited
    10 Lower Thames Street
    EC3R 6EN London
    The Northern & Shell Building
    England
    06 avr. 2016
    10 Lower Thames Street
    EC3R 6EN London
    The Northern & Shell Building
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEnglish Law
    Lieu d'enregistrementRegistrar Of Companies (England & Wales)
    Numéro d'enregistrement01091137
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    EXPRESS PRINTERS MANCHESTER LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 12 sept. 2005
    Livré le 26 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch as Trustee for Each of the Secured Parties (Thetrustee)
    Transactions
    • 26 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 nov. 2000
    Livré le 06 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations due or to become due from any obligor (as defined) to the chargee as trustee for the secured parties (as defined) (the "trustee") under the finance documents (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch
    Transactions
    • 06 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0