DOCKLANDS TRANSIT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDOCKLANDS TRANSIT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02212346
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DOCKLANDS TRANSIT LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe DOCKLANDS TRANSIT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Stagecoach Services Ltd
    Daw Bank
    SK3 0DU Stockport
    Cheshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DOCKLANDS TRANSIT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TEIGNIBUS LIMITED20 janv. 198820 janv. 1988

    Quels sont les derniers comptes de DOCKLANDS TRANSIT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour DOCKLANDS TRANSIT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 janv. 2012

    État du capital au 05 janv. 2012

    • Capital: GBP 2
    SH01

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2011

    4 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    7 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2010

    4 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Michael John Vaux le 10 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2009

    4 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Leslie Brian Warneford le 01 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Colin Brown le 15 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Michael John Vaux le 07 oct. 2009

    1 pagesCH03

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 30 avr. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 30 avr. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de DOCKLANDS TRANSIT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    British137383880001
    BROWN, Colin
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Administrateur
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish85970020003
    WARNEFORD, Leslie Brian
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Administrateur
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish49771140004
    BATH, Stephen John
    8 Elmers Way
    Bransgore
    BH23 8HB Christchurch
    Dorset
    Secrétaire
    8 Elmers Way
    Bransgore
    BH23 8HB Christchurch
    Dorset
    British2877760001
    BEST, Michael John
    Harley Thorn Higher Broad Oak Road
    West Hill
    EX11 1XJ Ottery St Mary
    Devon
    Secrétaire
    Harley Thorn Higher Broad Oak Road
    West Hill
    EX11 1XJ Ottery St Mary
    Devon
    British36339320001
    MAYHEW, Graham James
    Langstone House Toadpit Lane
    West Hill
    EX11 1TR Ottery St Mary
    Devon
    Secrétaire
    Langstone House Toadpit Lane
    West Hill
    EX11 1TR Ottery St Mary
    Devon
    British2990690001
    STAITE, John Frederick
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    Secrétaire
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    British45931770001
    STOGGELL, Martin Herbert
    119 Blackborough Road
    RH2 7DA Reigate
    Surrey
    Secrétaire
    119 Blackborough Road
    RH2 7DA Reigate
    Surrey
    British27504200001
    STRICKLAND, Annabelle June
    22 Cherry Tree Close
    EX4 5AT Exeter
    Devon
    Secrétaire
    22 Cherry Tree Close
    EX4 5AT Exeter
    Devon
    British32648300001
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Secrétaire
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002
    WILDMAN, Lara Joanne
    17 Catalina Close
    Dunkeswell
    EX14 0QD Honiton
    Devon
    Secrétaire
    17 Catalina Close
    Dunkeswell
    EX14 0QD Honiton
    Devon
    British45772780001
    ARNOLD, Barry Edward
    107 Beechwood Avenue
    Melbourn
    SG8 6BW Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    107 Beechwood Avenue
    Melbourn
    SG8 6BW Royston
    Hertfordshire
    British8614900001
    BEST, Michael John
    Harley Thorn Higher Broad Oak Road
    West Hill
    EX11 1XJ Ottery St Mary
    Devon
    Administrateur
    Harley Thorn Higher Broad Oak Road
    West Hill
    EX11 1XJ Ottery St Mary
    Devon
    British36339320001
    BLUNDRED, Harold Davies
    Ladram House
    Behind Hayes
    EX9 7JQ Otterton
    Devon
    Administrateur
    Ladram House
    Behind Hayes
    EX9 7JQ Otterton
    Devon
    British2990700001
    BOWKER, Roger William
    43 Leigh Drive
    Elsenham
    CM22 6BY Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    43 Leigh Drive
    Elsenham
    CM22 6BY Bishops Stortford
    Hertfordshire
    EnglandBritish8614910005
    COCHRANE, Keith Robertson
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    Administrateur
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    British47574960002
    COX, Anthony Geoffrey
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    British70180950001
    COX, Brian John
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    Administrateur
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    EnglandBritish1436830002
    DUFF, Peter
    83 Gainsborough Drive
    Lawford Dale Estate
    CO11 2LF Lawford, Manning Tree
    Essex
    Administrateur
    83 Gainsborough Drive
    Lawford Dale Estate
    CO11 2LF Lawford, Manning Tree
    Essex
    British27504190002
    FRANCIS, Tony Fitzalbert
    1 Ballard Chase
    OX14 1XQ Abingdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    1 Ballard Chase
    OX14 1XQ Abingdon
    Oxfordshire
    British32968160001
    GRIFFITHS, Martin Andrew
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Administrateur
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    ScotlandBritish61722690002
    HINKLEY, William Barry
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    Administrateur
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    EnglandBritish2268190002
    JEFFERY, Patricia Janet
    Millburn House
    8 Five Acres
    OX5 2RP Murcott
    Oxfordshire
    Administrateur
    Millburn House
    8 Five Acres
    OX5 2RP Murcott
    Oxfordshire
    British2990710006
    JEFFERY, Paul Kenneth
    Millburn House 8 Five Acres
    Murcott
    OX5 2RP Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    Millburn House 8 Five Acres
    Murcott
    OX5 2RP Oxford
    Oxfordshire
    British52000820001
    MACDONALD, Russell Wayne
    Winsham 8 Barton Close
    EX3 0PE Exton
    Devon
    Administrateur
    Winsham 8 Barton Close
    EX3 0PE Exton
    Devon
    British77122430001
    MAYHEW, Graham James
    Langstone House Toadpit Lane
    West Hill
    EX11 1TR Ottery St Mary
    Devon
    Administrateur
    Langstone House Toadpit Lane
    West Hill
    EX11 1TR Ottery St Mary
    Devon
    British2990690001
    MORGAN, Gregory Joseph
    61 Hermitage Road
    Mannamead
    PL3 4RX Plymouth
    Devon
    Administrateur
    61 Hermitage Road
    Mannamead
    PL3 4RX Plymouth
    Devon
    British60817260001
    SOUTER, Brian
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    Administrateur
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    British1436810001
    STAITE, John Frederick
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    Administrateur
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    United KingdomBritish45931770001
    STOGGELL, Martin Herbert
    119 Blackborough Road
    RH2 7DA Reigate
    Surrey
    Administrateur
    119 Blackborough Road
    RH2 7DA Reigate
    Surrey
    British27504200001
    STURTRIDGE, Gerald Arthur
    The Lugger 2 Globe Ley
    Globefield Topsham
    EX3 0DL Exeter
    Devon
    Administrateur
    The Lugger 2 Globe Ley
    Globefield Topsham
    EX3 0DL Exeter
    Devon
    United KingdomBritish105163380001
    WEBB, Clifford
    24 Oakfield Ridge
    EX17 2EG Crediton
    Devon
    Administrateur
    24 Oakfield Ridge
    EX17 2EG Crediton
    Devon
    British2990720001

    DOCKLANDS TRANSIT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 08 août 1996
    Livré le 14 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 19 févr. 1996
    Livré le 06 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Harold Davies Blundred
    Transactions
    • 06 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 18 janv. 1991
    Livré le 25 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Nat West Investment Bank Limited
    Transactions
    • 25 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 25 juin 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 19 mai 1989
    Livré le 26 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 25 juin 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0