ASTONICS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ASTONICS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02227900 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ASTONICS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Deloitte Llp 1 City Square LS1 2AL Leeds |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ASTONICS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour ASTONICS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 10 pages | LIQ13 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Rsm Uk Central Square, Fifth Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL | 2 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Rsm Central Square 5th Floor, 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL United Kingdom à Rsm Uk Central Square, Fifth Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Ges Silverstone Drive Gallagher Business Park Coventry CV6 6PA England à Deloitte Llp 1 City Square Leeds LS1 2AL le 23 janv. 2020 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 6 pages | LIQ01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Rsm Central Square 5th Floor, 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jason Popp en tant que directeur le 20 sept. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Michael Stewart en tant que secrétaire le 09 janv. 2019 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Paul Mckenna Silverstone Drive Gallagher Business Park Coventry CV6 6PA à Ges Silverstone Drive Gallagher Business Park Coventry CV6 6PA le 09 janv. 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Mr Jason Popp en tant qu'administrateur le 09 janv. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nicholas John Marshall en tant que directeur le 09 janv. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Mckenna en tant que secrétaire le 09 janv. 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de ASTONICS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEWART, Michael | Secrétaire | 1 City Square LS1 2AL Leeds Deloitte Llp | 254071510001 | |||||||
| INGERSOLL, Ellen Marie | Administrateur | 1 City Square LS1 2AL Leeds Deloitte Llp | United States | American | 118864140001 | |||||
| MOSTER, Steven | Administrateur | 1 City Square LS1 2AL Leeds Deloitte Llp | United States | American | 193607710001 | |||||
| DAY, Christopher Alexander Coryton | Secrétaire | 48 Whitley Court Road Quinton B32 1EY Birmingham West Midlands | British | 92047820001 | ||||||
| FARRELL, Sheila Margaret | Secrétaire | 42a Redbourne Avenue Finchley N3 2BS London | British | 57133980001 | ||||||
| FROST, Helen Margaret | Secrétaire | 35 Carlton House Goral Mead WD3 1BP Rickmansworth Hertfordshire | British | 36222730001 | ||||||
| GIBBS, Carol Anne | Secrétaire | Blacksmiths Cottage The Row Lane End HP14 3JZ High Wycombe Buckinghamshire | British | 22041330004 | ||||||
| GORDON, Neil Arthur | Secrétaire | Stable Cottage, Burrows Lea Hook Lane, Shere GU5 9QQ Guildford Surrey | British | 73989530001 | ||||||
| JACKSON, Jacqueline | Secrétaire | 35 The High Street CM5 9EA Ongar Essex | British | 22041310002 | ||||||
| MAKANJI, Ashok | Secrétaire | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry C/O Paul Mckenna England | 191996520001 | |||||||
| MAKANJI, Ashok | Secrétaire | Unit 100 Centennial Avenue WD6 3SA Elstree Hertfordshire | British | 120367360001 | ||||||
| MCKENNA, Paul | Secrétaire | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry C/O Paul Mckenna England | 193458250001 | |||||||
| PATEL, Daxshaben | Secrétaire | 2 Millers Court Vicars Bridge Close HA0 1XG Alperton Middlesex | British | 96045520001 | ||||||
| WAKELEY, David Peacefull | Secrétaire | 166 Rosemary Hill Road B74 4HN Sutton Coldfield West Midlands | British | 86839080001 | ||||||
| BEDDOW, Charles Edward Kenneth | Administrateur | Manor Road MK45 4NU Barton Le Clay 163 Bedfordshire | United Kingdom | British | 132281430001 | |||||
| BREEN, Michael John | Administrateur | 47 Wieland Road HA6 3QX Northwood Middlesex | England | English | 8442840002 | |||||
| COLES, Leslie David | Administrateur | Rose Cottage Marlowe Road Cadmore End HP14 3PF High Wycombe Buckinghamshire | British | 22041320003 | ||||||
| COPLEY, Noel St John | Administrateur | Pond Cottage The Green Harefield UB9 6NP Uxbridge Middlesex | British | 57446950001 | ||||||
| DAY, Barry David | Administrateur | The Old Rectory Hatton Green Hatton CV35 7LA Warwick Warwickshire | England | British | 57937960001 | |||||
| DYKSTRA, Paul Brian | Administrateur | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry C/O Paul Mckenna England | Usa | American | 191827990001 | |||||
| GIBBS, Carol Anne | Administrateur | Blacksmiths Cottage The Row Lane End HP14 3JZ High Wycombe Buckinghamshire | British | 22041330004 | ||||||
| GORDON, Neil Arthur | Administrateur | Stable Cottage, Burrows Lea Hook Lane, Shere GU5 9QQ Guildford Surrey | England | British | 73989530001 | |||||
| JACKSON, Jacqueline | Administrateur | 35 The High Street CM5 9EA Ongar Essex | British | 22041310002 | ||||||
| MAKANJI, Ashok | Administrateur | Unit 100 Centennial Avenue WD6 3SA Elstree Hertfordshire | United Kingdom | British | 120367360001 | |||||
| MARSHALL, Nicholas John | Administrateur | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry C/O Paul Mckenna England | England | British | 20708530004 | |||||
| MARSHALL, Nicholas John | Administrateur | Spring House Fieldgate Lawn, Fieldgate Lane CV8 1BT Kenilworth Warwickshire | England | British | 20708530004 | |||||
| POPP, Jason | Administrateur | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry Ges England | United States | American | 254059920001 | |||||
| SAMJI, Munir Akberali | Administrateur | Unit 100 Centennial Avenue WD6 3SA Elstree Hertfordshire | United Kingdom | United Kingdom | 119498620001 | |||||
| WATTS, Michael | Administrateur | Bottle Lane SL6 3SB Littlewick Green Bay Tree Cottage Berks | British | 133568510001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ASTONICS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viad Corp | 06 avr. 2016 | Suite 1900 Phoenix 1850 N Central Avenue Arizona United States | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
ASTONICS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 04 août 1993 Livré le 12 août 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge | Créé le 30 sept. 1992 Livré le 15 oct. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the equipment as shown on the attached schedule 1 x aston 4 video character generator serial no: 97447 complete with all ancillary equipment and seven additional typefaces and others (please see form 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
ASTONICS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0