ASTONICS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéASTONICS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02227900
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ASTONICS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe ASTONICS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ASTONICS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour ASTONICS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    10 pagesLIQ13

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Rsm Uk Central Square, Fifth Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Rsm Central Square 5th Floor, 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL United Kingdom à Rsm Uk Central Square, Fifth Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Ges Silverstone Drive Gallagher Business Park Coventry CV6 6PA England à Deloitte Llp 1 City Square Leeds LS1 2AL le 23 janv. 2020

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 13 janv. 2020

    LRESSP

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Rsm Central Square 5th Floor, 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL

    1 pagesAD02

    Cessation de la nomination de Jason Popp en tant que directeur le 20 sept. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Michael Stewart en tant que secrétaire le 09 janv. 2019

    2 pagesAP03

    Changement d'adresse du siège social de C/O Paul Mckenna Silverstone Drive Gallagher Business Park Coventry CV6 6PA à Ges Silverstone Drive Gallagher Business Park Coventry CV6 6PA le 09 janv. 2019

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Jason Popp en tant qu'administrateur le 09 janv. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Nicholas John Marshall en tant que directeur le 09 janv. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Paul Mckenna en tant que secrétaire le 09 janv. 2019

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 mars 2016

    État du capital au 01 mars 2016

    • Capital: GBP 6,666
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 mars 2015

    État du capital au 02 mars 2015

    • Capital: GBP 6,666
    SH01

    Qui sont les dirigeants de ASTONICS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    STEWART, Michael
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Deloitte Llp
    Secrétaire
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Deloitte Llp
    254071510001
    INGERSOLL, Ellen Marie
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Deloitte Llp
    Administrateur
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Deloitte Llp
    United StatesAmerican118864140001
    MOSTER, Steven
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Deloitte Llp
    Administrateur
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Deloitte Llp
    United StatesAmerican193607710001
    DAY, Christopher Alexander Coryton
    48 Whitley Court Road
    Quinton
    B32 1EY Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    48 Whitley Court Road
    Quinton
    B32 1EY Birmingham
    West Midlands
    British92047820001
    FARRELL, Sheila Margaret
    42a Redbourne Avenue
    Finchley
    N3 2BS London
    Secrétaire
    42a Redbourne Avenue
    Finchley
    N3 2BS London
    British57133980001
    FROST, Helen Margaret
    35 Carlton House
    Goral Mead
    WD3 1BP Rickmansworth
    Hertfordshire
    Secrétaire
    35 Carlton House
    Goral Mead
    WD3 1BP Rickmansworth
    Hertfordshire
    British36222730001
    GIBBS, Carol Anne
    Blacksmiths Cottage The Row
    Lane End
    HP14 3JZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Blacksmiths Cottage The Row
    Lane End
    HP14 3JZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    British22041330004
    GORDON, Neil Arthur
    Stable Cottage, Burrows Lea
    Hook Lane, Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    Stable Cottage, Burrows Lea
    Hook Lane, Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    British73989530001
    JACKSON, Jacqueline
    35 The High Street
    CM5 9EA Ongar
    Essex
    Secrétaire
    35 The High Street
    CM5 9EA Ongar
    Essex
    British22041310002
    MAKANJI, Ashok
    Silverstone Drive
    Gallagher Business Park
    CV6 6PA Coventry
    C/O Paul Mckenna
    England
    Secrétaire
    Silverstone Drive
    Gallagher Business Park
    CV6 6PA Coventry
    C/O Paul Mckenna
    England
    191996520001
    MAKANJI, Ashok
    Unit 100
    Centennial Avenue
    WD6 3SA Elstree
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Unit 100
    Centennial Avenue
    WD6 3SA Elstree
    Hertfordshire
    British120367360001
    MCKENNA, Paul
    Silverstone Drive
    Gallagher Business Park
    CV6 6PA Coventry
    C/O Paul Mckenna
    England
    Secrétaire
    Silverstone Drive
    Gallagher Business Park
    CV6 6PA Coventry
    C/O Paul Mckenna
    England
    193458250001
    PATEL, Daxshaben
    2 Millers Court
    Vicars Bridge Close
    HA0 1XG Alperton
    Middlesex
    Secrétaire
    2 Millers Court
    Vicars Bridge Close
    HA0 1XG Alperton
    Middlesex
    British96045520001
    WAKELEY, David Peacefull
    166 Rosemary Hill Road
    B74 4HN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    166 Rosemary Hill Road
    B74 4HN Sutton Coldfield
    West Midlands
    British86839080001
    BEDDOW, Charles Edward Kenneth
    Manor Road
    MK45 4NU Barton Le Clay
    163
    Bedfordshire
    Administrateur
    Manor Road
    MK45 4NU Barton Le Clay
    163
    Bedfordshire
    United KingdomBritish132281430001
    BREEN, Michael John
    47 Wieland Road
    HA6 3QX Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    47 Wieland Road
    HA6 3QX Northwood
    Middlesex
    EnglandEnglish8442840002
    COLES, Leslie David
    Rose Cottage Marlowe Road
    Cadmore End
    HP14 3PF High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Rose Cottage Marlowe Road
    Cadmore End
    HP14 3PF High Wycombe
    Buckinghamshire
    British22041320003
    COPLEY, Noel St John
    Pond Cottage The Green
    Harefield
    UB9 6NP Uxbridge
    Middlesex
    Administrateur
    Pond Cottage The Green
    Harefield
    UB9 6NP Uxbridge
    Middlesex
    British57446950001
    DAY, Barry David
    The Old Rectory Hatton Green
    Hatton
    CV35 7LA Warwick
    Warwickshire
    Administrateur
    The Old Rectory Hatton Green
    Hatton
    CV35 7LA Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish57937960001
    DYKSTRA, Paul Brian
    Silverstone Drive
    Gallagher Business Park
    CV6 6PA Coventry
    C/O Paul Mckenna
    England
    Administrateur
    Silverstone Drive
    Gallagher Business Park
    CV6 6PA Coventry
    C/O Paul Mckenna
    England
    UsaAmerican191827990001
    GIBBS, Carol Anne
    Blacksmiths Cottage The Row
    Lane End
    HP14 3JZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Blacksmiths Cottage The Row
    Lane End
    HP14 3JZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    British22041330004
    GORDON, Neil Arthur
    Stable Cottage, Burrows Lea
    Hook Lane, Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Stable Cottage, Burrows Lea
    Hook Lane, Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    EnglandBritish73989530001
    JACKSON, Jacqueline
    35 The High Street
    CM5 9EA Ongar
    Essex
    Administrateur
    35 The High Street
    CM5 9EA Ongar
    Essex
    British22041310002
    MAKANJI, Ashok
    Unit 100
    Centennial Avenue
    WD6 3SA Elstree
    Hertfordshire
    Administrateur
    Unit 100
    Centennial Avenue
    WD6 3SA Elstree
    Hertfordshire
    United KingdomBritish120367360001
    MARSHALL, Nicholas John
    Silverstone Drive
    Gallagher Business Park
    CV6 6PA Coventry
    C/O Paul Mckenna
    England
    Administrateur
    Silverstone Drive
    Gallagher Business Park
    CV6 6PA Coventry
    C/O Paul Mckenna
    England
    EnglandBritish20708530004
    MARSHALL, Nicholas John
    Spring House
    Fieldgate Lawn, Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    Spring House
    Fieldgate Lawn, Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    EnglandBritish20708530004
    POPP, Jason
    Silverstone Drive
    Gallagher Business Park
    CV6 6PA Coventry
    Ges
    England
    Administrateur
    Silverstone Drive
    Gallagher Business Park
    CV6 6PA Coventry
    Ges
    England
    United StatesAmerican254059920001
    SAMJI, Munir Akberali
    Unit 100
    Centennial Avenue
    WD6 3SA Elstree
    Hertfordshire
    Administrateur
    Unit 100
    Centennial Avenue
    WD6 3SA Elstree
    Hertfordshire
    United KingdomUnited Kingdom119498620001
    WATTS, Michael
    Bottle Lane
    SL6 3SB Littlewick Green
    Bay Tree Cottage
    Berks
    Administrateur
    Bottle Lane
    SL6 3SB Littlewick Green
    Bay Tree Cottage
    Berks
    British133568510001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ASTONICS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Viad Corp
    Suite 1900
    Phoenix
    1850 N Central Avenue
    Arizona
    United States
    06 avr. 2016
    Suite 1900
    Phoenix
    1850 N Central Avenue
    Arizona
    United States
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Autorité légaleSecurities Act Of 1933 And The Securities And Exchange Act Of 1934
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    ASTONICS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 04 août 1993
    Livré le 12 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 30 sept. 1992
    Livré le 15 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the equipment as shown on the attached schedule 1 x aston 4 video character generator serial no: 97447 complete with all ancillary equipment and seven additional typefaces and others (please see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Studio Capital PLC
    Transactions
    • 15 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 sept. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ASTONICS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    13 janv. 2020Commencement of winding up
    06 janv. 2021Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stephen Roland Browne
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    practitioner
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Adrian Peter Berry
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    practitioner
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0