QUENTIN PRESS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéQUENTIN PRESS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02227945
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de QUENTIN PRESS LIMITED ?

    • (2222) /

    Où se situe QUENTIN PRESS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de QUENTIN PRESS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BUSINESS PRINT CENTRE LIMITED17 sept. 199117 sept. 1991
    CLOAKPOINT LIMITED07 mars 198807 mars 1988

    Quels sont les derniers comptes de QUENTIN PRESS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour QUENTIN PRESS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    16 pages4.72

    Changement d'adresse du siège social de Farringdon Place 20 Farringdon Road London EC1M 3AP le 22 août 2013

    2 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 sept. 2012

    12 pages4.68

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:order of court removing liquidator
    34 pagesLIQ MISC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Changement d'adresse du siège social de Unit a1 Dolphin Way Estate Shoreham by Sea West Sussex BN43 6NZ le 04 oct. 2011

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    10 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 27 sept. 2011

    LRESEX

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 juil. 2011

    État du capital au 04 juil. 2011

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Gregory Priest le 01 juin 2011

    2 pagesCH01

    Divers

    Section 519
    1 pagesMISC

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2010

    8 pagesAA

    Cessation de la nomination de Paul Dupret en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr John Boyle en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Stephen Andrew Cropper en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    6 pagesMG01

    legacy

    3 pagesMG02

    Cessation de la nomination de Michael Quibell en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 mai 2010

    12 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2009

    14 pagesAA

    legacy

    7 pages363a

    Qui sont les dirigeants de QUENTIN PRESS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOLMES, Nigel David
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    Secrétaire
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    British24756150004
    BOYLE, John
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Administrateur
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United KingdomBritish141437280001
    CROPPER, Stephen Andrew
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Administrateur
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandBritish38816830003
    HOLMES, Nigel David
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    Administrateur
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    EnglandBritish24756150004
    PRIEST, Gregory
    Strawlands
    Plumpton Green
    BN7 3DB Lewes
    Tyra
    East Sussex
    Administrateur
    Strawlands
    Plumpton Green
    BN7 3DB Lewes
    Tyra
    East Sussex
    EnglandBritish129513580001
    FUNNELL, David William
    11 St Helens Crescent
    BN3 8EP Hove
    East Sussex
    Secrétaire
    11 St Helens Crescent
    BN3 8EP Hove
    East Sussex
    British15418470002
    QUIBELL, Michael Timothy
    Vale Farm
    BN8 4JE Chailey
    East Sussex
    Secrétaire
    Vale Farm
    BN8 4JE Chailey
    East Sussex
    British6706130001
    DUPRET, Paul Malcolm
    77 Beach Green
    BN43 5YE Shoreham By Sea
    West Sussex
    Administrateur
    77 Beach Green
    BN43 5YE Shoreham By Sea
    West Sussex
    EnglandBritish6706140002
    FUNNELL, David William
    11 St Helens Crescent
    BN3 8EP Hove
    East Sussex
    Administrateur
    11 St Helens Crescent
    BN3 8EP Hove
    East Sussex
    British15418470002
    QUIBELL, Michael Timothy
    Vale Farm
    BN8 4JE Chailey
    East Sussex
    Administrateur
    Vale Farm
    BN8 4JE Chailey
    East Sussex
    United KingdomBritish6706130001
    STILL, Stuart John
    4 The Chestnuts
    High Street
    BN8 5BA Barcombe
    Sussex
    Administrateur
    4 The Chestnuts
    High Street
    BN8 5BA Barcombe
    Sussex
    British6706170001
    SWAN, Stewart John
    7 Winterbourne Close
    BN7 1JY Lewes
    East Sussex
    Administrateur
    7 Winterbourne Close
    BN7 1JY Lewes
    East Sussex
    British6706180001

    QUENTIN PRESS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debentures
    Créé le 27 janv. 2011
    Livré le 29 janv. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Centric Spv 1 Limited
    Transactions
    • 29 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 30 juil. 2008
    Livré le 08 août 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 08 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    All assets debenture
    Créé le 05 mars 2007
    Livré le 07 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 07 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture deed
    Créé le 05 déc. 2003
    Livré le 06 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 06 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    All assets debenture
    Créé le 20 févr. 2003
    Livré le 25 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Capital Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 25 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 16 mai 2000
    Livré le 23 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 oct. 1994
    Livré le 28 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 28 oct. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    QUENTIN PRESS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 sept. 2011Commencement of winding up
    05 mars 2014Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Bryan Jackson
    Farringdon Place 20 Farringdon Road
    EC1M 3AP London
    practitioner
    Farringdon Place 20 Farringdon Road
    EC1M 3AP London
    Stephen Paul Holgate
    Farringdon Place 20 Farringdon Road
    EC1M 3AP London
    practitioner
    Farringdon Place 20 Farringdon Road
    EC1M 3AP London
    James Douglas Ernle Money
    Farringdon Place 20 Farringdon Road
    EC1M 3AP London
    practitioner
    Farringdon Place 20 Farringdon Road
    EC1M 3AP London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0