DATAFORM (NORTHERN) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDATAFORM (NORTHERN) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02229065
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DATAFORM (NORTHERN) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe DATAFORM (NORTHERN) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Communisis House
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DATAFORM (NORTHERN) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    YORKSHIRE BUSINESS FORMS LIMITED24 juin 198824 juin 1988
    BANGQUOTE LIMITED10 mars 198810 mars 1988

    Quels sont les derniers comptes de DATAFORM (NORTHERN) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour DATAFORM (NORTHERN) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2018

    4 pagesAA

    Nomination de Mr Steven Clive Rawlins en tant que secrétaire le 28 févr. 2019

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Sarah Louise Caddy en tant que secrétaire le 28 févr. 2019

    1 pagesTM02

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2017

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    4 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 août 2015

    État du capital au 05 août 2015

    • Capital: GBP 75,000
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 août 2014

    État du capital au 20 août 2014

    • Capital: GBP 75,000
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Miss Sarah Louise Caddy le 15 août 2014

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jonathan Rowlatt Huber Riddle le 15 août 2014

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Wakefield Road Leeds West Yorkshire LS10 1DU à Communisis House Manston Lane Leeds LS15 8AH le 15 août 2014

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 juil. 2013

    État du capital au 30 juil. 2013

    • Capital: GBP 75,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    4 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Miss Sarah Louise Morton le 20 sept. 2012

    1 pagesCH03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    4 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de DATAFORM (NORTHERN) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RAWLINS, Steven Clive
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Communisis House
    England
    England
    Secrétaire
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Communisis House
    England
    England
    256219410001
    RIDDLE, Jonathan Rowlatt Huber
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Communisis House
    United Kingdom
    Administrateur
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Communisis House
    United Kingdom
    EnglandBritishTax Manager53609030001
    CADDY, Sarah Louise
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Communisis House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Communisis House
    United Kingdom
    146627560002
    EGERTON, Peter Wilfrid
    54 Callander
    Ouston
    DH2 1LG Chester Le Street
    County Durham
    Secrétaire
    54 Callander
    Ouston
    DH2 1LG Chester Le Street
    County Durham
    British6042050002
    MILTON, Keith Bertram
    25 Rectory Grove
    NE3 1AL Gosforth
    Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire
    25 Rectory Grove
    NE3 1AL Gosforth
    Newcastle Upon Tyne
    BritishCompany Secretary76950940001
    WARE, Andrew
    Cauldwell
    Snows Green Road
    DH8 0NJ Shotley Bridge
    Durham
    Secrétaire
    Cauldwell
    Snows Green Road
    DH8 0NJ Shotley Bridge
    Durham
    BritishDirector110947260001
    WORSNOP, Marshall Barry
    6 Florence Road
    HG2 0LD Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    6 Florence Road
    HG2 0LD Harrogate
    North Yorkshire
    British22406990001
    WYNDHAM, Rupert Charles Edward
    Oakwood 15 Crabtree Road
    NE43 7NX Stocksfield
    Northumberland
    Secrétaire
    Oakwood 15 Crabtree Road
    NE43 7NX Stocksfield
    Northumberland
    BritishCompany Secretary43721290001
    YOUNG, Martin Keay
    3 Penny Pot Gardens
    HG3 2GB Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    3 Penny Pot Gardens
    HG3 2GB Harrogate
    North Yorkshire
    BritishCompany Secretary41926620002
    GOLDMAN, Alan David
    13 Fernville Road
    Gosforth
    NE3 4HT Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    13 Fernville Road
    Gosforth
    NE3 4HT Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishCompany Director6042060001
    HARRISON, Kenneth John
    5 St Georges Avenue
    Timperley
    WA15 6HF Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    5 St Georges Avenue
    Timperley
    WA15 6HF Altrincham
    Cheshire
    BritishNorth West Divisional Director9436420001
    HOLBROOK, Bradley
    North Moor
    36 Station Road Stannington
    NE61 6DU Morpeth
    Northumberland
    Administrateur
    North Moor
    36 Station Road Stannington
    NE61 6DU Morpeth
    Northumberland
    EnglandBritishCompany Director50693590001
    HOLBROOK, Graham
    19 Ashdale
    Mount Pleasant
    DH4 7SL Fatfield, Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Administrateur
    19 Ashdale
    Mount Pleasant
    DH4 7SL Fatfield, Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    BritishCompany Director50927850001
    MILTON, Keith Bertram
    25 Rectory Grove
    NE3 1AL Gosforth
    Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    25 Rectory Grove
    NE3 1AL Gosforth
    Newcastle Upon Tyne
    BritishCompany Director76950940001
    MORAN, Denise
    Beech House High Street
    Billingley
    S72 0HY Barnsley
    South Yorkshire
    Administrateur
    Beech House High Street
    Billingley
    S72 0HY Barnsley
    South Yorkshire
    BritishDirector99531800001
    POWELL, Bruce Lewis Hamilton
    Broadhatch House
    Bentley
    GU10 5JJ Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Broadhatch House
    Bentley
    GU10 5JJ Farnham
    Surrey
    United KingdomBritishDirector15809770001
    PYGALL, Christopher
    1 Mulberry Close
    NE24 3XR Blyth
    Northumberland
    Administrateur
    1 Mulberry Close
    NE24 3XR Blyth
    Northumberland
    BritishCompany Director56373380002
    RATCLIFFE, Paula Eileen
    The Grange
    Granby
    NG13 9PW Nottingham
    Administrateur
    The Grange
    Granby
    NG13 9PW Nottingham
    BritishDirector50190420001
    SIMPSON, Paul Stephen
    The Corfields
    Pinfold Lane
    DN6 0ED Moss
    South Yorkshire
    Administrateur
    The Corfields
    Pinfold Lane
    DN6 0ED Moss
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector150743370001
    SPENCE, Ian Roger
    6 Redhills Lane
    DH1 4AJ Durham
    Administrateur
    6 Redhills Lane
    DH1 4AJ Durham
    BritishMarketing79113550001
    STEEN, John Matheson
    88 Main Street
    Felton
    NE65 9PZ Morpeth
    Northumberland
    Administrateur
    88 Main Street
    Felton
    NE65 9PZ Morpeth
    Northumberland
    BritishDirector56207820002
    WALKER, Paul Ashton
    1 Furzefield Road
    Gosforth
    NE3 4EA Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    1 Furzefield Road
    Gosforth
    NE3 4EA Newcastle Upon Tyne
    BritishCompany Director19807800002
    WARE, Andrew
    Cauldwell
    Snows Green Road
    DH8 0NJ Shotley Bridge
    Durham
    Administrateur
    Cauldwell
    Snows Green Road
    DH8 0NJ Shotley Bridge
    Durham
    United KingdomBritishDirector110947260001
    WORSNOP, Marshall Barry
    6 Florence Road
    HG2 0LD Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    6 Florence Road
    HG2 0LD Harrogate
    North Yorkshire
    BritishRegional Sales Manager22406990001
    YOUNG, Martin Keay
    3 Penny Pot Gardens
    HG3 2GB Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    3 Penny Pot Gardens
    HG3 2GB Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Secretary41926620002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DATAFORM (NORTHERN) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Communisis Dataform Limited
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Communisis House
    England
    06 avr. 2016
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Communisis House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    DATAFORM (NORTHERN) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 18 déc. 1997
    Livré le 27 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company (formerly known as yorkshire business forms limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 déc. 1994
    Livré le 03 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 7 didcot way boldon business park boldon. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 mai 1993
    Livré le 13 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 7 didcot way, boldon business park, boldon. By way of fixed charged all the plant machinery and fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils now and in the future at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 mai 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 juin 1990
    Livré le 30 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 7 didcot way, boldon business park, boldon, tyne & wear fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment & fixtures & fittings.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 08 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 oct. 1989
    Livré le 11 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 48 bradford road stanningley, leeds west yorkshire title no wyk 385329 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment. Fixtures & fittings.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    • 15 mars 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 mai 1988
    Livré le 07 juin 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures & fittings fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transactions
    • 07 juin 1988Enregistrement d'une charge
    • 15 mars 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0