DATAFORM (NORTHERN) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | DATAFORM (NORTHERN) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02229065 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe DATAFORM (NORTHERN) LIMITED ?
Adresse du siège social | Communisis House Manston Lane LS15 8AH Leeds |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de DATAFORM (NORTHERN) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour DATAFORM (NORTHERN) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2018 | 4 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Steven Clive Rawlins en tant que secrétaire le 28 févr. 2019 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Sarah Louise Caddy en tant que secrétaire le 28 févr. 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2017 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 4 pages | AA | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Miss Sarah Louise Caddy le 15 août 2014 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jonathan Rowlatt Huber Riddle le 15 août 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Wakefield Road Leeds West Yorkshire LS10 1DU à Communisis House Manston Lane Leeds LS15 8AH le 15 août 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 4 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Miss Sarah Louise Morton le 20 sept. 2012 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 4 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de DATAFORM (NORTHERN) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAWLINS, Steven Clive | Secrétaire | Manston Lane LS15 8AH Leeds Communisis House England England | 256219410001 | |||||||
RIDDLE, Jonathan Rowlatt Huber | Administrateur | Manston Lane LS15 8AH Leeds Communisis House United Kingdom | England | British | Tax Manager | 53609030001 | ||||
CADDY, Sarah Louise | Secrétaire | Manston Lane LS15 8AH Leeds Communisis House United Kingdom | 146627560002 | |||||||
EGERTON, Peter Wilfrid | Secrétaire | 54 Callander Ouston DH2 1LG Chester Le Street County Durham | British | 6042050002 | ||||||
MILTON, Keith Bertram | Secrétaire | 25 Rectory Grove NE3 1AL Gosforth Newcastle Upon Tyne | British | Company Secretary | 76950940001 | |||||
WARE, Andrew | Secrétaire | Cauldwell Snows Green Road DH8 0NJ Shotley Bridge Durham | British | Director | 110947260001 | |||||
WORSNOP, Marshall Barry | Secrétaire | 6 Florence Road HG2 0LD Harrogate North Yorkshire | British | 22406990001 | ||||||
WYNDHAM, Rupert Charles Edward | Secrétaire | Oakwood 15 Crabtree Road NE43 7NX Stocksfield Northumberland | British | Company Secretary | 43721290001 | |||||
YOUNG, Martin Keay | Secrétaire | 3 Penny Pot Gardens HG3 2GB Harrogate North Yorkshire | British | Company Secretary | 41926620002 | |||||
GOLDMAN, Alan David | Administrateur | 13 Fernville Road Gosforth NE3 4HT Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | Company Director | 6042060001 | |||||
HARRISON, Kenneth John | Administrateur | 5 St Georges Avenue Timperley WA15 6HF Altrincham Cheshire | British | North West Divisional Director | 9436420001 | |||||
HOLBROOK, Bradley | Administrateur | North Moor 36 Station Road Stannington NE61 6DU Morpeth Northumberland | England | British | Company Director | 50693590001 | ||||
HOLBROOK, Graham | Administrateur | 19 Ashdale Mount Pleasant DH4 7SL Fatfield, Houghton Le Spring Tyne & Wear | British | Company Director | 50927850001 | |||||
MILTON, Keith Bertram | Administrateur | 25 Rectory Grove NE3 1AL Gosforth Newcastle Upon Tyne | British | Company Director | 76950940001 | |||||
MORAN, Denise | Administrateur | Beech House High Street Billingley S72 0HY Barnsley South Yorkshire | British | Director | 99531800001 | |||||
POWELL, Bruce Lewis Hamilton | Administrateur | Broadhatch House Bentley GU10 5JJ Farnham Surrey | United Kingdom | British | Director | 15809770001 | ||||
PYGALL, Christopher | Administrateur | 1 Mulberry Close NE24 3XR Blyth Northumberland | British | Company Director | 56373380002 | |||||
RATCLIFFE, Paula Eileen | Administrateur | The Grange Granby NG13 9PW Nottingham | British | Director | 50190420001 | |||||
SIMPSON, Paul Stephen | Administrateur | The Corfields Pinfold Lane DN6 0ED Moss South Yorkshire | England | British | Director | 150743370001 | ||||
SPENCE, Ian Roger | Administrateur | 6 Redhills Lane DH1 4AJ Durham | British | Marketing | 79113550001 | |||||
STEEN, John Matheson | Administrateur | 88 Main Street Felton NE65 9PZ Morpeth Northumberland | British | Director | 56207820002 | |||||
WALKER, Paul Ashton | Administrateur | 1 Furzefield Road Gosforth NE3 4EA Newcastle Upon Tyne | British | Company Director | 19807800002 | |||||
WARE, Andrew | Administrateur | Cauldwell Snows Green Road DH8 0NJ Shotley Bridge Durham | United Kingdom | British | Director | 110947260001 | ||||
WORSNOP, Marshall Barry | Administrateur | 6 Florence Road HG2 0LD Harrogate North Yorkshire | British | Regional Sales Manager | 22406990001 | |||||
YOUNG, Martin Keay | Administrateur | 3 Penny Pot Gardens HG3 2GB Harrogate North Yorkshire | England | British | Company Secretary | 41926620002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DATAFORM (NORTHERN) LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communisis Dataform Limited | 06 avr. 2016 | Manston Lane LS15 8AH Leeds Communisis House England | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
|
DATAFORM (NORTHERN) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 18 déc. 1997 Livré le 27 déc. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company (formerly known as yorkshire business forms limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 01 déc. 1994 Livré le 03 déc. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Unit 7 didcot way boldon business park boldon. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 10 mai 1993 Livré le 13 mai 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Unit 7 didcot way, boldon business park, boldon. By way of fixed charged all the plant machinery and fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils now and in the future at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 29 juin 1990 Livré le 30 juin 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Unit 7 didcot way, boldon business park, boldon, tyne & wear fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment & fixtures & fittings. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 03 oct. 1989 Livré le 11 oct. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H 48 bradford road stanningley, leeds west yorkshire title no wyk 385329 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment. Fixtures & fittings. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 31 mai 1988 Livré le 07 juin 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures & fittings fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0