PREBON GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPREBON GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02230414
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PREBON GROUP LIMITED ?

    • Activités des sociétés holding de services financiers (64205) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe PREBON GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    135 Bishopsgate
    EC2M 3TP London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PREBON GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MARSHALLS FINANCE LIMITED13 déc. 198813 déc. 1988
    AUSHOLD LIMITED15 mars 198815 mars 1988

    Quels sont les derniers comptes de PREBON GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour PREBON GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pagesLIQ13

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 16 déc. 2022

    LRESSP

    Statuts

    25 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    État du capital au 18 oct. 2022

    • Capital: GBP 0.25
    4 pagesSH02

    Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2022 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Modification des détails de Tullett Prebon Investment Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 nov. 2021

    2 pagesPSC05

    Modification des détails de Tullett Prebon Investment Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 mai 2021

    2 pagesPSC05

    Nomination de Mr Andrew Ren-Yiing Chen en tant qu'administrateur le 01 avr. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Robin James Stewart en tant que directeur le 01 avr. 2022

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    18 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Floor 2 155 Bishopsgate London EC2M 3TQ England à 135 Bishopsgate London EC2M 3TP le 07 mai 2021

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    19 pagesAA

    État du capital au 12 nov. 2020

    • Capital: GBP 17.85
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 14 mai 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    21 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 mai 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de PREBON GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHEN, Andrew Ren-Yiing
    EC2M 3TP London
    135 Bishopsgate
    England
    Administrateur
    EC2M 3TP London
    135 Bishopsgate
    England
    EnglandBritish225251990001
    WILLIAMS, David Huw
    EC2M 3TP London
    135 Bishopsgate
    England
    Administrateur
    EC2M 3TP London
    135 Bishopsgate
    England
    United KingdomBritish134162960002
    ANKERS, Peter
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    Secrétaire
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    British56413750001
    BRILL, Tiffany Fern
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    Secrétaire
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    218149260001
    CHALLEN, Nicola
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Secrétaire
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Other119903660002
    DE FREITAS, Maria Teresa
    Flat 1 47 Lloyd Baker Street
    WC1X 9AA London
    Secrétaire
    Flat 1 47 Lloyd Baker Street
    WC1X 9AA London
    British95153090009
    DEARLOVE, Juliet Mary
    Churchgate House
    15 Churchgate Street
    CM17 0JT Old Harlow
    Essex
    Secrétaire
    Churchgate House
    15 Churchgate Street
    CM17 0JT Old Harlow
    Essex
    British72784040001
    DYER BARTLETT, Diana
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Secrétaire
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    177054120001
    HOSKINS, Justin Wilbert
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Secrétaire
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    171913630001
    PEEL, Alistair Charles
    Deep Acres
    HP6 5NX Amersham
    6
    Bucks
    England
    Secrétaire
    Deep Acres
    HP6 5NX Amersham
    6
    Bucks
    England
    Other132896170001
    RAVER, Harold Mark
    21 Colson Gardens
    IG10 3RE Loughton
    Essex
    Secrétaire
    21 Colson Gardens
    IG10 3RE Loughton
    Essex
    British1493340004
    DAVID VENUS & COMPANY LLP
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    Forme juridiqueLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Type d'identificationHors EEE
    Autorité légaleCOMPANIES ACT 2006
    Numéro d'enregistrementOC309455
    131429630001
    AIREY, Michael Gareth
    House B Greenland Villas
    8-12 Ma Yeung Path
    Kau To Shan
    Shatin
    Hong Kong
    Administrateur
    House B Greenland Villas
    8-12 Ma Yeung Path
    Kau To Shan
    Shatin
    Hong Kong
    British50290930003
    BADDELEY, Andrew Martin
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    Administrateur
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    United Kingdom
    United KingdomBritish82469460001
    BENTLEY, Peter John
    10 Myln Meadow
    Stock
    CM4 9NE Ingatestone
    Essex
    Administrateur
    10 Myln Meadow
    Stock
    CM4 9NE Ingatestone
    Essex
    British2039000001
    BOTTCHER, Friedrich Mathieu Jean
    Singel 192
    FOREIGN 1016 Aa Amsterdam
    Netherlands
    Administrateur
    Singel 192
    FOREIGN 1016 Aa Amsterdam
    Netherlands
    Dutch70253240003
    BURTON, Anthony David
    Beechwood House Halls Hole Road
    TN2 4RD Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    Beechwood House Halls Hole Road
    TN2 4RD Tunbridge Wells
    Kent
    UkBritish3513950001
    CAMERON SMAIL, Barry James
    4 Gorse Lane
    Wrecclesham
    GU10 4SD Farnham
    Surrey
    Administrateur
    4 Gorse Lane
    Wrecclesham
    GU10 4SD Farnham
    Surrey
    British45139170001
    COLLIS, Sarah Ann
    53 The Avenue
    West Ealing
    W13 8JR London
    Administrateur
    53 The Avenue
    West Ealing
    W13 8JR London
    EnglandBritish35447290002
    COWAN, Christopher Ian
    Ballards
    Ballards Lane
    RH8 0SN Limpsfield
    Surrey
    Administrateur
    Ballards
    Ballards Lane
    RH8 0SN Limpsfield
    Surrey
    British54679190001
    DORJEE, Frank Franciscus
    Heidelaantje 3
    Huizen 1272 Pe
    Netherlands
    Administrateur
    Heidelaantje 3
    Huizen 1272 Pe
    Netherlands
    NetherlandsDutch162922400001
    EVANS, Andrew Keith
    177 Burtons Road
    Hampton Hill
    TW12 1DX Hampton
    Middlesex
    Administrateur
    177 Burtons Road
    Hampton Hill
    TW12 1DX Hampton
    Middlesex
    EnglandBritish124021620001
    FRANKS, Louis Eric Arthur
    29 Baytree Walk
    WD1 3RX Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    29 Baytree Walk
    WD1 3RX Watford
    Hertfordshire
    British68885740001
    GODDARD, Peter Anthony
    3 Aylmer Close
    HA7 3EQ Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    3 Aylmer Close
    HA7 3EQ Stanmore
    Middlesex
    British75308340003
    HARRISON, John Trevor
    Woodcote
    1b Harmer Dell
    AL6 0BE Welwyn
    Hertfordshire
    Administrateur
    Woodcote
    1b Harmer Dell
    AL6 0BE Welwyn
    Hertfordshire
    EnglandBritish120531710001
    HIGAKI, Keiji
    3-43-4 Uehara
    Shibuya-Ku
    Tokyo
    151-0064
    Japan
    Administrateur
    3-43-4 Uehara
    Shibuya-Ku
    Tokyo
    151-0064
    Japan
    Japanese53144490002
    HIROSE, Kimtake
    A-1 3-13-1 Kamisaginomiya
    Nakano-Ku
    Tokyo
    Japan 165
    Administrateur
    A-1 3-13-1 Kamisaginomiya
    Nakano-Ku
    Tokyo
    Japan 165
    Japanese35279750001
    HOLMES, Deborah Ann
    87 Carrara Wharf
    Ranelagh Gardens Putney Bridge
    SW6 3UE London
    Administrateur
    87 Carrara Wharf
    Ranelagh Gardens Putney Bridge
    SW6 3UE London
    Australian113674080001
    HONKE, Masataka
    1-33-2 Higashiyurigoaka
    Asoh-Ku
    Kawasaki Kanagawa
    215-0012
    Japan
    Administrateur
    1-33-2 Higashiyurigoaka
    Asoh-Ku
    Kawasaki Kanagawa
    215-0012
    Japan
    Japanese75371270001
    HOOPER, David Charles
    Alouette
    Mayfield Lane
    TN5 6HX Wadhurst
    East Sussex
    Administrateur
    Alouette
    Mayfield Lane
    TN5 6HX Wadhurst
    East Sussex
    British85448170001
    HUGHES, Arthur Mcquade
    Miran San
    11 Windlesham Court Snows Ride
    GU20 6LA Windlesham
    Surrey
    Administrateur
    Miran San
    11 Windlesham Court Snows Ride
    GU20 6LA Windlesham
    Surrey
    United KingdomBritish1458920002
    JACK, Stephen Andrew
    1 Hunter Road
    West Wimbledon
    SW20 8NZ London
    Administrateur
    1 Hunter Road
    West Wimbledon
    SW20 8NZ London
    EnglandBritish13013280001
    KEENAN, Patrick Michael
    10 Plane Tree House
    Duchess Of Bedfords Walk
    W8 7QT London
    Administrateur
    10 Plane Tree House
    Duchess Of Bedfords Walk
    W8 7QT London
    Australian42704380002
    KELSON, Christopher John Kerry
    441 E 84th Street
    New York
    Ny 10028
    United States
    Administrateur
    441 E 84th Street
    New York
    Ny 10028
    United States
    British2039010006
    KEMBER, William Percy
    83 Hillway
    Highgate
    N6 6AB London
    Administrateur
    83 Hillway
    Highgate
    N6 6AB London
    British6655760001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PREBON GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Tp Icap Emea Investments Limited
    Bishopsgate
    EC2M 3TP London
    135
    England
    06 avr. 2016
    Bishopsgate
    EC2M 3TP London
    135
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House (England And Wales)
    Numéro d'enregistrement7042902
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    PREBON GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Second priority floating charge
    Créé le 26 févr. 2001
    Livré le 16 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the guarantee and at the times and in the manner provided in the guarantee and loan note (all as defined)
    Brèves mentions
    Subject to the prior ranking of the senior charge (as defined) all the company's property assets rights and revenues whatsoever and wheresoever present and future including its uncalled share capital (if any) or such of them as the context requires.
    Personnes ayant droit
    • Yamane Tanshi Co LTD
    Transactions
    • 16 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit agreement
    Créé le 28 juin 1999
    Livré le 01 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £164,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All the interest of the company in the sum of £164,000.
    Personnes ayant droit
    • Railtrack PLC
    Transactions
    • 01 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 28 mai 1999
    Livré le 16 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    In favour of the chargee each and every liability arising under the finance documents which the company may have had at the time the debenture was entered into or thereafter have to the security trustee or any of the beneficiaries and pay to the security trustee every sum now or thereafter owing due or incurred by the company to the security trustee or any of the beneficiaries in respect of any such liabilities
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC (As Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 16 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 15 déc. 1993
    Livré le 23 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Tokyo International Limitedas Agent for Itself and the Banks
    Transactions
    • 23 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juil. 1994Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 14 févr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 28 févr. 1989
    Livré le 13 mars 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent for itself and the lenders as defined in the loan agreement dated 27/2/89 under the terms of a guarantee of even date and this charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Security Pacific National Bank
    Transactions
    • 13 mars 1989Enregistrement d'une charge
    • 06 mai 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 27 févr. 1989
    Livré le 08 mars 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent for itself and the banks as defined in the loan agreement of even date under the terms of the said loan agreement and/or this charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Security Pacific National Bankas Agent for Itself and the Banks as Defined Inthe Loan Agreement
    Transactions
    • 08 mars 1989Enregistrement d'une charge
    • 08 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    PREBON GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 déc. 2022Commencement of winding up
    14 sept. 2023Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Laura May Waters
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0