VARIN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVARIN LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02230594
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VARIN LIMITED ?

    • (5170) /

    Où se situe VARIN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Smith & Williamson
    Prospect House
    N20 9YU 2 Athernaeum Road
    London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de VARIN LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2004

    Quels sont les derniers dépôts pour VARIN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 avr. 2011

    5 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    3 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 janv. 2011

    9 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 juil. 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 janv. 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 juil. 2009

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 janv. 2009

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 juil. 2008

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    legacy

    1 pages287

    Déclaration des affaires

    6 pages4.20

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation

    LRESEX

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 mars 2004

    6 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution élective

    ELRES

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution élective

    ELRES

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution élective

    ELRES

    legacy

    1 pages287

    Qui sont les dirigeants de VARIN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VICKERS, Philip
    37 Rowanswood Drive
    Godley
    SK14 3SA Hyde
    Cheshire
    Secrétaire
    37 Rowanswood Drive
    Godley
    SK14 3SA Hyde
    Cheshire
    BritishAccountant39881280001
    SYNETT, Jacob Julian
    The Old Stables
    Pinnacle Place, Green Lane
    HA7 3AA Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    The Old Stables
    Pinnacle Place, Green Lane
    HA7 3AA Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director78716770002
    VICKERS, Philip
    37 Rowanswood Drive
    Godley
    SK14 3SA Hyde
    Cheshire
    Administrateur
    37 Rowanswood Drive
    Godley
    SK14 3SA Hyde
    Cheshire
    EnglandBritishAccountant39881280001
    EBERHARDT, Martin
    39 Broad Ha'Penny
    Boundstone Road
    GU10 4TF Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    39 Broad Ha'Penny
    Boundstone Road
    GU10 4TF Farnham
    Surrey
    BritishCompany Director54644630001
    FREEMAN, Philip William
    16 Barcheston Road
    Knowle
    B93 9JS Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    16 Barcheston Road
    Knowle
    B93 9JS Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Secretary47061120001
    LATHAM, Anthony Robert
    Lone Elm
    46 Victoria Road
    OX14 1DQ Abingdon
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Lone Elm
    46 Victoria Road
    OX14 1DQ Abingdon
    Oxfordshire
    British30869320001
    PENNINGTON, David Ian
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    BritishSecretary38346120001
    ANDRE, Jean Claude
    17 Rue Xaintrailles
    Paris 75013
    France
    Administrateur
    17 Rue Xaintrailles
    Paris 75013
    France
    FrenchCompany Director38596670001
    EBERHARDT, Martin
    39 Broad Ha'Penny
    Boundstone Road
    GU10 4TF Farnham
    Surrey
    Administrateur
    39 Broad Ha'Penny
    Boundstone Road
    GU10 4TF Farnham
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director54644630001
    FREEMAN, Philip William
    16 Barcheston Road
    Knowle
    B93 9JS Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    16 Barcheston Road
    Knowle
    B93 9JS Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director47061120001
    HANNA, Michael
    26 Turpins Avenue
    CO15 5HE Holland On Sea
    Essex
    Administrateur
    26 Turpins Avenue
    CO15 5HE Holland On Sea
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director68319570001
    HAYES, Kevin Andrew
    4 Elm Road
    SO22 5AG Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    4 Elm Road
    SO22 5AG Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishFinance Director29737760001
    HUCKLE, John Richard William
    15 Homefield Road
    Wimbledon
    SW19 4QF London
    Administrateur
    15 Homefield Road
    Wimbledon
    SW19 4QF London
    BritishDirector49301820001
    HUNT, Andrew
    Levercrest House
    Eurolink Industrial Estate
    ME10 3RN Sittingbourne
    Kent
    Administrateur
    Levercrest House
    Eurolink Industrial Estate
    ME10 3RN Sittingbourne
    Kent
    BritishCompany Director43624370001
    HUNT, Geoffrey Douglas
    The Drove House Drove Lane
    Cold Ash
    RG18 9NP Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    The Drove House Drove Lane
    Cold Ash
    RG18 9NP Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director11605030001
    LATHAM, Anthony Robert
    Lone Elm
    46 Victoria Road
    OX14 1DQ Abingdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    Lone Elm
    46 Victoria Road
    OX14 1DQ Abingdon
    Oxfordshire
    BritishAccountant30869320001
    LOYNES, Alan
    25 Molivers Lane
    Bromham
    MK43 8JT Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    25 Molivers Lane
    Bromham
    MK43 8JT Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishCompany Director7815680001
    ORROCK, Ian Jackson
    The Yardhouse
    Edinample
    FK19 8QE Loch Earn
    Perthshire
    Administrateur
    The Yardhouse
    Edinample
    FK19 8QE Loch Earn
    Perthshire
    United KingdomBritishCompany Director34054760010
    PAZZARD, Bernard Charles Egbert
    75 Avalon Road
    Earley
    RG6 7NR Reading
    Administrateur
    75 Avalon Road
    Earley
    RG6 7NR Reading
    EnglandBritishManaging Director86671260001
    RYAN, Peter Henry
    Chalet Vent Du Nord
    Rue Des Gentianes 7
    Crans Sur Sierre
    3963
    Switzerland
    Administrateur
    Chalet Vent Du Nord
    Rue Des Gentianes 7
    Crans Sur Sierre
    3963
    Switzerland
    BritishCompany Director25011740005
    SMITH, Leslie Arthur David
    Squirrel Lodge The Mount
    Highclere
    RG15 9RA Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Squirrel Lodge The Mount
    Highclere
    RG15 9RA Newbury
    Berkshire
    BritishSales Engineer11647970001
    STATHAM, James Edward Anthony
    Highlands
    TR11 5LA Helford Passage
    Cornwall
    Administrateur
    Highlands
    TR11 5LA Helford Passage
    Cornwall
    United KingdomBritishCompany Director150614890001
    WHITEHEAD, Colin Bernard
    89 Old Fort Road
    Shoreham Beach
    BN43 5HA Shoreham By Sea
    West Sussex
    Administrateur
    89 Old Fort Road
    Shoreham Beach
    BN43 5HA Shoreham By Sea
    West Sussex
    BritishCompany Director20196890007

    VARIN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 12 nov. 2003
    Livré le 21 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of amendment
    Créé le 26 mars 1998
    Livré le 09 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the finance documents (as defined) or any of them and all obligations due or to become due from each other company (as defined) under or pursuant to the finance documents or any of them and all monies and liabilities due or to become due to the finance parties or any of them under or pursuant to the finance documents or any of them and by any other present or future subsidiary (as defined) of the parent (as defined) and on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC; In Its Capacity as Trustee on Behalf of the Finance Parties
    Transactions
    • 09 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 18 févr. 1998
    Livré le 02 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the finance documents (as defined) or any of them and all obligations due or to become due from each other company (as defined) under or pursuant to the finance documents or any of them and all monies and liabilities due or to become due to the finance parties or any of them under or pursuant to the finance documents or any of them and by any other present or future subsidiary (as defined) of the parent (as defined) and on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2 downgate drive, sheffield; jays close viables basingstoke; units 1,2, 3 and 10 campbell court bramley hampshire .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC; In Its Capacity as Trustee on Behalf of the Finance Parties
    Transactions
    • 02 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 30 avr. 1997
    Livré le 02 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank Limited
    Transactions
    • 02 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 09 janv. 1996
    Livré le 16 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 mai 1995
    Livré le 06 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juil. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 26 juin 1991
    Livré le 16 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (See form 395 ref M579C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 04 mai 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    VARIN LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 janv. 2006Commencement of winding up
    11 août 2011Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stephen Robert Leslie Cork
    Smith & Williamson
    Prospect House
    N20 9YU 2 Athenaeum Road
    London
    practitioner
    Smith & Williamson
    Prospect House
    N20 9YU 2 Athenaeum Road
    London
    Joanne Elizabeth Milner
    Smith & Williamson Ltd
    Prospect House
    N20 9YU 2 Athenaeum Road
    London
    practitioner
    Smith & Williamson Ltd
    Prospect House
    N20 9YU 2 Athenaeum Road
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0