PARAGON MORTGAGES (NO. 3) LIMITED

PARAGON MORTGAGES (NO. 3) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPARAGON MORTGAGES (NO. 3) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02231301
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PARAGON MORTGAGES (NO. 3) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PARAGON MORTGAGES (NO. 3) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    51 Homer Road
    B91 3QJ Solihull
    West Midlands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PARAGON MORTGAGES (NO. 3) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PARAGON MORTGAGES (NO. 3) PLC16 mai 200116 mai 2001
    PARAGON MORTGAGES (NO 3) PLC09 mars 200109 mars 2001
    COLLATERALISED MORTGAGE SECURITIES (NO 10) PLC08 mai 199108 mai 1991
    MAJORMAMMOTH PUBLIC LIMITED COMPANY16 mars 198816 mars 1988

    Quels sont les derniers comptes de PARAGON MORTGAGES (NO. 3) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour PARAGON MORTGAGES (NO. 3) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Changement d'adresse du siège social de St Catherine's Court Herbert Road Solihull West Midlands B91 3QE le 07 déc. 2012

    2 pagesAD01

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 oct. 2012

    État du capital au 08 oct. 2012

    • Capital: GBP 10
    SH01

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2011

    10 pagesAA

    État du capital au 08 juin 2012

    • Capital: GBP 10
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    27 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Certificat de réimmatriculation de société anonyme à responsabilité limitée

    1 pagesCERT10

    Réenregistrement des statuts

    27 pagesMAR

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de réimmatriculation

    RES02

    Re-enregistrement d'une société publique en société à responsabilité limitée privée

    2 pagesRR02

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2010

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Richard Dominic Shelton le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Keen le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Grigor Gemmell le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr John Grigor Gemmell le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Cessation de la nomination de Adem Mehmet en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de PARAGON MORTGAGES (NO. 3) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GEMMELL, John Grigor
    Homer Road
    B91 3QJ Solihull
    51
    West Midlands
    Secrétaire
    Homer Road
    B91 3QJ Solihull
    51
    West Midlands
    BritishAccountant84111440004
    GEMMELL, John Grigor
    Homer Road
    B91 3QJ Solihull
    51
    West Midlands
    Administrateur
    Homer Road
    B91 3QJ Solihull
    51
    West Midlands
    United KingdomBritishGroup Company Secretary84111440004
    KEEN, Nicholas
    Homer Road
    B91 3QJ Solihull
    51
    West Midlands
    Administrateur
    Homer Road
    B91 3QJ Solihull
    51
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector85330520002
    SHELTON, Richard Dominic
    Homer Road
    B91 3QJ Solihull
    51
    West Midlands
    Administrateur
    Homer Road
    B91 3QJ Solihull
    51
    West Midlands
    EnglandBritishSolicitor79139430001
    HALL, Penelope Jane Rosemary
    242 Yardley Wood Road
    Moseley
    B13 9JN Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    242 Yardley Wood Road
    Moseley
    B13 9JN Birmingham
    West Midlands
    British705950001
    SHELTON, Richard Dominic
    12 Campion Grove
    B63 1HB Halesowen
    West Midlands
    Secrétaire
    12 Campion Grove
    B63 1HB Halesowen
    West Midlands
    FritishSolicitor31065230001
    BINGHAM, Roy Neil
    29 Baalmoral Way
    SM2 6PD Belmont
    Surrey
    Administrateur
    29 Baalmoral Way
    SM2 6PD Belmont
    Surrey
    BritishDivisional Director36546250001
    FAIRRIE, James Patrick Johnston
    5 Templars Crescent
    Finchley
    N3 3QR London
    Administrateur
    5 Templars Crescent
    Finchley
    N3 3QR London
    BritishCompany Director45091610001
    MEHMET, Adem
    EN2
    Administrateur
    EN2
    United KingdomBritishDirector85573720002
    RAIKES, Anthony Francis
    Pond House
    High Street
    TN5 6AA Wadhurst
    East Sussex
    Administrateur
    Pond House
    High Street
    TN5 6AA Wadhurst
    East Sussex
    BritishDirector74100440004
    RAIKES, Anthony Francis
    St Catherine's Court
    Herbert Road
    B91 3QE Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    St Catherine's Court
    Herbert Road
    B91 3QE Solihull
    West Midlands
    BritishDirector74100440002
    READ, Brian John
    The Gatehouse 117 Silverdale Avenue
    KT12 1EQ Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    The Gatehouse 117 Silverdale Avenue
    KT12 1EQ Walton On Thames
    Surrey
    EnglandBritishDirector3042230001
    SAFFERY, John Robert
    St Catherines Court
    Herbert Road
    B913QEE Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    St Catherines Court
    Herbert Road
    B913QEE Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Accountant2013700002
    TERRINGTON, Nigel Stewart
    St Catherine's Court
    Herbert Road
    B91 3QE Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    St Catherine's Court
    Herbert Road
    B91 3QE Solihull
    West Midlands
    BritishFinance Director33299100002

    PARAGON MORTGAGES (NO. 3) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A deed of sub-charge and assignment
    Créé le 27 avr. 2001
    Livré le 04 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The company covenants with and undertakes to the trustee that it will duly and punctually pay or discharge all monies and liabilities whatsoever which from time to time become due owing or payable by the company a) to or to the order of the trustee and/or any receiver under the deed of sub-charge and assignment the trust deed and the conditions at the times and in the manner provided in the deed of sub-charge and assignment or therein b) under or in respect of the notes and c) to the trustee on any account whatsoever whether as principal or surety and whether or not jointly with another
    Brèves mentions
    All right title interest and benefit in and under the english PM3 mortgages (whether pursuant to the UK mortgage sale agreement the luxembourg mortgage sale agreement or the exercise of the luxembourg call option). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citicorp Trustee Company Limited (As Trustee Which Expression Shall Withoutlimiting Clause 1.2 of the Deed of Sub-Charge and Assignment Include Such Company and All Otherpersons or Companies for the Time Being Acting as Trustee or Trustees Under the Trust Deed)
    Transactions
    • 04 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of charge & assignment
    Créé le 31 mai 1991
    Livré le 12 juin 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed of charge and the trust deed.
    Brèves mentions
    (1) all right, title interest & benefit of the mortgagor existing and the date of the deed of charge or in the future in the class A3 notes (2) all right, title benefit under the CM59 deed of charge as holder of the CM59 frn'S. By way of first floating charge the whole of the undertaking property & assets. (See form 395 ref M291C for full details).
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C."the Trustee" (As Defined)
    Transactions
    • 12 juin 1991Enregistrement d'une charge
    • 11 juin 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0