PARAGON MORTGAGES (NO. 3) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | PARAGON MORTGAGES (NO. 3) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02231301 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PARAGON MORTGAGES (NO. 3) LIMITED ?
Adresse du siège social | 51 Homer Road B91 3QJ Solihull West Midlands |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PARAGON MORTGAGES (NO. 3) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour PARAGON MORTGAGES (NO. 3) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de St Catherine's Court Herbert Road Solihull West Midlands B91 3QE le 07 déc. 2012 | 2 pages | AD01 | ||||||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2011 | 10 pages | AA | ||||||||||||||
État du capital au 08 juin 2012
| 4 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 27 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré | 1 pages | AD03 | ||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée | 1 pages | AD02 | ||||||||||||||
Certificat de réimmatriculation de société anonyme à responsabilité limitée | 1 pages | CERT10 | ||||||||||||||
Réenregistrement des statuts | 27 pages | MAR | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Re-enregistrement d'une société publique en société à responsabilité limitée privée | 2 pages | RR02 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2010 | 10 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Richard Dominic Shelton le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Keen le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Grigor Gemmell le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr John Grigor Gemmell le 01 oct. 2009 | 1 pages | CH03 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Adem Mehmet en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de PARAGON MORTGAGES (NO. 3) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMMELL, John Grigor | Secrétaire | Homer Road B91 3QJ Solihull 51 West Midlands | British | Accountant | 84111440004 | |||||
GEMMELL, John Grigor | Administrateur | Homer Road B91 3QJ Solihull 51 West Midlands | United Kingdom | British | Group Company Secretary | 84111440004 | ||||
KEEN, Nicholas | Administrateur | Homer Road B91 3QJ Solihull 51 West Midlands | United Kingdom | British | Director | 85330520002 | ||||
SHELTON, Richard Dominic | Administrateur | Homer Road B91 3QJ Solihull 51 West Midlands | England | British | Solicitor | 79139430001 | ||||
HALL, Penelope Jane Rosemary | Secrétaire | 242 Yardley Wood Road Moseley B13 9JN Birmingham West Midlands | British | 705950001 | ||||||
SHELTON, Richard Dominic | Secrétaire | 12 Campion Grove B63 1HB Halesowen West Midlands | Fritish | Solicitor | 31065230001 | |||||
BINGHAM, Roy Neil | Administrateur | 29 Baalmoral Way SM2 6PD Belmont Surrey | British | Divisional Director | 36546250001 | |||||
FAIRRIE, James Patrick Johnston | Administrateur | 5 Templars Crescent Finchley N3 3QR London | British | Company Director | 45091610001 | |||||
MEHMET, Adem | Administrateur | EN2 | United Kingdom | British | Director | 85573720002 | ||||
RAIKES, Anthony Francis | Administrateur | Pond House High Street TN5 6AA Wadhurst East Sussex | British | Director | 74100440004 | |||||
RAIKES, Anthony Francis | Administrateur | St Catherine's Court Herbert Road B91 3QE Solihull West Midlands | British | Director | 74100440002 | |||||
READ, Brian John | Administrateur | The Gatehouse 117 Silverdale Avenue KT12 1EQ Walton On Thames Surrey | England | British | Director | 3042230001 | ||||
SAFFERY, John Robert | Administrateur | St Catherines Court Herbert Road B913QEE Solihull West Midlands | British | Chartered Accountant | 2013700002 | |||||
TERRINGTON, Nigel Stewart | Administrateur | St Catherine's Court Herbert Road B91 3QE Solihull West Midlands | British | Finance Director | 33299100002 |
PARAGON MORTGAGES (NO. 3) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A deed of sub-charge and assignment | Créé le 27 avr. 2001 Livré le 04 mai 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti The company covenants with and undertakes to the trustee that it will duly and punctually pay or discharge all monies and liabilities whatsoever which from time to time become due owing or payable by the company a) to or to the order of the trustee and/or any receiver under the deed of sub-charge and assignment the trust deed and the conditions at the times and in the manner provided in the deed of sub-charge and assignment or therein b) under or in respect of the notes and c) to the trustee on any account whatsoever whether as principal or surety and whether or not jointly with another | |
Brèves mentions All right title interest and benefit in and under the english PM3 mortgages (whether pursuant to the UK mortgage sale agreement the luxembourg mortgage sale agreement or the exercise of the luxembourg call option). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of charge & assignment | Créé le 31 mai 1991 Livré le 12 juin 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed of charge and the trust deed. | |
Brèves mentions (1) all right, title interest & benefit of the mortgagor existing and the date of the deed of charge or in the future in the class A3 notes (2) all right, title benefit under the CM59 deed of charge as holder of the CM59 frn'S. By way of first floating charge the whole of the undertaking property & assets. (See form 395 ref M291C for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0