REFRESCO (NELSON) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREFRESCO (NELSON) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02234044
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REFRESCO (NELSON) LIMITED ?

    • Fabrication de boissons non alcoolisées; production d'eaux minérales et d'autres eaux en bouteille (11070) / Industries manufacturières

    Où se situe REFRESCO (NELSON) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de REFRESCO (NELSON) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    COTT (NELSON) LIMITED25 mai 200625 mai 2006
    MACAW (SOFT DRINKS) LIMITED26 févr. 199026 févr. 1990
    SANDING LIMITED22 mars 198822 mars 1988

    Quels sont les derniers comptes de REFRESCO (NELSON) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour REFRESCO (NELSON) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01
    XAZKL5OI

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    1 pagesAA
    AAXX9B00

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    1 pagesAA
    AAXX966W

    Déclaration de confirmation établie le 14 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XA9AOFO0

    Nomination de Mr Jan Abraham Pienaar en tant qu'administrateur le 16 févr. 2021

    2 pagesAP01
    X9YJ1YE3

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    1 pagesAA
    A9KDC23L

    Déclaration de confirmation établie le 14 juil. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01
    X99EOW2G

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    1 pagesAA
    A8F6F2MP

    Déclaration de confirmation établie le 14 juil. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X89Q4ONF

    Comptes pour une société dormante établis au 30 déc. 2017

    1 pagesAA
    A7FF72OY

    Déclaration de confirmation établie le 14 juil. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01
    X7AJQV0Q

    Modification des détails de Cott Nelson (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 avr. 2018

    2 pagesPSC05
    X7AJPJZD

    Nomination de David Saint en tant qu'administrateur le 18 juin 2018

    2 pagesAP01
    X78GVE9M

    Cessation de la nomination de Matthew James Vernon en tant que directeur le 18 juin 2018

    1 pagesTM01
    X78GVFBC

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name22 mai 2018

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15
    X76IHBG8

    Cessation de la nomination de Claire Duffy en tant que directeur le 30 janv. 2018

    1 pagesTM01
    X6ZC7M22

    Cessation de la nomination de Steven Kitching en tant que directeur le 30 janv. 2018

    1 pagesTM01
    X6ZC7MHK

    Cessation de la nomination de Jason Robert Ausher en tant que directeur le 30 janv. 2018

    1 pagesTM01
    X6ZC7H4B

    Satisfaction de la charge 18 en totalité

    1 pagesMR04
    X6YRNIYI

    Satisfaction de la charge 022340440019 en totalité

    1 pagesMR04
    X6YRNNL6

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jason Robert Ausher le 12 déc. 2017

    2 pagesCH01
    X6L5PORV

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    1 pagesAA
    A6FXSQKI

    Déclaration de confirmation établie le 14 juil. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X6AW62LL

    Qui sont les dirigeants de REFRESCO (NELSON) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SQUIRE PATTON BOGGS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Rutland House
    West Midlands
    United Kingdom
    Secrétaire
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Rutland House
    West Midlands
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement2911328
    73037780028
    PIENAAR, Jan Abraham
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Administrateur
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    EnglandDutchFinance Director265177850001
    SAINT, David John
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Administrateur
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    United KingdomBritishManaging Director84921030001
    CLAYTON, Arthur John Howard
    Lone Wood Ladderbanks Lane
    Baildon
    BD17 6RX Shipley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Lone Wood Ladderbanks Lane
    Baildon
    BD17 6RX Shipley
    West Yorkshire
    British7552130001
    FOSTER, George Jonathan
    36 Castlefields
    Rothwell
    LS26 0GN Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    36 Castlefields
    Rothwell
    LS26 0GN Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector51419380003
    MAIN, David Robert
    1 The Courtyard
    Farm Lane
    CV22 6NL Easenhall
    Warwickshire
    Secrétaire
    1 The Courtyard
    Farm Lane
    CV22 6NL Easenhall
    Warwickshire
    BritishDirector Secretary76779080003
    SHORT, Mark Andrew
    Highcliffe Long Lane
    Southowram
    HX3 9UD Halifax
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Highcliffe Long Lane
    Southowram
    HX3 9UD Halifax
    West Yorkshire
    British36567240002
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Secrétaire
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    67382580003
    HAMMONDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    73037780002
    AUSHER, Jason Robert
    Corporate Center Iii At International Plaza
    Suite 400, 4221 W. Boy Scout Blvd.
    Tampa
    Cott Corporation
    Florida
    Usa
    Administrateur
    Corporate Center Iii At International Plaza
    Suite 400, 4221 W. Boy Scout Blvd.
    Tampa
    Cott Corporation
    Florida
    Usa
    United StatesAmericanDirector188769770002
    BOARD, John Robert
    12 Chaigley Court
    Chaigley
    BB7 3ND Clitheroe
    Lancashire
    Administrateur
    12 Chaigley Court
    Chaigley
    BB7 3ND Clitheroe
    Lancashire
    BritishCompany Director93836050001
    BRENNAN, Catherine Marie Helen
    Sunnylea Avenue East Toronto
    Ontario
    M87 2k5
    63
    Canada
    Administrateur
    Sunnylea Avenue East Toronto
    Ontario
    M87 2k5
    63
    Canada
    CanadianCorporate Treasurer133301470001
    CAWTHRAY, Andrew James
    Meadow Bank Farm Daleside Park
    HG3 2PX Darley
    North Yorkshire
    Administrateur
    Meadow Bank Farm Daleside Park
    HG3 2PX Darley
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director29428920003
    CLAYTON, Arthur John Howard
    Lone Wood Ladderbanks Lane
    Baildon
    BD17 6RX Shipley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Lone Wood Ladderbanks Lane
    Baildon
    BD17 6RX Shipley
    West Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant7552130001
    CORBY, Stephen
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Administrateur
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    EnglandBritishManaging Director176624850001
    DUFFY, Claire
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Administrateur
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    EnglandBritishSolicitor223323570001
    FOSTER, George Jonathan
    36 Castlefields
    Rothwell
    LS26 0GN Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    36 Castlefields
    Rothwell
    LS26 0GN Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director51419380003
    FOWDEN, Jeremy Stephen Gary
    The Paddocks 33 Twyford Road
    Barrow On Trent
    DE73 7HA Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    The Paddocks 33 Twyford Road
    Barrow On Trent
    DE73 7HA Derby
    Derbyshire
    BritishDirector125265950001
    HOYLE, Jeremy Stephen
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Administrateur
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    EnglandBritishDirector153317170002
    JOYNSON, Andrew Douglas Stuart
    Farm
    Southam Road Napton On The Hill
    CV47 8NG Southam
    Red House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Farm
    Southam Road Napton On The Hill
    CV47 8NG Southam
    Red House
    Warwickshire
    United Kingdom
    BritishOperations Director133301820001
    KITCHING, Steven
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Administrateur
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    United KingdomBritishDirector223323760001
    KITCHING, Steven
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Administrateur
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    United KingdomBritishManaging Director133273740001
    LEITER, Gregory
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Administrateur
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    UsaUnited StatesCorporate Controller140195590001
    LLOYD-DAVIES, Joanne
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Administrateur
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    EnglandBritishSolicitor176624840002
    MAIN, David Robert
    1 The Courtyard
    Farm Lane
    CV22 6NL Easenhall
    Warwickshire
    Administrateur
    1 The Courtyard
    Farm Lane
    CV22 6NL Easenhall
    Warwickshire
    BritishDirector Secretary76779080003
    MARTIN, Paul John
    Ash Ghyll
    Bromley Road
    BD16 4DA Bingley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Ash Ghyll
    Bromley Road
    BD16 4DA Bingley
    West Yorkshire
    BritishCompany Director70618780003
    MASON, Robert Andrew
    22 Howe Drive
    HP9 2BG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    22 Howe Drive
    HP9 2BG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishFinance Director40909900001
    MURFIN, Andrew James
    48 Hawthorne Way
    Shelley
    HD8 8JX Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    48 Hawthorne Way
    Shelley
    HD8 8JX Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector68921430001
    PRESLAR, B Clyde
    11913 Marblehead Drive
    FOREIGN Tampa
    Florida
    33626
    Administrateur
    11913 Marblehead Drive
    FOREIGN Tampa
    Florida
    33626
    AmericanChief Financial Officer114826450001
    ROSE, Martyn Craig
    39a Limerston Street
    SW10 0BQ London
    Administrateur
    39a Limerston Street
    SW10 0BQ London
    BritishCompany Director75808040001
    TURNER, Michael John
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Administrateur
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    United KingdomBritishTechnical Director121920530001
    VERNON, Matthew James
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Administrateur
    Citrus Grove
    Sideley Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    EnglandBritishDirector203388960001
    WALKER, Colin
    175 Meridene Crescent
    London
    Ontario N5x 1g3
    Canada
    Administrateur
    175 Meridene Crescent
    London
    Ontario N5x 1g3
    Canada
    CanadianSenior Vice President115337890001
    WHITLEY, Nicholas Edward
    14 Milton Road
    DE65 6FZ Repton
    Derbyshire
    Administrateur
    14 Milton Road
    DE65 6FZ Repton
    Derbyshire
    United KingdomBritishDirector170576580001
    WILLARD, Wynn A
    1097 Eden Isle Drive Ne
    FOREIGN St. Petersburg
    Florida 33704
    Usa
    Administrateur
    1097 Eden Isle Drive Ne
    FOREIGN St. Petersburg
    Florida 33704
    Usa
    UsaExecutive117606010001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur REFRESCO (NELSON) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Refresco Nelson (Holdings) Limited
    Sideley
    Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Citrus Grove
    England
    06 avr. 2016
    Sideley
    Kegworth
    DE74 2FJ Derby
    Citrus Grove
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales Registry
    Numéro d'enregistrement3464429
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.

    REFRESCO (NELSON) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 03 août 2016
    Livré le 12 août 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Trademark "sunvill" with registration number 580919. trademark "sunquen" with registration number 735064. see instrument for further details.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Jpmorgan Chase Bank, N.A., London Branch
    Transactions
    • 12 août 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 31 janv. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 17 août 2010
    Livré le 23 août 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jpmorgan Chase Bank, N.A., London Branch (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 23 août 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 31 janv. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 31 mars 2008
    Livré le 03 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the loan parties to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jpmorgan Chase Bank N.A. as the Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 03 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 10 août 2005
    Livré le 19 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the canadian borrower or any of its subsidiaries to the secured parties and all monies due or to become due from any borrower to any person that is a lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wachovia Bank, National Association Acting Through Its London Branch
    Transactions
    • 19 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 mai 2002
    Livré le 08 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at lomeshaye industrial estae nelson lancashire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 août 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 14 juin 2001
    Livré le 22 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land & buildings north west side of lindred road nelson lancashire t/no.LA654819. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 août 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 14 juin 2001
    Livré le 22 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 août 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 14 juin 2001
    Livré le 22 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H and l/h property k/a land & buildings on the south/ south east side of lindred road nelson lancashire. T/no. LA691938, LA78838, LA872068 & LA872069. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 août 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 juil. 2000
    Livré le 01 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H plot of land situate at lomeshaye industrial estate nelson lancs t/no.LA586821. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 11 juin 1998
    Livré le 16 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 11 juin 1998
    Livré le 16 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All its right title and interest in the policy NO23194-092-das.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 juin 1998
    Livré le 16 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a lindred road nelson lancashire-LA69193 & LA788384. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 22 oct. 1996
    Livré le 28 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a premises at roseway lomeshaye industrial estate nelson lancashire and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 30 janv. 1992
    Livré le 04 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/orthe proceeds of sale thereof, fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts andthe benefits of any licences legal mortgage and/or the proceeds of sale on l/h property k/a roseway lomeshaye industrial estate nelson t/n la 6577709.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 janv. 1992
    Livré le 04 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H premises in roseway lomeshaye industrial estate nelson t/n la 657709 and/or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second legal charge
    Créé le 03 sept. 1990
    Livré le 07 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease contract and master leasing agreement dated 3/9/90
    Brèves mentions
    The land and buildings together with all plant, fixtures (including tennant's and trade fixtures) and all machinery, fittings and equipment from time to time thereon being the land and buildings now known as 7 roseway situated at lindred road, lomeshaye industrial estate, nelson, lancashire.
    Personnes ayant droit
    • The Cca Partnership
    Transactions
    • 07 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 11 oct. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 août 1990
    Livré le 12 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that of land having an area of three point eight six acres of thereabouts at lindred road nelson lancashire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 11 oct. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 mai 1990
    Livré le 06 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 11 oct. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 21 mai 1990
    Livré le 07 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Building agreement dated 9/4/90 relating to land at lindred road, nelson, lancashire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 11 oct. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0