EHPR LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEHPR LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02234290
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EHPR LTD ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe EHPR LTD ?

    Adresse du siège social
    8th Floor, Holborn Gate,
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EHPR LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ELIZABETH HINDMARCH PUBLIC RELATIONS LIMITED08 févr. 199308 févr. 1993
    GULF STREAM OFFICE RELOCATION PROJECTS LIMITED04 août 198804 août 1988
    STARULL LIMITED23 mars 198823 mars 1988

    Quels sont les derniers comptes de EHPR LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour EHPR LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    7 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 3rd Floor, 3 London Wall Buildings London Wall London EC2M 5SY à 8th Floor, Holborn Gate, 26 Southampton Buildings London WC2A 1AN le 27 juil. 2016

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Neil Garth Jones en tant qu'administrateur le 01 juil. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Rebecca Adele Horne en tant que directeur le 01 juil. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 oct. 2015

    État du capital au 19 oct. 2015

    • Capital: GBP 3,000
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de 3 London Wall Buildings London EC2M 5SY England à 3rd Floor, 3 London Wall Buildings London Wall London EC2M 5SY le 19 oct. 2015

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    2 pagesAA

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Nomination de Mrs Rebecca Adele Horne en tant qu'administrateur le 01 juil. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Alison Jane Clarke en tant que directeur le 14 juin 2015

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 15-17 Huntsworth Mews London NW1 6DD à 3 London Wall Buildings London EC2M 5SY le 28 juin 2015

    1 pagesAD01

    Nomination de Ms Alison Jane Clarke en tant qu'administrateur le 31 déc. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Sally-Ann Patricia Withey en tant que directeur le 31 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 oct. 2014

    État du capital au 08 oct. 2014

    • Capital: GBP 3,000
    SH01

    Qui sont les dirigeants de EHPR LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JONES, Neil Garth
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate,
    England
    Administrateur
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate,
    England
    EnglandBritishFinance Director204774750001
    MORROW, Martin
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate,
    England
    Administrateur
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate,
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant167225950001
    GUTHRIE, Elizabeth Freda
    Nine Pins Pearson Road
    Sonning
    RG4 6UH Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    Nine Pins Pearson Road
    Sonning
    RG4 6UH Reading
    Berkshire
    BritishPublic Relations Consultant29200280001
    HATFIELD, Adam George Roland
    Old Berkeley Cottage
    Common Road
    WD3 5LW Chorleywood
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Old Berkeley Cottage
    Common Road
    WD3 5LW Chorleywood
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant84503340001
    JAMES, Jonathan Harry
    7 Hillcrest View
    BR3 3EH Beckenham
    Kent
    Secrétaire
    7 Hillcrest View
    BR3 3EH Beckenham
    Kent
    British22414890001
    LEES, Jennifer Kathryn
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    Secrétaire
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    British24587010002
    WHITE, Jeremy Mark
    14 Parkway
    Ratton
    BN20 9DX Eastbourne
    Sussex
    Secrétaire
    14 Parkway
    Ratton
    BN20 9DX Eastbourne
    Sussex
    BritishChartered Accountant51297980001
    ADAMS, Colin Raymond
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    Administrateur
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    EnglandBritishFinance Director39245820011
    BROADHEAD, Tymon Piers
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    Administrateur
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    EnglandBritishAccountant105342600002
    CARTER, Neil Booker
    The Old Vicarage
    Towersey
    OX9 3QW Thame
    Oxon
    Administrateur
    The Old Vicarage
    Towersey
    OX9 3QW Thame
    Oxon
    British22414900001
    CLARKE, Alison Jane
    London Wall Buildings
    EC2M 5SY London
    3
    England
    Administrateur
    London Wall Buildings
    EC2M 5SY London
    3
    England
    United KingdomBritishCompany Director93418210001
    CLARKE, Alison Jane
    5 Lyford Road
    SW18 3LU London
    Administrateur
    5 Lyford Road
    SW18 3LU London
    United KingdomBritishPr Consultant93418210001
    FLOWER, Jennie
    40 Stanley Hill
    HP7 9HL Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    40 Stanley Hill
    HP7 9HL Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishAccountant79244890002
    GUTHRIE, Barton Keith
    Nine Pins Pearson Road
    Sonning
    RG4 6UH Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Nine Pins Pearson Road
    Sonning
    RG4 6UH Reading
    Berkshire
    United KingdomAustralian22414910001
    GUTHRIE, Elizabeth Freda
    Nine Pins Pearson Road
    Sonning
    RG4 6UH Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Nine Pins Pearson Road
    Sonning
    RG4 6UH Reading
    Berkshire
    BritishPublic Relations Consultant29200280001
    HORNE, Rebecca Adele
    London Wall Buildings
    London Wall
    EC2M 5SY London
    3rd Floor, 3
    England
    Administrateur
    London Wall Buildings
    London Wall
    EC2M 5SY London
    3rd Floor, 3
    England
    United KingdomBritishAccountant188956200001
    JAMES, Jonathan Harry
    7 Hillcrest View
    BR3 3EH Beckenham
    Kent
    Administrateur
    7 Hillcrest View
    BR3 3EH Beckenham
    Kent
    British22414890001
    MCCULLOCH, Diane
    34 Duke Street
    SL4 1SA Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    34 Duke Street
    SL4 1SA Windsor
    Berkshire
    BritishManaging Director100038240002
    MOLE, Sarah
    14 Thorne Passage
    Barnes
    SW13 0PA London
    Administrateur
    14 Thorne Passage
    Barnes
    SW13 0PA London
    BritishManaging Director109166650001
    SELMAN, Roger Malcolm
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    Administrateur
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    United KingdomBritishFinance Director10691510002
    WITHEY, Sally-Ann Patricia
    Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    15-17
    Administrateur
    Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    15-17
    EnglandBritishGroup Finance Director109428260052

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EHPR LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Huntsworth Plc
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    06 avr. 2016
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Liability Company
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006 (As Amended)
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement1729478
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    EHPR LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off
    Créé le 19 avr. 2010
    Livré le 22 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 22 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 28 mars 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 27 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (27 july 2007)
    Créé le 06 avr. 2010
    Livré le 07 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 07 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 28 mars 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 27 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 27TH july 2007 and
    Créé le 27 oct. 2009
    Livré le 07 nov. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 07 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 28 mars 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 27 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off
    Créé le 22 sept. 2008
    Livré le 11 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the companies or any of them to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 27 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 27 july 2007 and
    Créé le 25 sept. 2007
    Livré le 02 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any one or more of the subsidiaries to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 02 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 27 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18 october 2004 and
    Créé le 24 avr. 2007
    Livré le 15 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 15 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 and
    Créé le 21 déc. 2006
    Livré le 03 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 03 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004
    Créé le 16 oct. 2006
    Livré le 20 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 20 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 and
    Créé le 12 août 2005
    Livré le 26 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 26 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18 october 2004 and
    Créé le 27 juil. 2005
    Livré le 04 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 04 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    An omnibus letter of set-off
    Créé le 18 oct. 2004
    Livré le 19 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any su or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank, either in sterling or any other currency.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of admission to an onmibus letter of set-off dated 13 july 2001
    Créé le 18 mai 2004
    Livré le 21 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any accounts of the companies or any of them.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 21 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0