ROVARD FACILITIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéROVARD FACILITIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02235222
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ROVARD FACILITIES LIMITED ?

    • Location de voitures et de véhicules légers (77110) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe ROVARD FACILITIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    James House
    55 Welford Road
    LE2 7AR Leicester
    Leicestershire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ROVARD FACILITIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DRYWOOD LIMITED24 mars 198824 mars 1988

    Quels sont les derniers comptes de ROVARD FACILITIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour ROVARD FACILITIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    7 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 30 juil. 2012

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Steven Mark Johnson en tant que directeur le 02 avr. 2012

    2 pagesTM01

    Nomination de Mr Gary Neil Smith en tant qu'administrateur le 02 avr. 2012

    3 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jane Colton en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Kenneth Stanley Mccall en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Cotterill en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Jane Margaret Colton le 01 oct. 2009

    3 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Steven Mark Johnson le 01 oct. 2009

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mark John Cotterill le 01 oct. 2009

    3 pagesCH01

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    5 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de ROVARD FACILITIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCCALL, Kenneth Stanley
    Aldenham Road
    WD23 2QQ Bushey
    77-85
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Aldenham Road
    WD23 2QQ Bushey
    77-85
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish156180730001
    SMITH, Gary Neil
    55 Welford Road
    LE2 7AR Leicester
    James House
    Leicestershire
    Administrateur
    55 Welford Road
    LE2 7AR Leicester
    James House
    Leicestershire
    EnglandBritish157695700001
    BARNES, John Charlton
    Pinehurst Felcourt Road
    Felcourt
    RH19 2LA East Grinstead
    West Sussex
    Secrétaire
    Pinehurst Felcourt Road
    Felcourt
    RH19 2LA East Grinstead
    West Sussex
    British2951340001
    BATCHELOR, Paul William Richard
    32 Hazelton Road
    Marlbrook
    B61 0JE Bromsgrove
    Worcestershire
    Secrétaire
    32 Hazelton Road
    Marlbrook
    B61 0JE Bromsgrove
    Worcestershire
    British29542990001
    COLTON, Jane Margaret
    55 Welford Road
    LE2 7AR Leicester
    James House
    Leicestershire
    England
    Secrétaire
    55 Welford Road
    LE2 7AR Leicester
    James House
    Leicestershire
    England
    British35540850004
    EVANS, Margaret Janet
    17 Coniston Way
    RH2 0LN Reigate
    Surrey
    Secrétaire
    17 Coniston Way
    RH2 0LN Reigate
    Surrey
    British2289880001
    HEWITSON, Anthony James
    149 Maney Hill Road
    B72 1JW Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    149 Maney Hill Road
    B72 1JW Sutton Coldfield
    West Midlands
    British79407560001
    PALMER, Helen Elizabeth
    22 Croftdown Road
    B17 8RB Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    22 Croftdown Road
    B17 8RB Birmingham
    West Midlands
    British69052940001
    SAYWARD, Glenn Martin
    32 Waverley Road
    NG18 5AG Mansfield
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    32 Waverley Road
    NG18 5AG Mansfield
    Nottinghamshire
    British41017820001
    MABLAW CORPORATE SERVICES LIMITED
    21 Station Road
    WD17 1HT Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    21 Station Road
    WD17 1HT Watford
    Hertfordshire
    52303360001
    BARRY, Marie, Mrs.
    Englewood
    7 Bletchley Road
    LU7 0ER Stewkley
    Bucks
    Administrateur
    Englewood
    7 Bletchley Road
    LU7 0ER Stewkley
    Bucks
    United KingdomIrish123866570002
    BATCHELOR, Paul William Richard
    32 Hazelton Road
    Marlbrook
    B61 0JE Bromsgrove
    Worcestershire
    Administrateur
    32 Hazelton Road
    Marlbrook
    B61 0JE Bromsgrove
    Worcestershire
    British29542990001
    BATCHELOR, Paul William Richard
    32 Hazelton Road
    Marlbrook
    B61 0JE Bromsgrove
    Worcestershire
    Administrateur
    32 Hazelton Road
    Marlbrook
    B61 0JE Bromsgrove
    Worcestershire
    British29542990001
    BAUNACK, Albert Wilhelm Uwe
    15 Rue Marcel Ballasse
    Margny-Les-Compiegne
    FOREIGN France
    Administrateur
    15 Rue Marcel Ballasse
    Margny-Les-Compiegne
    FOREIGN France
    German48909040001
    COTTERILL, Mark John
    Aldenham Road
    WD23 2QQ Bushey
    Europcar House
    Watford
    England
    Administrateur
    Aldenham Road
    WD23 2QQ Bushey
    Europcar House
    Watford
    England
    United KingdomBritish126885690001
    DEPOIS, Thierry
    4bis Rue Revert
    95300 Pontoise
    FOREIGN France
    Administrateur
    4bis Rue Revert
    95300 Pontoise
    FOREIGN France
    French54853950001
    DU MONCEAU DE BERGENDAL, John Maurice Gabriel
    9 Rue Victor Hugo
    Jouy-En-Josas
    Les Yvelines 78000
    France
    Administrateur
    9 Rue Victor Hugo
    Jouy-En-Josas
    Les Yvelines 78000
    France
    French46710400001
    FITCH, John Derek
    Douglas Cottage
    Coombe End
    KT2 7DQ Kingston
    Surrey
    Administrateur
    Douglas Cottage
    Coombe End
    KT2 7DQ Kingston
    Surrey
    British8461210001
    FLEMING, Paul Scott
    Apartment 244 Royal Drive
    Princess Park Manor
    N11 3FT London
    Administrateur
    Apartment 244 Royal Drive
    Princess Park Manor
    N11 3FT London
    British73871570003
    JOHNSON, Steven Mark
    Aldenham Road
    WD23 2QQ Bushey
    Europcar House
    Watford
    England
    Administrateur
    Aldenham Road
    WD23 2QQ Bushey
    Europcar House
    Watford
    England
    United KingdomBritish137622810001
    KERN, Michael, Dr
    Auestrasse 90
    52382 Niederzier
    Germany
    Administrateur
    Auestrasse 90
    52382 Niederzier
    Germany
    British70370910001
    KING SMITH, Terence Peter
    The Field House
    Snowshill
    WR12 7JT Broadway
    Worcestershire
    Administrateur
    The Field House
    Snowshill
    WR12 7JT Broadway
    Worcestershire
    British30203050001
    LEIGH, John Simon
    Priory House
    Priory Road
    SL5 9RQ Sunningdale
    Berkshire
    Administrateur
    Priory House
    Priory Road
    SL5 9RQ Sunningdale
    Berkshire
    United KingdomBritish119920050001
    MASAI, Pierre Jean Andre
    Avenue De L Opale 73
    FOREIGN Brussels
    1030
    Belgium
    Administrateur
    Avenue De L Opale 73
    FOREIGN Brussels
    1030
    Belgium
    Belgian76994760001
    NEVILLE, Robert Stanley
    Borrowell Borrowell Lane
    CV8 1ER Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    Borrowell Borrowell Lane
    CV8 1ER Kenilworth
    Warwickshire
    British8259110001
    NEVILLE, Robert Stanley
    Borrowell Borrowell Lane
    CV8 1ER Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    Borrowell Borrowell Lane
    CV8 1ER Kenilworth
    Warwickshire
    British8259110001
    NOACK, Gerhard
    2 Avenue Octave
    FOREIGN Greard
    75007 Paris
    France
    Administrateur
    2 Avenue Octave
    FOREIGN Greard
    75007 Paris
    France
    German71949080001
    OSTROWSKI, Stefan
    20 Avenue Thery
    92420 Vaucresson
    France
    Administrateur
    20 Avenue Thery
    92420 Vaucresson
    France
    German85010670001
    PALMER, Helen Elizabeth
    22 Croftdown Road
    B17 8RB Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    22 Croftdown Road
    B17 8RB Birmingham
    West Midlands
    British69052940001
    RAFAEL, Girona
    8 Rue Roger Bacon
    75017 Paris
    Paris
    France
    Administrateur
    8 Rue Roger Bacon
    75017 Paris
    Paris
    France
    FranceSpanish76995130003
    ROSE, Harry Anthony
    The Old School House
    Old School Lane Lighthorne
    CV35 0AX Warwick
    Administrateur
    The Old School House
    Old School Lane Lighthorne
    CV35 0AX Warwick
    British27476440003
    SAYWARD, Glenn Martin
    32 Waverley Road
    NG18 5AG Mansfield
    Nottinghamshire
    Administrateur
    32 Waverley Road
    NG18 5AG Mansfield
    Nottinghamshire
    British41017820001
    SLADE, Arthur Geoffrey
    Field House
    Horsham Road
    BN44 3AE Steyning
    West Sussex
    Administrateur
    Field House
    Horsham Road
    BN44 3AE Steyning
    West Sussex
    British72709160001
    SMITH, John Stephen
    The Coach House
    26 Kenilworth Road
    CV32 6JB Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    The Coach House
    26 Kenilworth Road
    CV32 6JB Leamington Spa
    Warwickshire
    British8259150002
    WOODHOUSE, John Graham
    The Lake House
    Breach Lane
    CV35 8QB Claverdon
    Warwickshire
    Administrateur
    The Lake House
    Breach Lane
    CV35 8QB Claverdon
    Warwickshire
    British4882030002

    ROVARD FACILITIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 15 juin 1994
    Livré le 22 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 1212 stockport road levenshulme manchester t/n LA266831 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 15 juin 1994
    Livré le 22 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 févr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0