ROVARD FACILITIES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ROVARD FACILITIES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02235222 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ROVARD FACILITIES LIMITED ?
| Adresse du siège social | James House 55 Welford Road LE2 7AR Leicester Leicestershire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ROVARD FACILITIES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour ROVARD FACILITIES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 7 pages | AA | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
État du capital au 30 juil. 2012
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Steven Mark Johnson en tant que directeur le 02 avr. 2012 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Gary Neil Smith en tant qu'administrateur le 02 avr. 2012 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 7 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jane Colton en tant que secrétaire | 2 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Kenneth Stanley Mccall en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Cotterill en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Jane Margaret Colton le 01 oct. 2009 | 3 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Steven Mark Johnson le 01 oct. 2009 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mark John Cotterill le 01 oct. 2009 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2008 | 5 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ROVARD FACILITIES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCCALL, Kenneth Stanley | Administrateur | Aldenham Road WD23 2QQ Bushey 77-85 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 156180730001 | |||||
| SMITH, Gary Neil | Administrateur | 55 Welford Road LE2 7AR Leicester James House Leicestershire | England | British | 157695700001 | |||||
| BARNES, John Charlton | Secrétaire | Pinehurst Felcourt Road Felcourt RH19 2LA East Grinstead West Sussex | British | 2951340001 | ||||||
| BATCHELOR, Paul William Richard | Secrétaire | 32 Hazelton Road Marlbrook B61 0JE Bromsgrove Worcestershire | British | 29542990001 | ||||||
| COLTON, Jane Margaret | Secrétaire | 55 Welford Road LE2 7AR Leicester James House Leicestershire England | British | 35540850004 | ||||||
| EVANS, Margaret Janet | Secrétaire | 17 Coniston Way RH2 0LN Reigate Surrey | British | 2289880001 | ||||||
| HEWITSON, Anthony James | Secrétaire | 149 Maney Hill Road B72 1JW Sutton Coldfield West Midlands | British | 79407560001 | ||||||
| PALMER, Helen Elizabeth | Secrétaire | 22 Croftdown Road B17 8RB Birmingham West Midlands | British | 69052940001 | ||||||
| SAYWARD, Glenn Martin | Secrétaire | 32 Waverley Road NG18 5AG Mansfield Nottinghamshire | British | 41017820001 | ||||||
| MABLAW CORPORATE SERVICES LIMITED | Secrétaire | 21 Station Road WD17 1HT Watford Hertfordshire | 52303360001 | |||||||
| BARRY, Marie, Mrs. | Administrateur | Englewood 7 Bletchley Road LU7 0ER Stewkley Bucks | United Kingdom | Irish | 123866570002 | |||||
| BATCHELOR, Paul William Richard | Administrateur | 32 Hazelton Road Marlbrook B61 0JE Bromsgrove Worcestershire | British | 29542990001 | ||||||
| BATCHELOR, Paul William Richard | Administrateur | 32 Hazelton Road Marlbrook B61 0JE Bromsgrove Worcestershire | British | 29542990001 | ||||||
| BAUNACK, Albert Wilhelm Uwe | Administrateur | 15 Rue Marcel Ballasse Margny-Les-Compiegne FOREIGN France | German | 48909040001 | ||||||
| COTTERILL, Mark John | Administrateur | Aldenham Road WD23 2QQ Bushey Europcar House Watford England | United Kingdom | British | 126885690001 | |||||
| DEPOIS, Thierry | Administrateur | 4bis Rue Revert 95300 Pontoise FOREIGN France | French | 54853950001 | ||||||
| DU MONCEAU DE BERGENDAL, John Maurice Gabriel | Administrateur | 9 Rue Victor Hugo Jouy-En-Josas Les Yvelines 78000 France | French | 46710400001 | ||||||
| FITCH, John Derek | Administrateur | Douglas Cottage Coombe End KT2 7DQ Kingston Surrey | British | 8461210001 | ||||||
| FLEMING, Paul Scott | Administrateur | Apartment 244 Royal Drive Princess Park Manor N11 3FT London | British | 73871570003 | ||||||
| JOHNSON, Steven Mark | Administrateur | Aldenham Road WD23 2QQ Bushey Europcar House Watford England | United Kingdom | British | 137622810001 | |||||
| KERN, Michael, Dr | Administrateur | Auestrasse 90 52382 Niederzier Germany | British | 70370910001 | ||||||
| KING SMITH, Terence Peter | Administrateur | The Field House Snowshill WR12 7JT Broadway Worcestershire | British | 30203050001 | ||||||
| LEIGH, John Simon | Administrateur | Priory House Priory Road SL5 9RQ Sunningdale Berkshire | United Kingdom | British | 119920050001 | |||||
| MASAI, Pierre Jean Andre | Administrateur | Avenue De L Opale 73 FOREIGN Brussels 1030 Belgium | Belgian | 76994760001 | ||||||
| NEVILLE, Robert Stanley | Administrateur | Borrowell Borrowell Lane CV8 1ER Kenilworth Warwickshire | British | 8259110001 | ||||||
| NEVILLE, Robert Stanley | Administrateur | Borrowell Borrowell Lane CV8 1ER Kenilworth Warwickshire | British | 8259110001 | ||||||
| NOACK, Gerhard | Administrateur | 2 Avenue Octave FOREIGN Greard 75007 Paris France | German | 71949080001 | ||||||
| OSTROWSKI, Stefan | Administrateur | 20 Avenue Thery 92420 Vaucresson France | German | 85010670001 | ||||||
| PALMER, Helen Elizabeth | Administrateur | 22 Croftdown Road B17 8RB Birmingham West Midlands | British | 69052940001 | ||||||
| RAFAEL, Girona | Administrateur | 8 Rue Roger Bacon 75017 Paris Paris France | France | Spanish | 76995130003 | |||||
| ROSE, Harry Anthony | Administrateur | The Old School House Old School Lane Lighthorne CV35 0AX Warwick | British | 27476440003 | ||||||
| SAYWARD, Glenn Martin | Administrateur | 32 Waverley Road NG18 5AG Mansfield Nottinghamshire | British | 41017820001 | ||||||
| SLADE, Arthur Geoffrey | Administrateur | Field House Horsham Road BN44 3AE Steyning West Sussex | British | 72709160001 | ||||||
| SMITH, John Stephen | Administrateur | The Coach House 26 Kenilworth Road CV32 6JB Leamington Spa Warwickshire | British | 8259150002 | ||||||
| WOODHOUSE, John Graham | Administrateur | The Lake House Breach Lane CV35 8QB Claverdon Warwickshire | British | 4882030002 |
ROVARD FACILITIES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Créé le 15 juin 1994 Livré le 22 juin 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a 1212 stockport road levenshulme manchester t/n LA266831 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 15 juin 1994 Livré le 22 juin 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0