COMPUTER SERVICES CONSULTANTS (U.K.) LIMITED

COMPUTER SERVICES CONSULTANTS (U.K.) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOMPUTER SERVICES CONSULTANTS (U.K.) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02237053
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COMPUTER SERVICES CONSULTANTS (U.K.) LIMITED ?

    • Développement de logiciels professionnels et grand public (62012) / Information et communication

    Où se situe COMPUTER SERVICES CONSULTANTS (U.K.) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Trimble House Gelderd Road, Gildersome
    Morley
    LS27 7JP Leeds
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COMPUTER SERVICES CONSULTANTS (U.K.) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NETPACE LIMITED28 mars 198828 mars 1988

    Quels sont les derniers comptes de COMPUTER SERVICES CONSULTANTS (U.K.) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour COMPUTER SERVICES CONSULTANTS (U.K.) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 03 nov. 2022

    • Capital: GBP 0.10
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c 02/11/2022
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 10 mars 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    2 pagesMR04

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2020

    13 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 mars 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2019

    11 pagesAA

    Nomination de Julie Shepard en tant qu'administrateur le 01 oct. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de John Peter Schreiber en tant que directeur le 01 oct. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 10 mars 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2018

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 mars 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2017

    11 pagesAA

    Nomination de Mr Algirdas Paul Rimas en tant qu'administrateur le 29 mars 2018

    2 pagesAP01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Director appointed 29/03/2018
    RES13

    Nomination de Mr John Schreiber en tant qu'administrateur le 29 mars 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de John Ernest Huey Iii en tant que directeur le 01 avr. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Steven Walter Berglund en tant que directeur le 01 avr. 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 10 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2016

    12 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de COMPUTER SERVICES CONSULTANTS (U.K.) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KIRKLAND, James Anthony, Vice President
    Stewart Drive
    94085 Sunnyvale
    935
    Ca
    United States
    Administrateur
    Stewart Drive
    94085 Sunnyvale
    935
    Ca
    United States
    United StatesAmericanVp, General Counsel And Assistant Secretary183093010001
    RIMAS, Algirdas Paul
    Stewart Drive
    Sunnyvale
    935
    California
    Usa
    Administrateur
    Stewart Drive
    Sunnyvale
    935
    California
    Usa
    United StatesAmericanDeputy General Counsel246182140001
    SHEPARD, Julie
    Gelderd Road, Gildersome
    Morley
    LS27 7JP Leeds
    Trimble House
    England
    Administrateur
    Gelderd Road, Gildersome
    Morley
    LS27 7JP Leeds
    Trimble House
    England
    United StatesAmericanPrincipal Accounting Officer275379790001
    BELLWOOD, Simon Mark
    Yeadon House, New Street
    Pudsey
    LS28 8AQ Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Yeadon House, New Street
    Pudsey
    LS28 8AQ Leeds
    West Yorkshire
    BritishAccountant14419800001
    DOBSON, Benjamin Richard Palin
    Buckley House
    Stanbury
    BD22 0HL Keighley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Buckley House
    Stanbury
    BD22 0HL Keighley
    West Yorkshire
    BritishDirector55189300001
    FEARNLEY, James Robert
    The Moorings Waterside Walk
    Wood Lane
    WF14 0EB Mirfield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    The Moorings Waterside Walk
    Wood Lane
    WF14 0EB Mirfield
    West Yorkshire
    British3798850001
    BELLWOOD, Simon Mark
    Yeadon House, New Street
    Pudsey
    LS28 8AQ Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Yeadon House, New Street
    Pudsey
    LS28 8AQ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishAccountant14419800002
    BERGLUND, Steven Walter
    Stewart Drive
    94085 Sunnyvale
    935
    Ca
    United States
    Administrateur
    Stewart Drive
    94085 Sunnyvale
    935
    Ca
    United States
    United StatesAmericanPresident/Ceo183093300001
    BEVERIDGE, Andrew John
    47 Effingham Road
    Harden
    BD16 1LQ Bingley
    West Yorkshire
    Administrateur
    47 Effingham Road
    Harden
    BD16 1LQ Bingley
    West Yorkshire
    BritishCompany Director4387710002
    CHAPMAN, Barry Graham
    Yeadon House, New Street
    Pudsey
    LS28 8AQ Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Yeadon House, New Street
    Pudsey
    LS28 8AQ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishSales Director126830720002
    DOBSON, Benjamin Richard Palin
    Yeadon House, New Street
    Pudsey
    LS28 8AQ Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Yeadon House, New Street
    Pudsey
    LS28 8AQ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector55189300002
    DRURY, Simon Michael
    41 Beauchamp Road
    SW11 1PG London
    Administrateur
    41 Beauchamp Road
    SW11 1PG London
    BritishInvestment Manager41191630001
    FEARNLEY, James Robert
    The Moorings Waterside Walk
    Wood Lane
    WF14 0EB Mirfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Moorings Waterside Walk
    Wood Lane
    WF14 0EB Mirfield
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant3798850001
    GEORGE, Christopher Robert
    Yeadon House, New Street
    Pudsey
    LS28 8AQ Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Yeadon House, New Street
    Pudsey
    LS28 8AQ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishExport Director55189360002
    HUEY III, John Ernest
    Stewart Drive
    94085 Sunnyvale
    935
    Ca
    United States
    Administrateur
    Stewart Drive
    94085 Sunnyvale
    935
    Ca
    United States
    United StatesAmericanTreasurer183093060001
    PARTRIDGE, Robert Steven
    Park House
    1 Rufford Crescent, Yeadon
    LS19 7QX Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Park House
    1 Rufford Crescent, Yeadon
    LS19 7QX Leeds
    West Yorkshire
    BritishTechnical Director142765020001
    PARTRIDGE, Robert Steven
    Park House
    1 Rufford Crescent, Yeadon
    LS19 7QX Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Park House
    1 Rufford Crescent, Yeadon
    LS19 7QX Leeds
    West Yorkshire
    BritishTechnical Director142765020001
    ROBERTS, Mark Andrew
    Yeadon House, New Street
    Pudsey
    LS28 8AQ Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Yeadon House, New Street
    Pudsey
    LS28 8AQ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishSales Director43094590003
    SCHREIBER, John Peter
    Stewart Drive
    Sunnyvale
    935
    California
    Usa
    Administrateur
    Stewart Drive
    Sunnyvale
    935
    California
    Usa
    United StatesAmericanVice President Global Tax245661570001
    STRONG, Richard Martin
    25 Newstead Way
    SW19 5HR London
    Administrateur
    25 Newstead Way
    SW19 5HR London
    BritishConsultant11940550001
    SWARTFIGURE, Geoffrey Thomas
    22 Chestnut Avenue
    LS22 6SG Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    22 Chestnut Avenue
    LS22 6SG Wetherby
    West Yorkshire
    BritishChartered Engineer46886740001
    YEADON, Robert Edward
    The Grove Carlton Lane
    Guiseley
    LS20 9NN Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Grove Carlton Lane
    Guiseley
    LS20 9NN Leeds
    West Yorkshire
    BritishCivil And Structural Engineer3798860001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COMPUTER SERVICES CONSULTANTS (U.K.) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Gelderd Road
    Gildersome, Morley
    LS27 7JP Leeds
    Trimble House
    England
    06 avr. 2016
    Gelderd Road
    Gildersome, Morley
    LS27 7JP Leeds
    Trimble House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement3330075
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    COMPUTER SERVICES CONSULTANTS (U.K.) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 23 janv. 2008
    Livré le 30 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 30 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 23 janv. 2008
    Livré le 30 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Yeadon house glebe street pudey leeds t/no WYK233741. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 30 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 28 mars 2003
    Livré le 11 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Andrew John Beveridge
    Transactions
    • 11 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 mars 2003
    Livré le 04 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on the east side of carlisle road pudsey leeds t/no: WYK233741. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 mars 2003
    Livré le 04 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 juil. 1997
    Livré le 25 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 25 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 10 juil. 1997
    Livré le 25 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property at the east side of carlisle road rudsey t/n wyk 233741. with the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 25 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 juil. 1997
    Livré le 22 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £600,000 guaranteed secure loan notes 1992-2002 and all sums owing thereunder due or to become due from the company to robert edward yeadon and anita winifred yeadon in their personal capacities and also as trustees of computer services consultants (UK) limited directors'pension fund
    Brèves mentions
    F/H premises at glebe mount,new street,pudsey,leeds,west yorkshire LS28 8AQ.t/no.WYK233741. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Robert Edward Yeadon
    • Anita Winifred Yeadon
    Transactions
    • 22 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 janv. 1990
    Livré le 08 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or eta engineering consultants limited to the chargee. Under the terms of the charge
    Brèves mentions
    (See form 395 and continuation sheets relevant to this charge). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank Public Limited Company.
    Transactions
    • 08 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 27 févr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 juin 1988
    Livré le 30 juin 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on the east side of carlisle road pudsey west yorkshire title no wyk 233741 with all fixtures and fittings (other than trade) plant and machinery. Floating charge over all movable plant machinery equipment fixtures fittings material and articles.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 30 juin 1988Enregistrement d'une charge
    • 30 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 mai 1988
    Livré le 18 mai 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floatng charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capitall buildings fixtures (inc trade fixtures) fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 18 mai 1988Enregistrement d'une charge
    • 27 févr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0