PHOENIX WEALTH SERVICES LIMITED

PHOENIX WEALTH SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPHOENIX WEALTH SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02238458
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PHOENIX WEALTH SERVICES LIMITED ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe PHOENIX WEALTH SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PHOENIX WEALTH SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AXA WEALTH SERVICES LIMITED15 sept. 201015 sept. 2010
    WINTERTHUR PENSION TRUSTEES UK LIMITED01 mai 199501 mai 1995
    PROVIDENT LIFE (PENSION TRUSTEES) LIMITED25 mai 198825 mai 1988
    INTERCEDE 540 LIMITED31 mars 198831 mars 1988

    Quels sont les derniers comptes de PHOENIX WEALTH SERVICES LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PHOENIX WEALTH SERVICES LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au23 avr. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation07 mai 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au23 avr. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour PHOENIX WEALTH SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Nomination de Mr Colin Williams en tant qu'administrateur le 01 oct. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Brid Mary Meaney en tant que directeur le 30 sept. 2024

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2023

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 avr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    21 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 avr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 424 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    22 pagesAA

    Nomination de Mrs Brid Mary Meaney en tant qu'administrateur le 01 oct. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Moss en tant que directeur le 01 oct. 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 23 avr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 avr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 avr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de David Richard Cheeseman en tant que directeur le 31 janv. 2020

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 395 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 423 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 422 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 022384580433 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 022384580431 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 022384580432 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 022384580439 en totalité

    4 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de PHOENIX WEALTH SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PEARL GROUP SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    West Midlands
    United Kingdom
    Secrétaire
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    West Midlands
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement3588041
    146249030001
    WILLIAMS, Colin
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    United KingdomBritishCompany Director311423680001
    WOOLLETT, David Nicholas
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    United KingdomBritishDirector224031460001
    BASARAN, Sandra Judith
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    Secrétaire
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    British150997870001
    BOUTLE, Geoffrey John
    3 Westbrook Close
    Oakley
    RG23 7HW Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    3 Westbrook Close
    Oakley
    RG23 7HW Basingstoke
    Hampshire
    British31409860001
    CANTLE, Neil Jonathan
    11 Birches Crest
    Hatch Warren
    RG22 4RP Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    11 Birches Crest
    Hatch Warren
    RG22 4RP Basingstoke
    Hampshire
    British66902800002
    CANTLE, Neil Jonathan
    11 Birches Crest
    Hatch Warren
    RG22 4RP Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    11 Birches Crest
    Hatch Warren
    RG22 4RP Basingstoke
    Hampshire
    British66902800002
    LOCKWOOD, Kevin Ashley
    2 Paddocks Close
    KT21 2RA Ashstead
    Surrey
    Secrétaire
    2 Paddocks Close
    KT21 2RA Ashstead
    Surrey
    British75155040003
    SMALL, Jeremy Peter
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    Secrétaire
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    British67168210001
    ALLEN, Michael Derek
    Manor Cottage
    Kings Somborne Road, Braishfield
    SO51 0QS Romsey
    Hampshire
    Administrateur
    Manor Cottage
    Kings Somborne Road, Braishfield
    SO51 0QS Romsey
    Hampshire
    United KingdomBritishFinance Director65347010001
    BASARAN, Sandra Judith
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Secretary150997870001
    BATCHELOR, Dawn Michelle
    Rose Cottage
    20 Folly Hill
    GU9 0BD Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Rose Cottage
    20 Folly Hill
    GU9 0BD Farnham
    Surrey
    United KingdomBritishCompliance Officer87525680001
    BROWN, David Mark
    Costa Porsche
    The Drive
    RH14 0TD Ifold
    West Sussex
    Administrateur
    Costa Porsche
    The Drive
    RH14 0TD Ifold
    West Sussex
    BritishActuary85273980001
    BUDD, Gerald Victor Albert
    Medlars
    Cleardown
    GU22 7HH Woking
    Surrey
    Administrateur
    Medlars
    Cleardown
    GU22 7HH Woking
    Surrey
    EnglandBritishGeneral Manager27592680003
    CANTLE, Neil Jonathan
    11 Birches Crest
    Hatch Warren
    RG22 4RP Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    11 Birches Crest
    Hatch Warren
    RG22 4RP Basingstoke
    Hampshire
    BritishDirector Corporate Development66902800002
    CHEESEMAN, David Richard
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    EnglandBritishDirector132416500001
    CHEESEMAN, David Richard
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    EnglandBritishCompany Director132416500001
    CUNLIFFE, John Malcolm
    Coombe Cottage
    Spring Hill Fordcombe
    TN3 0SB Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    Coombe Cottage
    Spring Hill Fordcombe
    TN3 0SB Tunbridge Wells
    Kent
    UkBritishSolicitor4582810001
    DOOLEY, Matthew James
    The Tollhouse Reading Road
    Chineham
    RG24 8LP Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    The Tollhouse Reading Road
    Chineham
    RG24 8LP Basingstoke
    Hampshire
    BritishChartered Accountant35184250001
    ELPHICK, Nicolas John
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    EnglandBritishNone138042920001
    ELPHICK, Nicolas John
    Tyfield
    Sherborne St. John
    RG24 9HZ Basingstoke
    Sunnylea 22
    Hampshire
    Administrateur
    Tyfield
    Sherborne St. John
    RG24 9HZ Basingstoke
    Sunnylea 22
    Hampshire
    EnglandBritishDir Group Operations & It138042920001
    EVANS, Paul James
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    EnglandBritishNone283554310001
    EVANS, Paul James
    5 Old Broad Street
    London
    EC2N 1AD
    Administrateur
    5 Old Broad Street
    London
    EC2N 1AD
    EnglandBritishCompany Director283554310001
    FINAN, John Charles
    Isomer Cottage
    The Warren, Caversham
    RG4 7TQ Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Isomer Cottage
    The Warren, Caversham
    RG4 7TQ Reading
    Berkshire
    EnglandIrishManaging Director7389820001
    GIBBS, Keith George
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    EnglandBritishNone56358480002
    HALLIGAN, Raymond Arthur
    8 The Baredown
    Nately Scures
    RG27 9JT Hook
    Hampshire
    Administrateur
    8 The Baredown
    Nately Scures
    RG27 9JT Hook
    Hampshire
    BritishGeneral Manager50475030001
    HARE, James Mcdonald Buchanan
    6 Parkway
    Edgcumbe Park
    RG45 6EN Crowthorne
    Berkshire
    Administrateur
    6 Parkway
    Edgcumbe Park
    RG45 6EN Crowthorne
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector Hr78266150001
    HAZELL, Peter Frank
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    EnglandBritishCompany Director76176480001
    ISHERWOOD, Kristina Maria
    4 The Ridgeway
    GU1 2DG Guildford
    Surrey
    Administrateur
    4 The Ridgeway
    GU1 2DG Guildford
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director94065860002
    J'AFARI PAK, Lindsay Clare
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    UkBritishNone147651430001
    KELLARD, Michael John
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    United KingdomBritishCeo84234750003
    KENNEDY, Annmarie
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    West Midlands
    United Kingdom
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector Of Operations & Regulatory Risk175060850002
    LAMBLE, Dean
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    West Midlands
    United Kingdom
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive Officer219137320001
    MCINNES, Susan Davidson
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    ScotlandBritishInsurance Manager146357050002
    MEANEY, Brid Mary
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England And Wales
    United Kingdom
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England And Wales
    United Kingdom
    EnglandIrishFinance Director282133260001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PHOENIX WEALTH SERVICES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    West Midlands
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    West Midlands
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement3223752
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    PHOENIX WEALTH SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 11 févr. 2015
    Livré le 16 févr. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    The property known as 1 park gardens, yeovil somerset, BA201DW registered under title number ST103641.
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 16 févr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 févr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 31 oct. 2014
    Livré le 17 nov. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    30-34 rookery road, handsworth, birmingham B21 9NB.
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 12 oct. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 oct. 2014
    Livré le 06 nov. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All and whole the subjects known as and forming 28 dundas street, edinburgh EH3 6JN and being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID87466.
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 06 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 oct. 2014
    Livré le 06 nov. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All and whole the subjects known as and forming 34 and 34A alva street, edinburgh EH2 4PY and being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID90024.
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 06 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 oct. 2014
    Livré le 06 nov. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All and whole the subjects known as and forming 51 and 53 thistle street, edinburgh EH2 1DY and being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID87485.
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 06 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 oct. 2014
    Livré le 06 nov. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All and whole the subjects known as and forming 43 moray place, edinburgh EH3 6BT and being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID89301.
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 06 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 oct. 2014
    Livré le 06 nov. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All and whole the subjects known as and forming 3 darnaway street, edinburgh EH3 6DW and being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID87487.
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 06 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 oct. 2014
    Livré le 06 nov. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All and whole the subjects known as and forming that shop and warehouse 30 and 30A dundas street, edinburgh EH3 6JN and being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID89300.
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 06 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 oct. 2014
    Livré le 06 nov. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All and whole the subjects known as and forming 12 william street, edinburgh EH3 7NH and being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID87467.
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 06 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 oct. 2014
    Livré le 06 nov. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All and whole the subjects known as and forming 22 howe street, edinburgh EH3 6TG and being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID87482.
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 06 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 oct. 2014
    Livré le 06 nov. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All and whole the subjects known as and forming 11 and 15 william street, edinburgh EH3 7NG and being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID87469.
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 06 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 oct. 2014
    Livré le 06 nov. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All and whole the subjects known as and forming 28A dundas street, edinburgh EH3 6JN and being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID89299.
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 06 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 oct. 2014
    Livré le 06 nov. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All and whole the subjects known as and forming 207-209 morningside road, edinburgh EH10 4QT and being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID87489.
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 06 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 24 oct. 2014
    Livré le 31 oct. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Part of the cobalt building, burnley bridge business park, burnley, lancashire.
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Both Clydesdale Bank and Yorkshire Bank)
    Transactions
    • 31 oct. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 04 avr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 15 oct. 2013
    Livré le 31 oct. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    8 dole lane, chorley, PR7 2RL ( title number LA543581). Notification of addition to or amendment of charge.
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 31 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 oct. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 15 oct. 2013
    Livré le 31 oct. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    51 atherton road, hindley, WN2 3EA (title number GM171185). Notification of addition to or amendment of charge.
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 31 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 oct. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 15 oct. 2013
    Livré le 31 oct. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    50 new market street, wigan, WN1 1SJ (GM197926). Notification of addition to or amendment of charge.
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 31 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 oct. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 29 janv. 2013
    Livré le 19 févr. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the customer to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    51 bushey hall road bushey hertfordshire (t/no HD53252) by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable from any lease, all goodwill, the proceeds of any insurance, all fixtures and fittings not forming part of the property, all plant and machinery, all furniture equipment tools and other goods kept at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 févr. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 12 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 11 janv. 2013
    Livré le 17 janv. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company as trustees for the time being of the waldman family suntrust scheme on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H - 7 riverside court, lower bristol road, bath with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 17 janv. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 21 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 07 déc. 2012
    Livré le 21 déc. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that l/h property k/a unit g, halesfield 14, telford, shropshire t/no.SL177516 fixed charge th goodwill any share moveable plant, machinery implements utensils furniture see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 21 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security executed on 29 august 2012
    Créé le 19 sept. 2012
    Livré le 22 sept. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company as trustee of the tony o'connor suntrust scheme (20522) to the chargee
    Brèves mentions
    All and whole 170-174 kilmarnock road glasgow within tenement 170-180 (even nos) kilmarnock road and 3 and 5 trefoil avenue t/no GLA9597.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 22 sept. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 07 sept. 2012
    Livré le 11 sept. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    120 high street marlborough wiltshire, t/no: WT18876 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 sept. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 03 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 20 juil. 2012
    Livré le 25 juil. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 10 stratford office village, wolverton mill, milton keynes, bucks by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 03 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 13 juil. 2012
    Livré le 24 juil. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the customer to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    142 seven sisters road london t/no NGL605557 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable from any lease, all goodwill, the proceeds of any insurance, all fixtures and fittings not forming part of the property, all plant and machinery, vehicles and computer equipment see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 28 févr. 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 09 juil. 2012
    Livré le 10 juil. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company re sills family suntrust scheme to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a land at st aylotts farm, ashdon road, saffron walden.
    Personnes ayant droit
    • The Agricultural Mortgage Corporation PLC
    Transactions
    • 10 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 25 janv. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0