PHOENIX WEALTH SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | PHOENIX WEALTH SERVICES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02238458 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PHOENIX WEALTH SERVICES LIMITED ?
Adresse du siège social | 1 Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PHOENIX WEALTH SERVICES LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PHOENIX WEALTH SERVICES LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 23 avr. 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 07 mai 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 23 avr. 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour PHOENIX WEALTH SERVICES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Nomination de Mr Colin Williams en tant qu'administrateur le 01 oct. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Brid Mary Meaney en tant que directeur le 30 sept. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 20 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 23 avr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 21 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 23 avr. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Satisfaction de la charge 424 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 22 pages | AA | ||
Nomination de Mrs Brid Mary Meaney en tant qu'administrateur le 01 oct. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Andrew Moss en tant que directeur le 01 oct. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 23 avr. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 20 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 23 avr. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 20 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 24 avr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de David Richard Cheeseman en tant que directeur le 31 janv. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 20 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Satisfaction de la charge 395 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 423 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 422 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 022384580433 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 022384580431 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 022384580432 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 022384580439 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Qui sont les dirigeants de PHOENIX WEALTH SERVICES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEARL GROUP SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secrétaire | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 West Midlands United Kingdom |
| 146249030001 | ||||||||||
WILLIAMS, Colin | Administrateur | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 | United Kingdom | British | Company Director | 311423680001 | ||||||||
WOOLLETT, David Nicholas | Administrateur | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 | United Kingdom | British | Director | 224031460001 | ||||||||
BASARAN, Sandra Judith | Secrétaire | Silveroaks 101 Copsewood Way HA6 2TU Northwood Middlesex | British | 150997870001 | ||||||||||
BOUTLE, Geoffrey John | Secrétaire | 3 Westbrook Close Oakley RG23 7HW Basingstoke Hampshire | British | 31409860001 | ||||||||||
CANTLE, Neil Jonathan | Secrétaire | 11 Birches Crest Hatch Warren RG22 4RP Basingstoke Hampshire | British | 66902800002 | ||||||||||
CANTLE, Neil Jonathan | Secrétaire | 11 Birches Crest Hatch Warren RG22 4RP Basingstoke Hampshire | British | 66902800002 | ||||||||||
LOCKWOOD, Kevin Ashley | Secrétaire | 2 Paddocks Close KT21 2RA Ashstead Surrey | British | 75155040003 | ||||||||||
SMALL, Jeremy Peter | Secrétaire | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 | British | 67168210001 | ||||||||||
ALLEN, Michael Derek | Administrateur | Manor Cottage Kings Somborne Road, Braishfield SO51 0QS Romsey Hampshire | United Kingdom | British | Finance Director | 65347010001 | ||||||||
BASARAN, Sandra Judith | Administrateur | Silveroaks 101 Copsewood Way HA6 2TU Northwood Middlesex | United Kingdom | British | Company Secretary | 150997870001 | ||||||||
BATCHELOR, Dawn Michelle | Administrateur | Rose Cottage 20 Folly Hill GU9 0BD Farnham Surrey | United Kingdom | British | Compliance Officer | 87525680001 | ||||||||
BROWN, David Mark | Administrateur | Costa Porsche The Drive RH14 0TD Ifold West Sussex | British | Actuary | 85273980001 | |||||||||
BUDD, Gerald Victor Albert | Administrateur | Medlars Cleardown GU22 7HH Woking Surrey | England | British | General Manager | 27592680003 | ||||||||
CANTLE, Neil Jonathan | Administrateur | 11 Birches Crest Hatch Warren RG22 4RP Basingstoke Hampshire | British | Director Corporate Development | 66902800002 | |||||||||
CHEESEMAN, David Richard | Administrateur | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 | England | British | Director | 132416500001 | ||||||||
CHEESEMAN, David Richard | Administrateur | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 | England | British | Company Director | 132416500001 | ||||||||
CUNLIFFE, John Malcolm | Administrateur | Coombe Cottage Spring Hill Fordcombe TN3 0SB Tunbridge Wells Kent | Uk | British | Solicitor | 4582810001 | ||||||||
DOOLEY, Matthew James | Administrateur | The Tollhouse Reading Road Chineham RG24 8LP Basingstoke Hampshire | British | Chartered Accountant | 35184250001 | |||||||||
ELPHICK, Nicolas John | Administrateur | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 | England | British | None | 138042920001 | ||||||||
ELPHICK, Nicolas John | Administrateur | Tyfield Sherborne St. John RG24 9HZ Basingstoke Sunnylea 22 Hampshire | England | British | Dir Group Operations & It | 138042920001 | ||||||||
EVANS, Paul James | Administrateur | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 | England | British | None | 283554310001 | ||||||||
EVANS, Paul James | Administrateur | 5 Old Broad Street London EC2N 1AD | England | British | Company Director | 283554310001 | ||||||||
FINAN, John Charles | Administrateur | Isomer Cottage The Warren, Caversham RG4 7TQ Reading Berkshire | England | Irish | Managing Director | 7389820001 | ||||||||
GIBBS, Keith George | Administrateur | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 | England | British | None | 56358480002 | ||||||||
HALLIGAN, Raymond Arthur | Administrateur | 8 The Baredown Nately Scures RG27 9JT Hook Hampshire | British | General Manager | 50475030001 | |||||||||
HARE, James Mcdonald Buchanan | Administrateur | 6 Parkway Edgcumbe Park RG45 6EN Crowthorne Berkshire | United Kingdom | British | Director Hr | 78266150001 | ||||||||
HAZELL, Peter Frank | Administrateur | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 | England | British | Company Director | 76176480001 | ||||||||
ISHERWOOD, Kristina Maria | Administrateur | 4 The Ridgeway GU1 2DG Guildford Surrey | England | British | Finance Director | 94065860002 | ||||||||
J'AFARI PAK, Lindsay Clare | Administrateur | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 | Uk | British | None | 147651430001 | ||||||||
KELLARD, Michael John | Administrateur | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 | United Kingdom | British | Ceo | 84234750003 | ||||||||
KENNEDY, Annmarie | Administrateur | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | Director Of Operations & Regulatory Risk | 175060850002 | ||||||||
LAMBLE, Dean | Administrateur | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 219137320001 | ||||||||
MCINNES, Susan Davidson | Administrateur | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 | Scotland | British | Insurance Manager | 146357050002 | ||||||||
MEANEY, Brid Mary | Administrateur | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 England And Wales United Kingdom | England | Irish | Finance Director | 282133260001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PHOENIX WEALTH SERVICES LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Wealth Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 West Midlands United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
PHOENIX WEALTH SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 11 févr. 2015 Livré le 16 févr. 2015 | Totalement satisfaite | ||
Brève description The property known as 1 park gardens, yeovil somerset, BA201DW registered under title number ST103641. Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 31 oct. 2014 Livré le 17 nov. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description 30-34 rookery road, handsworth, birmingham B21 9NB. Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 30 oct. 2014 Livré le 06 nov. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description All and whole the subjects known as and forming 28 dundas street, edinburgh EH3 6JN and being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID87466. Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 30 oct. 2014 Livré le 06 nov. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description All and whole the subjects known as and forming 34 and 34A alva street, edinburgh EH2 4PY and being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID90024. Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 30 oct. 2014 Livré le 06 nov. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description All and whole the subjects known as and forming 51 and 53 thistle street, edinburgh EH2 1DY and being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID87485. Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 30 oct. 2014 Livré le 06 nov. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description All and whole the subjects known as and forming 43 moray place, edinburgh EH3 6BT and being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID89301. Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 30 oct. 2014 Livré le 06 nov. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description All and whole the subjects known as and forming 3 darnaway street, edinburgh EH3 6DW and being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID87487. Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 30 oct. 2014 Livré le 06 nov. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description All and whole the subjects known as and forming that shop and warehouse 30 and 30A dundas street, edinburgh EH3 6JN and being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID89300. Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 30 oct. 2014 Livré le 06 nov. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description All and whole the subjects known as and forming 12 william street, edinburgh EH3 7NH and being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID87467. Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 30 oct. 2014 Livré le 06 nov. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description All and whole the subjects known as and forming 22 howe street, edinburgh EH3 6TG and being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID87482. Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 30 oct. 2014 Livré le 06 nov. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description All and whole the subjects known as and forming 11 and 15 william street, edinburgh EH3 7NG and being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID87469. Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 30 oct. 2014 Livré le 06 nov. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description All and whole the subjects known as and forming 28A dundas street, edinburgh EH3 6JN and being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID89299. Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 30 oct. 2014 Livré le 06 nov. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description All and whole the subjects known as and forming 207-209 morningside road, edinburgh EH10 4QT and being the subjects registered in the land register of scotland under title number MID87489. Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 24 oct. 2014 Livré le 31 oct. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Part of the cobalt building, burnley bridge business park, burnley, lancashire. Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 15 oct. 2013 Livré le 31 oct. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description 8 dole lane, chorley, PR7 2RL ( title number LA543581). Notification of addition to or amendment of charge. Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 15 oct. 2013 Livré le 31 oct. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description 51 atherton road, hindley, WN2 3EA (title number GM171185). Notification of addition to or amendment of charge. Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 15 oct. 2013 Livré le 31 oct. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description 50 new market street, wigan, WN1 1SJ (GM197926). Notification of addition to or amendment of charge. Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 29 janv. 2013 Livré le 19 févr. 2013 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the customer to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 51 bushey hall road bushey hertfordshire (t/no HD53252) by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable from any lease, all goodwill, the proceeds of any insurance, all fixtures and fittings not forming part of the property, all plant and machinery, all furniture equipment tools and other goods kept at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 11 janv. 2013 Livré le 17 janv. 2013 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company as trustees for the time being of the waldman family suntrust scheme on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H - 7 riverside court, lower bristol road, bath with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 07 déc. 2012 Livré le 21 déc. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All that l/h property k/a unit g, halesfield 14, telford, shropshire t/no.SL177516 fixed charge th goodwill any share moveable plant, machinery implements utensils furniture see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security executed on 29 august 2012 | Créé le 19 sept. 2012 Livré le 22 sept. 2012 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company as trustee of the tony o'connor suntrust scheme (20522) to the chargee | |
Brèves mentions All and whole 170-174 kilmarnock road glasgow within tenement 170-180 (even nos) kilmarnock road and 3 and 5 trefoil avenue t/no GLA9597. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 07 sept. 2012 Livré le 11 sept. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 120 high street marlborough wiltshire, t/no: WT18876 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 20 juil. 2012 Livré le 25 juil. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Unit 10 stratford office village, wolverton mill, milton keynes, bucks by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 13 juil. 2012 Livré le 24 juil. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the customer to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 142 seven sisters road london t/no NGL605557 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable from any lease, all goodwill, the proceeds of any insurance, all fixtures and fittings not forming part of the property, all plant and machinery, vehicles and computer equipment see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 09 juil. 2012 Livré le 10 juil. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company re sills family suntrust scheme to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a land at st aylotts farm, ashdon road, saffron walden. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0