MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02240236 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED ?
| Adresse du siège social | Millhouse Roughton Road Kirby On Bain LN10 6YL Woodhall Spa Lincolnshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 26 juil. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2017 | 2 pages | AA | ||||||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2016 | 2 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 26 juil. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015 | 4 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 30 avr. 2016 au 31 déc. 2015 | 1 pages | AA01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 26 juil. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Richard John Harwin en tant que directeur le 13 juil. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Satisfaction de la charge 022402360008 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Mbm Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 30 avr. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2015 | 6 pages | AA | ||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Andrew Peter Jones le 01 nov. 2015 | 1 pages | CH03 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Peter Jones le 01 nov. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Deuxième dépôt de AR01 précédemment soumis à Companies House mis à jour jusqu'au 26 juil. 2015 | 19 pages | RP04 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomination de Mbm Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 03 août 2015 | 2 pages | AP04 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Frank Carl Straetmans en tant que directeur le 13 mai 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Herring Lawson en tant que directeur le 13 mai 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Modification de la charge 022402360009, créée le 10 juin 2015 | 15 pages | MR07 | ||||||||||||||
Inscription de la charge 022402360009, créée le 10 juin 2015 | 25 pages | MR01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONES, Andrew Peter | Secrétaire | Kirkby On Bain LN10 6YL Woodhall Spa Roughton Road United Kingdom | 182346500001 | |||||||||||
| ASHTON, Stephen Richard | Administrateur | Millhouse Roughton Road Kirby On Bain LN10 6YL Woodhall Spa Lincolnshire | United Kingdom | British | 158496390001 | |||||||||
| HOUSTOUN, Alexander | Administrateur | Millhouse Roughton Road Kirby On Bain LN10 6YL Woodhall Spa Lincolnshire | United Kingdom | British | 13350630001 | |||||||||
| JONES, Andrew Peter | Administrateur | Kirkby On Bain LN10 6YL Woodhall Spa Roughton Road United Kingdom | England | British | 181551660001 | |||||||||
| SYMON, Alan Wilson | Administrateur | Millhouse Roughton Road Kirby On Bain LN10 6YL Woodhall Spa Lincolnshire | Scotland | British | 115942360001 | |||||||||
| HILL, Ewan | Secrétaire | 21b Exchange Street DD1 3DJ Dundee Angus | British | 123402720001 | ||||||||||
| HOLLAND, Carol | Secrétaire | The Willows 18 Lucan Close Sibsey PE22 0SH Boston Lincolnshire | British | 14187890002 | ||||||||||
| MORGAN, Andrew | Secrétaire | Newton Road DD7 6HQ Carnoustie 37 Angus | British | 146653900001 | ||||||||||
| OUTRAM, Michael Vaughan | Secrétaire | 3 The Spinney Boston Road Kirton PE20 1DE Boston Lincolnshire | British | 112021460001 | ||||||||||
| CCW SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Crescent House Carnegie Campus KY11 8GR Dunfermline Fife | 63577400019 | |||||||||||
| MBM SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | 125 Princes Street EH2 4AD Edinburgh 5th Floor United Kingdom |
| 133157900001 | ||||||||||
| BROWN, Matthew Jeremy | Administrateur | Fuller Street CM3 2AY Fairstead 2 White Cottages Essex | England | British | 108565950004 | |||||||||
| HARWIN, Richard John | Administrateur | Platts Lane Bucknall LN10 5DY Woodhall Spa White Cottage Lincolnshire | United Kingdom | British | 132931070001 | |||||||||
| LAWSON, Richard Herring | Administrateur | Over Pilmore Invergowrie DD2 5EL Dundee | Scotland | British | 146501290001 | |||||||||
| LAWSON, Richard Fraser | Administrateur | Albany Road Broughty Ferry DD5 1NU Dundee 39a United Kingdom | Scotland | British | 110947350003 | |||||||||
| OUTRAM, Michael Vaughan | Administrateur | 3 The Spinney Boston Road Kirton PE20 1DE Boston Lincolnshire | United Kingdom | British | 112021460001 | |||||||||
| OUTRAM, Michael Vaughan | Administrateur | 3 The Spinney Boston Road Kirton PE20 1DE Boston Lincolnshire | United Kingdom | British | 112021460001 | |||||||||
| STRAETMANS, Frank Carl | Administrateur | Springfield Road CM2 6AS Chelmsford 272 Essex England | United Kingdom | Belgian | 148283530002 | |||||||||
| WALKER, Rodney Jon Ogden | Administrateur | Granary House Boothby Graffoe LN5 0LE Lincoln Lincolnshire | British | 39016650001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
|---|---|---|---|
| Mr Andrew Peter Jones | 06 avr. 2016 | Millhouse Roughton Road Kirby On Bain LN10 6YL Woodhall Spa Lincolnshire | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 10 juin 2015 Livré le 25 juin 2015 | En cours | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 15 mai 2015 Livré le 29 mai 2015 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 24 nov. 2005 Livré le 08 déc. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Factory premises at roughton road kirby on bain lincolnshire t/no LL81623. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 10 oct. 2005 Livré le 27 oct. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating charge | Créé le 10 oct. 2005 Livré le 26 oct. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 28 févr. 1994 Livré le 09 mars 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a land and buildings at roughton road kirkby-on-bain nr. Woodhall spa lincolnshire. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge | Créé le 05 juin 1992 Livré le 09 juin 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Goodwill uncalled capital patents patent applications copyrights trade names trade marks. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating charge | Créé le 08 mars 1989 Livré le 10 mars 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0