MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED

MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02240236
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Millhouse Roughton Road
    Kirby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Lincolnshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 26 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2017

    2 pagesAA

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2016

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 26 juil. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    4 pagesAA

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Période comptable précédente raccourcie du 30 avr. 2016 au 31 déc. 2015

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 26 juil. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Richard John Harwin en tant que directeur le 13 juil. 2016

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 022402360008 en totalité

    1 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Mbm Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 30 avr. 2016

    1 pagesTM02

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2015

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Andrew Peter Jones le 01 nov. 2015

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Peter Jones le 01 nov. 2015

    2 pagesCH01

    Deuxième dépôt de AR01 précédemment soumis à Companies House mis à jour jusqu'au 26 juil. 2015

    19 pagesRP04

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 août 2015

    État du capital au 20 août 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01
    capital20 août 2015

    État du capital au 14 sept. 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01
    Annotations
    DateAnnotation
    14 sept. 2015Clarification A second filed AR01 was registered on 14/09/2015.

    Nomination de Mbm Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 03 août 2015

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Frank Carl Straetmans en tant que directeur le 13 mai 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Richard Herring Lawson en tant que directeur le 13 mai 2015

    1 pagesTM01

    Modification de la charge 022402360009, créée le 10 juin 2015

    15 pagesMR07

    Inscription de la charge 022402360009, créée le 10 juin 2015

    25 pagesMR01

    Qui sont les dirigeants de MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JONES, Andrew Peter
    Kirkby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Roughton Road
    United Kingdom
    Secrétaire
    Kirkby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Roughton Road
    United Kingdom
    182346500001
    ASHTON, Stephen Richard
    Millhouse Roughton Road
    Kirby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Lincolnshire
    Administrateur
    Millhouse Roughton Road
    Kirby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Lincolnshire
    United KingdomBritish158496390001
    HOUSTOUN, Alexander
    Millhouse Roughton Road
    Kirby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Lincolnshire
    Administrateur
    Millhouse Roughton Road
    Kirby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Lincolnshire
    United KingdomBritish13350630001
    JONES, Andrew Peter
    Kirkby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Roughton Road
    United Kingdom
    Administrateur
    Kirkby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Roughton Road
    United Kingdom
    EnglandBritish181551660001
    SYMON, Alan Wilson
    Millhouse Roughton Road
    Kirby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Lincolnshire
    Administrateur
    Millhouse Roughton Road
    Kirby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Lincolnshire
    ScotlandBritish115942360001
    HILL, Ewan
    21b Exchange Street
    DD1 3DJ Dundee
    Angus
    Secrétaire
    21b Exchange Street
    DD1 3DJ Dundee
    Angus
    British123402720001
    HOLLAND, Carol
    The Willows 18 Lucan Close
    Sibsey
    PE22 0SH Boston
    Lincolnshire
    Secrétaire
    The Willows 18 Lucan Close
    Sibsey
    PE22 0SH Boston
    Lincolnshire
    British14187890002
    MORGAN, Andrew
    Newton Road
    DD7 6HQ Carnoustie
    37
    Angus
    Secrétaire
    Newton Road
    DD7 6HQ Carnoustie
    37
    Angus
    British146653900001
    OUTRAM, Michael Vaughan
    3 The Spinney
    Boston Road Kirton
    PE20 1DE Boston
    Lincolnshire
    Secrétaire
    3 The Spinney
    Boston Road Kirton
    PE20 1DE Boston
    Lincolnshire
    British112021460001
    CCW SECRETARIES LIMITED
    Crescent House
    Carnegie Campus
    KY11 8GR Dunfermline
    Fife
    Secrétaire
    Crescent House
    Carnegie Campus
    KY11 8GR Dunfermline
    Fife
    63577400019
    MBM SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th Floor
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC156630
    133157900001
    BROWN, Matthew Jeremy
    Fuller Street
    CM3 2AY Fairstead
    2 White Cottages
    Essex
    Administrateur
    Fuller Street
    CM3 2AY Fairstead
    2 White Cottages
    Essex
    EnglandBritish108565950004
    HARWIN, Richard John
    Platts Lane
    Bucknall
    LN10 5DY Woodhall Spa
    White Cottage
    Lincolnshire
    Administrateur
    Platts Lane
    Bucknall
    LN10 5DY Woodhall Spa
    White Cottage
    Lincolnshire
    United KingdomBritish132931070001
    LAWSON, Richard Herring
    Over Pilmore
    Invergowrie
    DD2 5EL Dundee
    Administrateur
    Over Pilmore
    Invergowrie
    DD2 5EL Dundee
    ScotlandBritish146501290001
    LAWSON, Richard Fraser
    Albany Road
    Broughty Ferry
    DD5 1NU Dundee
    39a
    United Kingdom
    Administrateur
    Albany Road
    Broughty Ferry
    DD5 1NU Dundee
    39a
    United Kingdom
    ScotlandBritish110947350003
    OUTRAM, Michael Vaughan
    3 The Spinney
    Boston Road Kirton
    PE20 1DE Boston
    Lincolnshire
    Administrateur
    3 The Spinney
    Boston Road Kirton
    PE20 1DE Boston
    Lincolnshire
    United KingdomBritish112021460001
    OUTRAM, Michael Vaughan
    3 The Spinney
    Boston Road Kirton
    PE20 1DE Boston
    Lincolnshire
    Administrateur
    3 The Spinney
    Boston Road Kirton
    PE20 1DE Boston
    Lincolnshire
    United KingdomBritish112021460001
    STRAETMANS, Frank Carl
    Springfield Road
    CM2 6AS Chelmsford
    272
    Essex
    England
    Administrateur
    Springfield Road
    CM2 6AS Chelmsford
    272
    Essex
    England
    United KingdomBelgian148283530002
    WALKER, Rodney Jon Ogden
    Granary House Boothby
    Graffoe
    LN5 0LE Lincoln
    Lincolnshire
    Administrateur
    Granary House Boothby
    Graffoe
    LN5 0LE Lincoln
    Lincolnshire
    British39016650001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Andrew Peter Jones
    Millhouse Roughton Road
    Kirby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Lincolnshire
    06 avr. 2016
    Millhouse Roughton Road
    Kirby On Bain
    LN10 6YL Woodhall Spa
    Lincolnshire
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    MILL HOUSE MANUFACTURING DESIGN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 10 juin 2015
    Livré le 25 juin 2015
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Both Clydesdale and Yorkshire Bank)
    Transactions
    • 25 juin 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 juil. 2015Détails d'un instrument de modification d'une charge (MR07)
    A registered charge
    Créé le 15 mai 2015
    Livré le 29 mai 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Maven Capital Partners UK LLP (As Security Trustee for and on Behalf of Scottish Loan Fund L.P.)
    Transactions
    • 29 mai 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 09 juin 2015Détails d'un instrument de modification d'une charge (MR07)
    • 14 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 24 nov. 2005
    Livré le 08 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Factory premises at roughton road kirby on bain lincolnshire t/no LL81623. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 10 oct. 2005
    Livré le 27 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating charge
    Créé le 10 oct. 2005
    Livré le 26 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 26 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 28 févr. 1994
    Livré le 09 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a land and buildings at roughton road kirkby-on-bain nr. Woodhall spa lincolnshire. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 09 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 05 juin 1992
    Livré le 09 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Goodwill uncalled capital patents patent applications copyrights trade names trade marks.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 09 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 08 mars 1989
    Livré le 10 mars 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 10 mars 1989Enregistrement d'une charge
    • 01 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0