DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED

DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02241896
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Fisher Partners Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HANDYGIFT LIMITED01 mars 199401 mars 1994
    LONDON AND REGIONAL PROPERTIES LIMITED13 juin 198913 juin 1989
    GADE PROPERTIES LIMITED08 avr. 198808 avr. 1988

    Quels sont les derniers comptes de DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 févr. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71
    Q52GHNQY

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Chris Barton le 09 nov. 2015

    1 pagesCH03
    X4LTQAE2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 août 2015

    3 pages4.68
    A4I5ZIM9

    Nomination de Mr Chris Barton en tant que secrétaire le 05 janv. 2015

    2 pagesAP03
    X3YI8SO8

    Cessation de la nomination de Marcus Owen Shepherd en tant que secrétaire le 05 janv. 2015

    1 pagesTM02
    X3YI8S0W

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 août 2014

    4 pages4.68
    A3IQZFZS

    Nomination de Mr Marcus Owen Shepherd en tant que secrétaire le 01 sept. 2014

    2 pagesAP03
    X3FMZZYG

    Cessation de la nomination de Helen Maria Ratsey en tant que secrétaire le 01 sept. 2014

    1 pagesTM02
    X3FMZS5T

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    11 pagesLIQ MISC OC
    A2ZOWH8I

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600
    A2ZOWH8Q

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40
    A2ZOWH6Q

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600
    A2G7PXVK

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70
    A2G7PXVS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Changement d'adresse du siège social de * Portland House Bressenden Place London SW1E 5DS* le 03 sept. 2013

    1 pagesAD01
    X2G56G9L

    Cessation de la nomination de Matthew Weiner en tant que directeur

    2 pagesTM01
    A2DXO8YR

    Cessation de la nomination de Charles Barwick en tant que directeur

    2 pagesTM01
    A2DXO903

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 avr. 2013

    État du capital au 30 avr. 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01
    X27DQCOO

    Comptes pour une société dormante établis au 29 févr. 2012

    8 pagesAA
    A1KUSYFM

    Modification des coordonnées de l'administrateur Charles Julian Barwick le 11 août 2012

    3 pagesCH01
    A1IPLI3C

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    X16NJA8Q

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2011 au 29 févr. 2012

    3 pagesAA01
    A0OAIS83

    Modification des coordonnées de l'administrateur Charles Julian Barwick le 29 sept. 2011

    3 pagesCH01
    A1Y9DY6Z

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    8 pagesAA
    AB5Z1XF2

    Qui sont les dirigeants de DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BARTON, Chris
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Secrétaire
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    193873580001
    MARX, Michael Henry
    The Orchard California Lane
    WD23 1ES Bushey Heath
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Orchard California Lane
    WD23 1ES Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant35019090001
    DEVELOPMENT SECURITIES ESTATES PLC
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    United Kingdom
    Administrateur
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement657311
    53858600001
    BUNT, Philip Alan
    176 Whitchurch Lane
    HA8 6QJ Edgware
    Secrétaire
    176 Whitchurch Lane
    HA8 6QJ Edgware
    British33027500001
    LANES, Stephen Alec
    Thorpe House 105 Mycenae Road
    Blackheath
    SE3 7RX London
    Secrétaire
    Thorpe House 105 Mycenae Road
    Blackheath
    SE3 7RX London
    British1266100003
    LIVINGSTONE, Ian Malcolm
    5 Hanover Terrace
    NW1 4RJ London
    Secrétaire
    5 Hanover Terrace
    NW1 4RJ London
    British75831270001
    LIVINGSTONE, Richard John
    4 Eaton Mews North
    SW1 London
    Secrétaire
    4 Eaton Mews North
    SW1 London
    British51534890002
    RATSEY, Helen Maria
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    Secrétaire
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    British158447900001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    England
    Secrétaire
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    England
    190659990001
    BARWICK, Charles Julian
    Campana Road
    SW6 4AT London
    45
    England
    Administrateur
    Campana Road
    SW6 4AT London
    45
    England
    EnglandBritishCompany Director3818640003
    BODIE, Anthony Ellyah
    112 Clifton Hill
    NW8 OJS London
    Administrateur
    112 Clifton Hill
    NW8 OJS London
    BritishDirector34902790002
    CHEER, Bruce Baxter
    10 Kilmiston House
    TW17 9ES Shepperton
    Middlesex
    Administrateur
    10 Kilmiston House
    TW17 9ES Shepperton
    Middlesex
    BritishChartered Surveyor66762930001
    CORDEREY, Neil Sinclair
    5 Barton Road
    AL4 8QG Wheathampstead
    Hertfordshire
    Administrateur
    5 Barton Road
    AL4 8QG Wheathampstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor74024640001
    LIVINGSTONE, Ian Malcolm
    5 Hanover Terrace
    NW1 4RJ London
    Administrateur
    5 Hanover Terrace
    NW1 4RJ London
    BritishOptician75831270001
    LIVINGSTONE, Richard John
    4 Eaton Mews North
    SW1 London
    Administrateur
    4 Eaton Mews North
    SW1 London
    BritishChartered Surveyor51534890002
    ROSE, William Marcus Henderson
    11 Patten Road
    SW18 3RH London
    Administrateur
    11 Patten Road
    SW18 3RH London
    United KingdomBritishChartered Surveyor9127840001
    VAUGHAN, Steven Mark
    16 Kittiwake Close
    Woodley
    RG5 4UF Reading
    Berkshire
    Administrateur
    16 Kittiwake Close
    Woodley
    RG5 4UF Reading
    Berkshire
    BritishChartered Surveyor9092330001
    WARE, Robert Thomas Ernest
    3 Bayliss Road
    Wargrave
    RG10 8DR Reading
    Berkshire
    Administrateur
    3 Bayliss Road
    Wargrave
    RG10 8DR Reading
    Berkshire
    BritishChartered Accountant4779170001
    WEINER, Matthew Simon
    24 Southway
    NW11 6RU London
    Administrateur
    24 Southway
    NW11 6RU London
    United KingdomBritishChartered Surveyor72888710002

    DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental deed (being supplemental to a deed of legal charge dted 23 december 1998)
    Créé le 18 févr. 2002
    Livré le 07 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H property k/a 104 camley street, l/b of camden including all buildings fixtures fixed plant and machinery thereon. Fixed charge all moneys from timr to time deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 to the principal deed. Floating charge the company's property assets rights and revenues, present and future including the unacalled share capital (if any).. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 07 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment
    Créé le 18 févr. 2002
    Livré le 07 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from development securities PLC to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the rights titles benefits and interests of the company to all moneys from time to time owing or incurred to the company under the leases in respect of 104 camley street, london (the lease) other than sums receivable by the company by way of insurance contributions service charge, payments to sinking funds or any vat payable thereon (rents) including the right to receive the same and the full benefit of any guarantee or security for the performance thereof (the assigned rights). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 07 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 10 juil. 1995
    Livré le 17 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or development securities PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Whilem works, forest road, hainault, l/b of redbridge t/no.EGL7113.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 22 avr. 1994
    Livré le 12 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rents licence fees & other like sums payable under the terms of any lease underlease agreement for lease or tenancy relating to the property k/a whilem works & lorely forest road hainault essex. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transactions
    • 12 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 avr. 1994
    Livré le 12 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transactions
    • 12 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 août 1993
    Livré le 06 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land k/a gaywood house 29 great peter street vlondon t/no 221951 with fixtures & fittings fixed plant & machinery (other than trade).
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 06 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 août 1993
    Livré le 06 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First floating charge over. Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 06 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of yearly rents
    Créé le 20 août 1993
    Livré le 06 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the agreement dated 19/8/93, the assignment or any related security document (as defined in the assignment)
    Brèves mentions
    All right title & interest in & to the clear yearly rents reserved or to be reserved by the lease of building k/a gaywood house 29 great peter street london the benefit of any surety or guarantee. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 06 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Residual floating charge
    Créé le 29 janv. 1993
    Livré le 13 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge the whole of the undertaking property and assets of the company.
    Personnes ayant droit
    • Ucb Bank PLC
    Transactions
    • 13 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 29 janv. 1993
    Livré le 13 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a 104 camley street london title no NGL474499. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Ucb Bank PLC
    Transactions
    • 13 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment or rent
    Créé le 22 mai 1992
    Livré le 03 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a legal charge of even date
    Brèves mentions
    The benefit of all rents and all other sums payable under a lease together with any arrears existing at the date of this deed.
    Personnes ayant droit
    • Ucb Bank PLC
    Transactions
    • 03 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 mai 1992
    Livré le 27 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land & buildings k/a 52 standard rd, acton london t/no agl 12123 with a & goodwill & all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Ucb Bank PLC
    Transactions
    • 27 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal & floating charge
    Créé le 11 mai 1992
    Livré le 16 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,350,000 & all other monies due from the company to the chargee on any account whatsoever & a participation fee in the maximum sum of £54,000 due from the company to the chargee (as defined in the charge)
    Brèves mentions
    L/H land & building k/a 104 camley st, london t/no ngl 474499 with A. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 16 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 01 août 1989
    Livré le 16 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a 52 standard road acton london and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transactions
    • 16 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 04 juil. 1989
    Livré le 13 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that l/h property k/a units 1-18 telford close, burnett road norwich & the goodwill of the business.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transactions
    • 13 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 mai 1989
    Livré le 17 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a "loreley", forest road, hainault with fixed plant, machinery (except personal chattels) & the goodwill of the business.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Bank Limited.
    Transactions
    • 17 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 06 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 avr. 1989
    Livré le 27 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a whilemworks, forest rd. Haincuilt tno elg 7113 tog with together with, fixed and plant machienry fixtures by way of:. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transactions
    • 27 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 06 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 mars 1989
    Livré le 07 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 94 ballords lane london N3. (Title no: mx 468172. together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Banks Limited
    Transactions
    • 07 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 01 févr. 1989
    Livré le 03 févr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    221 camben high street T.N. ln 92414. together with fixed plant machinery & other fixtures. & stocks of building materials goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transactions
    • 03 févr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 01 juil. 1988
    Livré le 19 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    69 & 71 praed street, london W2 by way of a floating charge. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transactions
    • 19 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 juil. 1988
    Livré le 08 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transactions
    • 08 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 06 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    DEVELOPMENT SECURITIES (CAMDEN) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 août 2013Commencement of winding up
    17 juin 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nicholas H O'Reilly
    Acre House 11-15 William Road
    NW1 3ER London
    practitioner
    Acre House 11-15 William Road
    NW1 3ER London
    David Birne
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    practitioner
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Brian N Johnson
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    practitioner
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0