SAFMARINE UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSAFMARINE UK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02242728
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SAFMARINE UK LIMITED ?

    • Autres activités de soutien au transport (52290) / Transports et stockage

    Où se situe SAFMARINE UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SAFMARINE UK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ASECO (UK) LIMITED29 juin 199229 juin 1992
    CMB (U.K.) LIMITED27 mars 199027 mars 1990
    A.M.I. HOLDINGS LIMITED27 juin 198927 juin 1989
    A.M.I. U.K. LIMITED26 août 198826 août 1988
    EATONFALL LIMITED11 avr. 198811 avr. 1988

    Quels sont les derniers comptes de SAFMARINE UK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SAFMARINE UK LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour SAFMARINE UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Maersk House Braham Street London E1 8EP

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Maersk House Braham Street London E1 8EP à 30 Finsbury Square London EC2P 2YU le 26 sept. 2014

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 16 sept. 2014

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Brian Godsafe en tant que directeur le 01 sept. 2014

    2 pagesTM01

    Nomination de Mr Nigel Edmund Lehmann-Taylor en tant qu'administrateur le 22 août 2014

    3 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 juil. 2014

    État du capital au 10 juil. 2014

    • Capital: GBP 795,000
    SH01

    Divers

    Section 519
    3 pagesMISC

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    15 pagesAA

    Divers

    Section 519
    2 pagesMISC

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Rob Waterman en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Mr John Kilby en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Francis Mottrie en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jan Scheck en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de SAFMARINE UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KILBY, John, Mr.
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Secrétaire
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    BritishCompany Secretary76247880001
    KILBY, John, Mr.
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Administrateur
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    EnglandBritishCompany Secretary76247880001
    LEHMANN-TAYLOR, Nigel Edmund
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Administrateur
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    EnglandBritishDirector137861000001
    ASH-EDWARDS, Christopher John Peter
    45 Turners Mill Road
    RH16 1NW Haywards Heath
    West Sussex
    Secrétaire
    45 Turners Mill Road
    RH16 1NW Haywards Heath
    West Sussex
    British28514000001
    DAVIS, Colleen Mary
    66 Henfield Road
    SW19 3HH London
    Secrétaire
    66 Henfield Road
    SW19 3HH London
    South African62942340002
    MASSAM, Kevin
    Bramley House 26 Dalts Avenue
    Loose
    ME15 0AZ Maidstone
    Kent
    Secrétaire
    Bramley House 26 Dalts Avenue
    Loose
    ME15 0AZ Maidstone
    Kent
    British32328380002
    ROBBINS, Anthony
    183 Marsh Wall
    E14 9SH London
    Secrétaire
    183 Marsh Wall
    E14 9SH London
    British24137960001
    BANNISTER, James Douglas
    Beagle House
    Braham Street
    E1 8EP London
    Administrateur
    Beagle House
    Braham Street
    E1 8EP London
    United StatesDirector74555460001
    BARNES, Ian Robert
    10 Green Acres Road
    Layer De La Haye
    CO2 0JP Colchester
    Essex
    Administrateur
    10 Green Acres Road
    Layer De La Haye
    CO2 0JP Colchester
    Essex
    BritishDirector111626650001
    BOWES, Michael Anthony Alexander
    3 Bertha Avenue
    Bishops Court
    7700 Cape Town
    South Africa
    Administrateur
    3 Bertha Avenue
    Bishops Court
    7700 Cape Town
    South Africa
    BritishManager64965760001
    BUTLAND, Peter De Villiers
    Wilenstrasse 17
    Postfach 345
    Ch- 8832 Woolerau
    Switzerland
    Administrateur
    Wilenstrasse 17
    Postfach 345
    Ch- 8832 Woolerau
    Switzerland
    BritishShipping Executive27174710003
    DALGAARD, Flemming
    8 Netherton Road
    St Margarets
    TW1 1LZ Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    8 Netherton Road
    St Margarets
    TW1 1LZ Twickenham
    Middlesex
    United KingdomDanishManaging Director116091010001
    DEN AREND, Jacob
    Ekster 3
    Da Hoogvliet Rt Nl 3191
    FOREIGN Rotterdam
    Netherlands
    Administrateur
    Ekster 3
    Da Hoogvliet Rt Nl 3191
    FOREIGN Rotterdam
    Netherlands
    DutchCompany Director65106830001
    DOO, Christopher John
    Verviersstraat 2 Apartment 4a
    2000 Antwerpen
    Belgium
    Administrateur
    Verviersstraat 2 Apartment 4a
    2000 Antwerpen
    Belgium
    BritishChief Finance Officer42946000001
    GODSAFE, Brian
    Maersk House
    Braham Street
    E1 8EP London
    Administrateur
    Maersk House
    Braham Street
    E1 8EP London
    EnglandBritishDirector79983130001
    GODSAFE, Brian
    57 Purford Green
    CM18 6HN Harlow
    Essex
    Administrateur
    57 Purford Green
    CM18 6HN Harlow
    Essex
    EnglandBritishDirector79983130001
    GRAY, Brett Alexander
    Meidoornlaan 39
    Kapellen 2950
    FOREIGN Belgium
    Administrateur
    Meidoornlaan 39
    Kapellen 2950
    FOREIGN Belgium
    Ssouth AfricanDirector61711460002
    HODGES, James Thomas
    125 Endlebury Road
    Chingford
    E4 6PX London
    Administrateur
    125 Endlebury Road
    Chingford
    E4 6PX London
    EnglishCompany Director25695440001
    HODGSON, John Frederick
    19 Rye Close
    Stanway
    CO3 5YP Colchester
    Essex
    Administrateur
    19 Rye Close
    Stanway
    CO3 5YP Colchester
    Essex
    EnglishOperations Director10418200001
    JESPEN, Annemette
    Maersk House
    Braham Street
    E1 8EP London
    Administrateur
    Maersk House
    Braham Street
    E1 8EP London
    UkDanishManaging Director147365240001
    KOKSBANG, Anders Christian Hedegaad
    Otto Veniusstraat 23
    FOREIGN Antwerpen 2000
    Belgium
    Administrateur
    Otto Veniusstraat 23
    FOREIGN Antwerpen 2000
    Belgium
    DanishDirector73675970001
    LABEAU, Rudi
    Schoolstraat 2c
    Schilde
    2970
    Belgium
    Administrateur
    Schoolstraat 2c
    Schilde
    2970
    Belgium
    BelgianCompany Director73849430001
    MASSAM, Kevin
    Bramley House 26 Dalts Avenue
    Loose
    ME15 0AZ Maidstone
    Kent
    Administrateur
    Bramley House 26 Dalts Avenue
    Loose
    ME15 0AZ Maidstone
    Kent
    BritishAccountant32328380002
    MIDDLETON, Barry
    Sleepy Hollow Lane
    Noord Hoek
    Cape Province 7985
    South Africa
    Administrateur
    Sleepy Hollow Lane
    Noord Hoek
    Cape Province 7985
    South Africa
    EnglishDivisional Director33939660001
    MIKOLAJCZAK, Luk
    J P Van Gysellaan 16
    FOREIGN Wemmel 1810
    Belgium
    Administrateur
    J P Van Gysellaan 16
    FOREIGN Wemmel 1810
    Belgium
    BelgianCompany Director4112510001
    MITCHELL, Anthony Julian Edward
    12 Barnetts Road
    Leigh
    TN11 8QH Tonbridge
    Kent
    Administrateur
    12 Barnetts Road
    Leigh
    TN11 8QH Tonbridge
    Kent
    BritishFinance Manager81648570001
    MOTTRIE, Francis
    Neringenstraat 14
    B-9290 Berlare
    Belgium
    Administrateur
    Neringenstraat 14
    B-9290 Berlare
    Belgium
    BelgiumBelgianEurope Region Executive89247890001
    NEWTON, Aron
    48 Raleigh Court Clarence Mews
    Rotherhithe Street
    SE16 5GB London
    Administrateur
    48 Raleigh Court Clarence Mews
    Rotherhithe Street
    SE16 5GB London
    BritishGeneral Manager81648740001
    NIELSEN, Jens Holger
    12 Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    Administrateur
    12 Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    DanishManaging Director83281860001
    OST, Edward
    Brackla Warren Drive
    Kingswood
    KT20 6PX Tadworth
    Surrey
    Administrateur
    Brackla Warren Drive
    Kingswood
    KT20 6PX Tadworth
    Surrey
    BritishCompany Director24137970001
    OST, Edward
    Brackla Warren Drive
    Kingswood
    KT20 6PX Tadworth
    Surrey
    Administrateur
    Brackla Warren Drive
    Kingswood
    KT20 6PX Tadworth
    Surrey
    BritishMarketing Director24137970001
    PEIRCE, Kenneth John Graham
    Schijnparklaan 20
    2900 Schoten
    Belgium
    Administrateur
    Schijnparklaan 20
    2900 Schoten
    Belgium
    South AfricanChief Executive44374240001
    PEIRCE, Kenneth John Graham
    14 Malcolm Road
    Rondebosch
    FOREIGN Cape Province 7700
    South Africa
    Administrateur
    14 Malcolm Road
    Rondebosch
    FOREIGN Cape Province 7700
    South Africa
    South AfricanChief Executive18685090001
    RABIE, Jan Sebastian
    Frohburgstrasse 43
    FOREIGN Wollerau Ch-8832
    Switzerland
    Administrateur
    Frohburgstrasse 43
    FOREIGN Wollerau Ch-8832
    Switzerland
    South AfricanChief Executive49034380001
    RISEBOROUGH, Roderick William
    The Bield
    Sutton Place, Abinger Hammer
    RH5 6RL Dorking
    Surrey
    Administrateur
    The Bield
    Sutton Place, Abinger Hammer
    RH5 6RL Dorking
    Surrey
    BritishCompany Director79900330001

    SAFMARINE UK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of deposit supplemental to a lease dated 15TH may 2001 relating to premises known as suite 1.01 exchange tower 2 harbour exchange square limeharbour london E14
    Créé le 15 mai 2001
    Livré le 18 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the lease as defined above
    Brèves mentions
    All the company's right title benefit and interest in all monies standing to the credit of an interest bearing account opened in the name of harbour exchange (no.1) limited and harbour exchange (no.2) limited with a bank or institution of the landlord's choosing under the terms of the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Harbour Exchange (No.1) Limited and Harbour Exchange (No.2) Limited
    Transactions
    • 18 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of charge and release over deposit
    Créé le 29 oct. 1998
    Livré le 17 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and facility letter dated 9TH august 1995 defined therein
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest in and to the security deposit account in the account bank in whichg the security deposit is placed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hambros Bank Limited
    Transactions
    • 17 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed
    Créé le 10 févr. 1995
    Livré le 22 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an underlease of even date or any document supplemental thereto and under the terms of this deed
    Brèves mentions
    The account in the name of the landlord at national westminster bank PLC and the deposit sum of £24,592 (in respect of a tenancy of part of the fourth floor south phase ii south quay plaza 183 marsh wall london). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Baxtergate Investment Co Limited
    Transactions
    • 22 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed
    Créé le 10 févr. 1995
    Livré le 22 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an underlease of even date or any document supplemental thereto and under the terms of this deed
    Brèves mentions
    A deposit account in the name of the landlord at national westminster bank PLC and the deposit sum of £24,592 (in respect of a tenancy of part of the fourth floor north, phase ii south quay plaza 183 marsh wall london). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Baxtergate Investments Co Limited
    Transactions
    • 22 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    SAFMARINE UK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 sept. 2014Commencement of winding up
    14 août 2015Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0