SAFMARINE UK LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | SAFMARINE UK LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02242728 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SAFMARINE UK LIMITED ?
Adresse du siège social | 30 Finsbury Square EC2P 2YU London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SAFMARINE UK LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2012 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SAFMARINE UK LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour SAFMARINE UK LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 6 pages | 4.71 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Maersk House Braham Street London E1 8EP | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Maersk House Braham Street London E1 8EP à 30 Finsbury Square London EC2P 2YU le 26 sept. 2014 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 2 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Brian Godsafe en tant que directeur le 01 sept. 2014 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Nigel Edmund Lehmann-Taylor en tant qu'administrateur le 22 août 2014 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Divers Section 519 | 3 pages | MISC | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2012 | 15 pages | AA | ||||||||||
Divers Section 519 | 2 pages | MISC | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 2 pages | AUD | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Rob Waterman en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr John Kilby en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2011 | 16 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Francis Mottrie en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jan Scheck en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SAFMARINE UK LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILBY, John, Mr. | Secrétaire | Finsbury Square EC2P 2YU London 30 | British | Company Secretary | 76247880001 | |||||
KILBY, John, Mr. | Administrateur | Finsbury Square EC2P 2YU London 30 | England | British | Company Secretary | 76247880001 | ||||
LEHMANN-TAYLOR, Nigel Edmund | Administrateur | Finsbury Square EC2P 2YU London 30 | England | British | Director | 137861000001 | ||||
ASH-EDWARDS, Christopher John Peter | Secrétaire | 45 Turners Mill Road RH16 1NW Haywards Heath West Sussex | British | 28514000001 | ||||||
DAVIS, Colleen Mary | Secrétaire | 66 Henfield Road SW19 3HH London | South African | 62942340002 | ||||||
MASSAM, Kevin | Secrétaire | Bramley House 26 Dalts Avenue Loose ME15 0AZ Maidstone Kent | British | 32328380002 | ||||||
ROBBINS, Anthony | Secrétaire | 183 Marsh Wall E14 9SH London | British | 24137960001 | ||||||
BANNISTER, James Douglas | Administrateur | Beagle House Braham Street E1 8EP London | United States | Director | 74555460001 | |||||
BARNES, Ian Robert | Administrateur | 10 Green Acres Road Layer De La Haye CO2 0JP Colchester Essex | British | Director | 111626650001 | |||||
BOWES, Michael Anthony Alexander | Administrateur | 3 Bertha Avenue Bishops Court 7700 Cape Town South Africa | British | Manager | 64965760001 | |||||
BUTLAND, Peter De Villiers | Administrateur | Wilenstrasse 17 Postfach 345 Ch- 8832 Woolerau Switzerland | British | Shipping Executive | 27174710003 | |||||
DALGAARD, Flemming | Administrateur | 8 Netherton Road St Margarets TW1 1LZ Twickenham Middlesex | United Kingdom | Danish | Managing Director | 116091010001 | ||||
DEN AREND, Jacob | Administrateur | Ekster 3 Da Hoogvliet Rt Nl 3191 FOREIGN Rotterdam Netherlands | Dutch | Company Director | 65106830001 | |||||
DOO, Christopher John | Administrateur | Verviersstraat 2 Apartment 4a 2000 Antwerpen Belgium | British | Chief Finance Officer | 42946000001 | |||||
GODSAFE, Brian | Administrateur | Maersk House Braham Street E1 8EP London | England | British | Director | 79983130001 | ||||
GODSAFE, Brian | Administrateur | 57 Purford Green CM18 6HN Harlow Essex | England | British | Director | 79983130001 | ||||
GRAY, Brett Alexander | Administrateur | Meidoornlaan 39 Kapellen 2950 FOREIGN Belgium | Ssouth African | Director | 61711460002 | |||||
HODGES, James Thomas | Administrateur | 125 Endlebury Road Chingford E4 6PX London | English | Company Director | 25695440001 | |||||
HODGSON, John Frederick | Administrateur | 19 Rye Close Stanway CO3 5YP Colchester Essex | English | Operations Director | 10418200001 | |||||
JESPEN, Annemette | Administrateur | Maersk House Braham Street E1 8EP London | Uk | Danish | Managing Director | 147365240001 | ||||
KOKSBANG, Anders Christian Hedegaad | Administrateur | Otto Veniusstraat 23 FOREIGN Antwerpen 2000 Belgium | Danish | Director | 73675970001 | |||||
LABEAU, Rudi | Administrateur | Schoolstraat 2c Schilde 2970 Belgium | Belgian | Company Director | 73849430001 | |||||
MASSAM, Kevin | Administrateur | Bramley House 26 Dalts Avenue Loose ME15 0AZ Maidstone Kent | British | Accountant | 32328380002 | |||||
MIDDLETON, Barry | Administrateur | Sleepy Hollow Lane Noord Hoek Cape Province 7985 South Africa | English | Divisional Director | 33939660001 | |||||
MIKOLAJCZAK, Luk | Administrateur | J P Van Gysellaan 16 FOREIGN Wemmel 1810 Belgium | Belgian | Company Director | 4112510001 | |||||
MITCHELL, Anthony Julian Edward | Administrateur | 12 Barnetts Road Leigh TN11 8QH Tonbridge Kent | British | Finance Manager | 81648570001 | |||||
MOTTRIE, Francis | Administrateur | Neringenstraat 14 B-9290 Berlare Belgium | Belgium | Belgian | Europe Region Executive | 89247890001 | ||||
NEWTON, Aron | Administrateur | 48 Raleigh Court Clarence Mews Rotherhithe Street SE16 5GB London | British | General Manager | 81648740001 | |||||
NIELSEN, Jens Holger | Administrateur | 12 Ashchurch Park Villas W12 9SP London | Danish | Managing Director | 83281860001 | |||||
OST, Edward | Administrateur | Brackla Warren Drive Kingswood KT20 6PX Tadworth Surrey | British | Company Director | 24137970001 | |||||
OST, Edward | Administrateur | Brackla Warren Drive Kingswood KT20 6PX Tadworth Surrey | British | Marketing Director | 24137970001 | |||||
PEIRCE, Kenneth John Graham | Administrateur | Schijnparklaan 20 2900 Schoten Belgium | South African | Chief Executive | 44374240001 | |||||
PEIRCE, Kenneth John Graham | Administrateur | 14 Malcolm Road Rondebosch FOREIGN Cape Province 7700 South Africa | South African | Chief Executive | 18685090001 | |||||
RABIE, Jan Sebastian | Administrateur | Frohburgstrasse 43 FOREIGN Wollerau Ch-8832 Switzerland | South African | Chief Executive | 49034380001 | |||||
RISEBOROUGH, Roderick William | Administrateur | The Bield Sutton Place, Abinger Hammer RH5 6RL Dorking Surrey | British | Company Director | 79900330001 |
SAFMARINE UK LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Deed of deposit supplemental to a lease dated 15TH may 2001 relating to premises known as suite 1.01 exchange tower 2 harbour exchange square limeharbour london E14 | Créé le 15 mai 2001 Livré le 18 mai 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the lease as defined above | |
Brèves mentions All the company's right title benefit and interest in all monies standing to the credit of an interest bearing account opened in the name of harbour exchange (no.1) limited and harbour exchange (no.2) limited with a bank or institution of the landlord's choosing under the terms of the deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of charge and release over deposit | Créé le 29 oct. 1998 Livré le 17 nov. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and facility letter dated 9TH august 1995 defined therein | |
Brèves mentions All the company's right title and interest in and to the security deposit account in the account bank in whichg the security deposit is placed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed | Créé le 10 févr. 1995 Livré le 22 févr. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an underlease of even date or any document supplemental thereto and under the terms of this deed | |
Brèves mentions The account in the name of the landlord at national westminster bank PLC and the deposit sum of £24,592 (in respect of a tenancy of part of the fourth floor south phase ii south quay plaza 183 marsh wall london). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed | Créé le 10 févr. 1995 Livré le 22 févr. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an underlease of even date or any document supplemental thereto and under the terms of this deed | |
Brèves mentions A deposit account in the name of the landlord at national westminster bank PLC and the deposit sum of £24,592 (in respect of a tenancy of part of the fourth floor north, phase ii south quay plaza 183 marsh wall london). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
SAFMARINE UK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0