HOLMES & MARCHANT PUBLISHING LIMITED

HOLMES & MARCHANT PUBLISHING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHOLMES & MARCHANT PUBLISHING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02243060
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HOLMES & MARCHANT PUBLISHING LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe HOLMES & MARCHANT PUBLISHING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    8th Floor, Holborn Gate
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HOLMES & MARCHANT PUBLISHING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AGE COMMUNICATIONS LIMITED05 mai 198805 mai 1988
    LEGIBUS 1142 LIMITED11 avr. 198811 avr. 1988

    Quels sont les derniers comptes de HOLMES & MARCHANT PUBLISHING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour HOLMES & MARCHANT PUBLISHING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    7 pagesAA

    Nomination de Mr Neil Garth Jones en tant qu'administrateur le 01 juil. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Rebecca Adele Horne en tant que directeur le 01 juil. 2016

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 3rd Floor, 3 London Wall Buildings London Wall London EC2M 5SY à 8th Floor, Holborn Gate 26 Southampton Buildings London WC2A 1AN le 04 août 2016

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 oct. 2015

    État du capital au 20 oct. 2015

    • Capital: GBP 1,001
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de 3 London Wall Buildings London EC2M 5SY England à 3rd Floor, 3 London Wall Buildings London Wall London EC2M 5SY le 20 oct. 2015

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    2 pagesAA

    Nomination de Mrs Rebecca Adele Horne en tant qu'administrateur le 01 juil. 2015

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de 15-17 Huntsworth Mews London NW1 6DD à 3 London Wall Buildings London EC2M 5SY le 28 juin 2015

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Alison Jane Clarke en tant que directeur le 14 juin 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Alison Jane Clarke en tant qu'administrateur le 31 déc. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Sally-Ann Patricia Withey en tant que directeur le 31 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 oct. 2014

    État du capital au 10 oct. 2014

    • Capital: GBP 1,001
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    2 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jennifer Kathryn Lees en tant que secrétaire le 08 août 2014

    2 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 oct. 2013

    État du capital au 07 oct. 2013

    • Capital: GBP 1,001
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    2 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Sally Ann Patricia Withey le 22 févr. 2013

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de HOLMES & MARCHANT PUBLISHING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JONES, Neil Garth
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    Administrateur
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    EnglandBritishFinance Director204774750001
    MORROW, Martin
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    Administrateur
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant167225950001
    BROCKWELL, David Paul
    48 Saint Margarets Grove
    HP15 6HP Great Kingshill
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    48 Saint Margarets Grove
    HP15 6HP Great Kingshill
    Buckinghamshire
    BritishAccountant76990590001
    BRYSON, Neil George
    14 Nash Gardens
    Blythewood
    SL5 8TD Ascot
    Berkshire
    Secrétaire
    14 Nash Gardens
    Blythewood
    SL5 8TD Ascot
    Berkshire
    British37336350001
    CULVER EVANS, Philip Frederick
    Bradfield Cottage
    Bradfield Willand
    EX15 2RA Cullompton
    Devon
    Secrétaire
    Bradfield Cottage
    Bradfield Willand
    EX15 2RA Cullompton
    Devon
    BritishAccountant93870000001
    HATFIELD, Adam George Roland
    Old Berkeley Cottage
    Common Road
    WD3 5LW Chorleywood
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Old Berkeley Cottage
    Common Road
    WD3 5LW Chorleywood
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary84503340001
    LAWSON, David Sydney
    18 The Pines
    Penn
    HP10 8BZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    18 The Pines
    Penn
    HP10 8BZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant69676920002
    LEES, Jennifer Kathryn
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    Secrétaire
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    British24587010002
    WHITE, Jeremy Mark
    14 Parkway
    Ratton
    BN20 9DX Eastbourne
    Sussex
    Secrétaire
    14 Parkway
    Ratton
    BN20 9DX Eastbourne
    Sussex
    BritishChartered Accountant51297980001
    ADAMS, Colin Raymond
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    Administrateur
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    EnglandBritishFinance Director39245820011
    BROADHEAD, Tymon Piers
    Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    15-17
    Administrateur
    Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    15-17
    EnglandBritishAccountant105342600002
    BROCKWELL, David Paul
    48 Saint Margarets Grove
    HP15 6HP Great Kingshill
    Buckinghamshire
    Administrateur
    48 Saint Margarets Grove
    HP15 6HP Great Kingshill
    Buckinghamshire
    BritishAccountant76990590001
    BRYSON, Neil George
    14 Nash Gardens
    Blythewood
    SL5 8TD Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    14 Nash Gardens
    Blythewood
    SL5 8TD Ascot
    Berkshire
    BritishAccountant37336350001
    CLARKE, Alison Jane
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    Administrateur
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    EnglandBritishCompany Director197310420001
    CULLINGHAM, Ian Henry Leonard
    52 Lower Cippenham Lane
    SL1 5DF Slough
    Berkshire
    Administrateur
    52 Lower Cippenham Lane
    SL1 5DF Slough
    Berkshire
    BritishAccountant9597710001
    CULVER EVANS, Philip Frederick
    Bradfield Cottage
    Bradfield Willand
    EX15 2RA Cullompton
    Devon
    Administrateur
    Bradfield Cottage
    Bradfield Willand
    EX15 2RA Cullompton
    Devon
    United KingdomBritishFinance Director93870000001
    HATFIELD, Adam George Roland
    Old Berkeley Cottage
    Common Road
    WD3 5LW Chorleywood
    Hertfordshire
    Administrateur
    Old Berkeley Cottage
    Common Road
    WD3 5LW Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Secretary84503340001
    HORNE, Rebecca Adele
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    Administrateur
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    United KingdomBritishAccountant188956200001
    JONES, Emyr Wyn
    Corners Cottage Westhorpe
    SL7 3RQ Little Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Corners Cottage Westhorpe
    SL7 3RQ Little Marlow
    Buckinghamshire
    BritishDirector5294910001
    LAWSON, David Sydney
    18 The Pines
    Penn
    HP10 8BZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    18 The Pines
    Penn
    HP10 8BZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant69676920002
    RICHARDSON, Bryan
    Oltwood House
    Oltwood
    RH1 5PW Redhill
    Surrey
    Administrateur
    Oltwood House
    Oltwood
    RH1 5PW Redhill
    Surrey
    BritishDirector5294900001
    SELMAN, Roger Malcolm
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    Administrateur
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    United KingdomBritishFinance Director10691510002
    WALTER, Ian Alan
    9 Holly Tree Close
    Ley Hill
    HP5 3QT Chesham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    9 Holly Tree Close
    Ley Hill
    HP5 3QT Chesham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishAccountant1452640001
    WHITE, Jeremy Mark
    14 Parkway
    Ratton
    BN20 9DX Eastbourne
    Sussex
    Administrateur
    14 Parkway
    Ratton
    BN20 9DX Eastbourne
    Sussex
    BritishChartered Accountant51297980001
    WITHEY, Sally-Ann Patricia
    24 Penwood Heights
    Penwood
    RG20 9EY Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    24 Penwood Heights
    Penwood
    RG20 9EY Newbury
    Berkshire
    EnglandBritishChief Operating Officer109428260052

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HOLMES & MARCHANT PUBLISHING LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Huntsworth Investments Limted
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    06 avr. 2016
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Liability Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006 (As Amended)
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement01894682
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    HOLMES & MARCHANT PUBLISHING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 24 juil. 1990
    Livré le 30 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 20 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 23 janv. 1989
    Livré le 26 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over all the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 26 janv. 1989Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0