KEMBREY ELECTRONICS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | KEMBREY ELECTRONICS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02244623 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe KEMBREY ELECTRONICS LIMITED ?
Adresse du si ège social | Roke Manor Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Hampshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de KEMBREY ELECTRONICS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 oct. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour KEMBREY ELECTRONICS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 janv. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2017 | 9 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael James Flowers en tant que directeur le 30 juin 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 janv. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2016 | 9 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Andrew Gregory Lewis en tant qu'administrateur le 19 janv. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 janv. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Sarah Louise Ellard le 03 janv. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Steven John Bowers en tant que directeur le 30 sept. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2015 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2014 | 8 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael James Flowers le 13 mars 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Sarah Louise Ellard le 09 déc. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Sarah Louise Ellard le 09 déc. 2014 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2013 | 8 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Michael James Flowers en tant qu'administrateur le 24 juil. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Harry Papworth en tant que directeur le 24 juil. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Roke Manor Old Salisbury Lane Romsey Hampshire SO51 0LZ United Kingdom* le 04 juil. 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Chemring House 1500 Parkway Whiteley Fareham Hampshire PO15 7AF* le 30 juin 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Mr Steven John Bowers en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de KEMBREY ELECTRONICS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLARD, Sarah Louise | Secrétaire | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | British | Company Secretary | 43855640011 | |||||
ELLARD, Sarah Louise | Administrateur | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | Group Legal Director | 43855640013 | ||||
LEWIS, Andrew Gregory | Administrateur | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire | United Kingdom | British | Company Director | 222848510001 | ||||
EDGE, Geoffrey | Secrétaire | Spindlewood Dog Kennel Hill Kiveton Park Station S26 6NG Sheffield South Yorkshire | British | 2055530001 | ||||||
LEIGHTON, Iain Gordon Kerr | Secrétaire | 71 Rectory Grove Clapham Common SW4 0DS London | British | Company Secretary | 42841660001 | |||||
VINE, Sylvia Elizabeth Faith | Secrétaire | Struan 65 Bell Hill GU32 2EA Petersfield Hampshire | British | Company Secretary | 3801050001 | |||||
BILLINGTON, Philip Gordon | Administrateur | 25 Carbis Close Port Solent Cosham PO6 4TW Portsmouth Hampshire | British | Chairman | 18247670001 | |||||
BOWERS, Steven John | Administrateur | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Group Finance Director | 176189250001 | ||||
BURNS, Robert Ernest | Administrateur | 20 Tennyson Road CV37 7JU Stratford Upon Avon Warwickshire | British | Director | 1525660001 | |||||
CLEARY, Michael John | Administrateur | 22 Main Road Naphill HP14 4QB High Wycombe Buckinghamshire | British | Director | 1525670001 | |||||
EDGE, Geoffrey | Administrateur | Spindlewood Dog Kennel Hill Kiveton Park Station S26 6NG Sheffield South Yorkshire | British | Accountant | 2055530001 | |||||
FLOWERS, Michael James | Administrateur | Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | Australian | Company Director | 188873370002 | ||||
GIBBS, Raymond John | Administrateur | Bridge House 7 Uxbridge Close SO31 7LP Sarisbury Soton Hampshire | British | Finance Director & Company Sec | 85421380001 | |||||
HAMMOND, Henry John | Administrateur | 28 Lamberts Field Bourton On The Water GL54 2EH Cheltenham Gloucestershire | British | Director | 3073140001 | |||||
LEIGHTON, Iain Gordon Kerr | Administrateur | 71 Rectory Grove Clapham Common SW4 0DS London | United Kingdom | British | Company Secretary | 42841660001 | ||||
MACDERMOTT, Philip | Administrateur | 179 Sternhold Avenue SW2 4PF London | British | Director | 25679470001 | |||||
PAPWORTH, Mark Harry | Administrateur | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | Chief Executive | 103085690002 | ||||
PRICE, David John | Administrateur | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive | 75259760004 | ||||
RAYNER, Paul Adrian | Administrateur | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 45628680002 | ||||
VINE, Sylvia Elizabeth Faith | Administrateur | Struan 65 Bell Hill GU32 2EA Petersfield Hampshire | British | Company Secretary | 3801050001 | |||||
WHITEHORN, Justin Michael | Administrateur | Lower Farm House Upper Milton Milton Under Wychwood OX7 6EX Chipping Norton Oxfordshire | England | British | Director | 42825970001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur KEMBREY ELECTRONICS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemring Group Plc | 30 juin 2016 | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
KEMBREY ELECTRONICS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Fixed and floating charge | Créé le 20 juil. 1993 Livré le 22 juil. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 06 juil. 1993 Livré le 13 juil. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0