COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02248411 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED ?
| Adresse du siège social | Asticus Building, 2nd Floor 21 Palmer Street SW1H 0AD London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 août 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 2 pages | AA | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 août 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 août 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 août 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Sanne Group Secretaries (Uk) Limited le 20 juil. 2015 | 1 pages | CH04 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Sanne Group 2nd Floor Pollen House 10 Cork Street London W1S 3NP à Asticus Building, 2nd Floor 21 Palmer Street London SW1H 0AD le 05 août 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Jonathan David Farkas en tant qu'administrateur le 27 janv. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mathieu Streiff en tant que directeur le 27 janv. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
legacy | 28 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE1 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 août 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mathieu Streiff le 31 mars 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Sanne Group Secretaries (Uk) Limited le 31 mars 2014 | 1 pages | CH04 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * C/O Sanne Group 1 Berkeley Street London United Kingdom W1J 8DJ* le 08 avr. 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2014 au 31 déc. 2013 | 3 pages | AA01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013 | 10 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Sanne Group Secretaries (Uk) Limited en tant que secrétaire | 3 pages | AP04 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED | Secrétaire | 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building 2nd Floor England |
| 175738460001 | ||||||||||
| FARKAS, Jonathan David | Administrateur | Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building, 2nd Floor 21 | Luxembourg | American | 193539990001 | |||||||||
| BUTLER, John | Secrétaire | Magnolia Cottage Elm Close SL2 3NA Farnham Common Buckinghamshire | British | 4526760004 | ||||||||||
| SCHOFIELD, Nigel Bennett | Secrétaire | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | British | 52338530002 | ||||||||||
| BRONOCK, Brian Paul | Administrateur | Well Springs Orchard Well Springs Brightwell Cum Sotwell OX10 0RN Wallingford Oxfordshire | United Kingdom | British | 46299650003 | |||||||||
| BRONOCK, Catherine Mary | Administrateur | Wells Springs Orchard Well Springs, Brightwell Cumsotwell OX10 0RN Wallingford Oxfordshire | United Kingdom | British | 17925460002 | |||||||||
| BUTLER, Brenda | Administrateur | Magnolia Cottage Elm Close SL2 3NA Farnham Common Buckinghamshire | England | British | 10952670003 | |||||||||
| BUTLER, John | Administrateur | Magnolia Cottage Elm Close SL2 3NA Farnham Common Buckinghamshire | England | British | 4526760004 | |||||||||
| CORMACK, Derek George | Administrateur | Pillars Grantley Avenue, Wonersh GU5 0QN Guildford Surrey | England | Irish | 67400530015 | |||||||||
| GRIFFIN, Craig | Administrateur | Halebourne House Halebourne Lane GU24 8SL Chobham Surrey | United Kingdom | British | 154122490001 | |||||||||
| HILL, Peter Martin | Administrateur | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | England | British | 130983750002 | |||||||||
| JEFFERY, Paul Anthony Keith | Administrateur | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | United Kingdom | British | 65609290003 | |||||||||
| LANGAN, Michael John | Administrateur | 68 Hitherbroom Road UB3 3AE Hayes Middlesex | United Kingdom | British | 50177330001 | |||||||||
| O'BRIEN, Bernard Vincent | Administrateur | 1 Braemar House Orchehill House Orchehill Avenue SL9 8QS Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 69342790002 | ||||||||||
| SCHOFIELD, Nigel Bennett | Administrateur | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | United Kingdom | British | 148139420001 | |||||||||
| STREIFF, Mathieu Bernard | Administrateur | Pollen House 10 Cork Street W1S 3NP London 2nd Floor | United States | American | 200529310001 | |||||||||
| WHITE, Ian James | Administrateur | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | England | British | 133383410003 | |||||||||
| WHITE, Ian James | Administrateur | Wetherden Road Haughley IP14 3RE Stowmarket Wetherden Cottage Suffolk United Kingdom | England | British | 133383410003 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga Hc Reit Ch Uk Senior Housing Portfolio Limited | 06 avr. 2016 | 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building, 2nd Floor England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 28 juil. 2010 Livré le 06 août 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of accession and charge | Créé le 17 janv. 2008 Livré le 29 janv. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 16 nov. 2007 Livré le 27 nov. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Ascot house 28 wingrove road fenham,34 and 36 wingrove road newcastle upon tynet/no's TY221509 and TY52154,bradbury house bradbury house new street braintree t/no ESX647090, cheshire house 22 st mary's road ashton on mersey t/no GM54543 (for details of further properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 28 oct. 2005 Livré le 03 nov. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All land in england and wales now vested in the chargor, all interests and rights in or relating to land or the proceeds of sale, all plant and machinery, all rental and other income. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 26 oct. 2001 Livré le 30 oct. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 14 févr. 1996 Livré le 19 févr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or brocklan investments limited and/or burnham lodge care limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 18 févr. 1991 Livré le 27 févr. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or brocklan investments limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0