COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED

COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02248411
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED ?

    • Établissements de soins infirmiers en résidence (87100) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Asticus Building, 2nd Floor 21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    COUNTY & SURBURBAN CARE LIMITED 26 avr. 198826 avr. 1988

    Quels sont les derniers comptes de COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 14 août 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    2 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 août 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 août 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 août 2015

    État du capital au 17 août 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Sanne Group Secretaries (Uk) Limited le 20 juil. 2015

    1 pagesCH04

    Changement d'adresse du siège social de C/O Sanne Group 2nd Floor Pollen House 10 Cork Street London W1S 3NP à Asticus Building, 2nd Floor 21 Palmer Street London SW1H 0AD le 05 août 2015

    1 pagesAD01

    Nomination de Jonathan David Farkas en tant qu'administrateur le 27 janv. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mathieu Streiff en tant que directeur le 27 janv. 2015

    1 pagesTM01

    legacy

    28 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT1

    legacy

    3 pagesGUARANTEE1

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mathieu Streiff le 31 mars 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Sanne Group Secretaries (Uk) Limited le 31 mars 2014

    1 pagesCH04

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Sanne Group 1 Berkeley Street London United Kingdom W1J 8DJ* le 08 avr. 2014

    1 pagesAD01

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2014 au 31 déc. 2013

    3 pagesAA01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    10 pagesAA

    Nomination de Sanne Group Secretaries (Uk) Limited en tant que secrétaire

    3 pagesAP04

    Qui sont les dirigeants de COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Secrétaire
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement8334728
    175738460001
    FARKAS, Jonathan David
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building, 2nd Floor 21
    Administrateur
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building, 2nd Floor 21
    LuxembourgAmerican193539990001
    BUTLER, John
    Magnolia Cottage
    Elm Close
    SL2 3NA Farnham Common
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Magnolia Cottage
    Elm Close
    SL2 3NA Farnham Common
    Buckinghamshire
    British4526760004
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Secrétaire
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    British52338530002
    BRONOCK, Brian Paul
    Well Springs Orchard Well Springs
    Brightwell Cum Sotwell
    OX10 0RN Wallingford
    Oxfordshire
    Administrateur
    Well Springs Orchard Well Springs
    Brightwell Cum Sotwell
    OX10 0RN Wallingford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish46299650003
    BRONOCK, Catherine Mary
    Wells Springs Orchard
    Well Springs, Brightwell Cumsotwell
    OX10 0RN Wallingford
    Oxfordshire
    Administrateur
    Wells Springs Orchard
    Well Springs, Brightwell Cumsotwell
    OX10 0RN Wallingford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish17925460002
    BUTLER, Brenda
    Magnolia Cottage
    Elm Close
    SL2 3NA Farnham Common
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Magnolia Cottage
    Elm Close
    SL2 3NA Farnham Common
    Buckinghamshire
    EnglandBritish10952670003
    BUTLER, John
    Magnolia Cottage
    Elm Close
    SL2 3NA Farnham Common
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Magnolia Cottage
    Elm Close
    SL2 3NA Farnham Common
    Buckinghamshire
    EnglandBritish4526760004
    CORMACK, Derek George
    Pillars
    Grantley Avenue, Wonersh
    GU5 0QN Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Pillars
    Grantley Avenue, Wonersh
    GU5 0QN Guildford
    Surrey
    EnglandIrish67400530015
    GRIFFIN, Craig
    Halebourne House
    Halebourne Lane
    GU24 8SL Chobham
    Surrey
    Administrateur
    Halebourne House
    Halebourne Lane
    GU24 8SL Chobham
    Surrey
    United KingdomBritish154122490001
    HILL, Peter Martin
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Administrateur
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritish130983750002
    JEFFERY, Paul Anthony Keith
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Administrateur
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritish65609290003
    LANGAN, Michael John
    68 Hitherbroom Road
    UB3 3AE Hayes
    Middlesex
    Administrateur
    68 Hitherbroom Road
    UB3 3AE Hayes
    Middlesex
    United KingdomBritish50177330001
    O'BRIEN, Bernard Vincent
    1 Braemar House
    Orchehill House Orchehill Avenue
    SL9 8QS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    1 Braemar House
    Orchehill House Orchehill Avenue
    SL9 8QS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British69342790002
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Administrateur
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritish148139420001
    STREIFF, Mathieu Bernard
    Pollen House
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    2nd Floor
    Administrateur
    Pollen House
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    2nd Floor
    United StatesAmerican200529310001
    WHITE, Ian James
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Administrateur
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritish133383410003
    WHITE, Ian James
    Wetherden Road
    Haughley
    IP14 3RE Stowmarket
    Wetherden Cottage
    Suffolk
    United Kingdom
    Administrateur
    Wetherden Road
    Haughley
    IP14 3RE Stowmarket
    Wetherden Cottage
    Suffolk
    United Kingdom
    EnglandBritish133383410003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building, 2nd Floor
    England
    06 avr. 2016
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building, 2nd Floor
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleThe Companies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement04258255
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 28 juil. 2010
    Livré le 06 août 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 06 août 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession and charge
    Créé le 17 janv. 2008
    Livré le 29 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 29 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 16 nov. 2007
    Livré le 27 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Ascot house 28 wingrove road fenham,34 and 36 wingrove road newcastle upon tynet/no's TY221509 and TY52154,bradbury house bradbury house new street braintree t/no ESX647090, cheshire house 22 st mary's road ashton on mersey t/no GM54543 (for details of further properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 28 oct. 2005
    Livré le 03 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All land in england and wales now vested in the chargor, all interests and rights in or relating to land or the proceeds of sale, all plant and machinery, all rental and other income. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transactions
    • 03 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 26 oct. 2001
    Livré le 30 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 oct. 2003Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 08 oct. 2003Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 14 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 14 févr. 1996
    Livré le 19 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or brocklan investments limited and/or burnham lodge care limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 18 févr. 1991
    Livré le 27 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or brocklan investments limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 25 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0