BLOOMFIELD SUPPLIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBLOOMFIELD SUPPLIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02253938
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BLOOMFIELD SUPPLIES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe BLOOMFIELD SUPPLIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Macfarlane Group Uk Ltd
    Siskin Parkway East
    CV3 4PE Middlemarch Business Park
    Coventry
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BLOOMFIELD SUPPLIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour BLOOMFIELD SUPPLIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    1 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    1 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 déc. 2015

    État du capital au 31 déc. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nomination de Mr John Love en tant que secrétaire le 08 mai 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Andrew Cotton en tant que secrétaire le 08 mai 2015

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 janv. 2015

    État du capital au 05 janv. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 janv. 2014

    État du capital au 06 janv. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Colin Griffiths en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Love le 12 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de BLOOMFIELD SUPPLIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LOVE, John
    Newton Place
    G3 7PY Glasgow
    21
    Scotland
    Secrétaire
    Newton Place
    G3 7PY Glasgow
    21
    Scotland
    197482940001
    GRAY, Ivor
    Newton Place
    G3 7PY Glasgow
    21
    United Kingdom
    Administrateur
    Newton Place
    G3 7PY Glasgow
    21
    United Kingdom
    ScotlandBritishAccountant62029390001
    LOVE, John
    Newton Place
    G3 7PY Glasgow
    21
    United Kingdom
    Administrateur
    Newton Place
    G3 7PY Glasgow
    21
    United Kingdom
    ScotlandBritishChartered Accountant48003560002
    COTTON, Andrew
    Newton Place
    G3 7PY Glasgow
    21
    United Kingdom
    Secrétaire
    Newton Place
    G3 7PY Glasgow
    21
    United Kingdom
    BritishAccountant116035180002
    GRIFFITHS, Colin Gerald
    The Cobbles
    Bath Road Eastington
    GL10 3AY Stonehouse
    Glos
    Secrétaire
    The Cobbles
    Bath Road Eastington
    GL10 3AY Stonehouse
    Glos
    British5258690007
    GRIFFITHS, Delan Roy
    15 Kensington Avenue
    Canton
    CF5 1BU Cardiff
    South Glamorgan
    Secrétaire
    15 Kensington Avenue
    Canton
    CF5 1BU Cardiff
    South Glamorgan
    British59850430003
    PHILLIPS, Kevin Nicholas
    4 Abbotswood Road
    Brockworth
    GL3 4NZ Gloucester
    Secrétaire
    4 Abbotswood Road
    Brockworth
    GL3 4NZ Gloucester
    BritishCompany Secretary/Director59850360002
    GARLAND, Roy Ernest
    17 Cotswold Gardens
    Longlevens
    GL2 0DR Gloucester
    Gloucestershire
    Administrateur
    17 Cotswold Gardens
    Longlevens
    GL2 0DR Gloucester
    Gloucestershire
    BritishDirector23691140002
    GRIFFITHS, Colin Gerald
    The Cobbles
    Bath Road Eastington
    GL10 3AY Stonehouse
    Glos
    Administrateur
    The Cobbles
    Bath Road Eastington
    GL10 3AY Stonehouse
    Glos
    EnglandBritishManaging Director5258690007
    GRIFFITHS, Delan Roy
    73 North Upton Lane
    Barnwood
    GL4 3XW Gloucester
    Gloucestershire
    Administrateur
    73 North Upton Lane
    Barnwood
    GL4 3XW Gloucester
    Gloucestershire
    BritishI T Manager59850430002
    GRIFFITHS, Linda
    73 North Upton Lane
    Barnwood
    GL4 7XW Gloucester
    Gloucestershire
    Administrateur
    73 North Upton Lane
    Barnwood
    GL4 7XW Gloucester
    Gloucestershire
    BritishCompany Secretary23691150001
    LAKE, Anthony
    19 Jasmine Close
    Abbeydale
    GL4 9FJ Gloucester
    Gloucestershire
    Administrateur
    19 Jasmine Close
    Abbeydale
    GL4 9FJ Gloucester
    Gloucestershire
    BritishSales Director25517910001
    PHILLIPS, Kevin Nicholas
    4 Abbotswood Road
    Brockworth
    GL3 4NZ Gloucester
    Administrateur
    4 Abbotswood Road
    Brockworth
    GL3 4NZ Gloucester
    EnglandBritishCompany Secretary/Director59850360002
    SMITHAM, Barry
    The Tythe Barn
    St. Weonards
    HR2 8NT Hereford
    Herefordshire
    Administrateur
    The Tythe Barn
    St. Weonards
    HR2 8NT Hereford
    Herefordshire
    BritishManaging Director65140550001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BLOOMFIELD SUPPLIES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Macfarlane Group Uk Limited
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    2
    England
    06 avr. 2016
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    2
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Acts
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement1630389
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    BLOOMFIELD SUPPLIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture deed
    Créé le 14 août 2002
    Livré le 24 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 24 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 déc. 2000
    Livré le 11 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land adjoining unit 1, 3A northbrook road gloucester gloucestershire title number GR192229.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 févr. 2000
    Livré le 02 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 1, 3A northbank road gloucester gloucestershire t/n GR87659.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 févr. 2000
    Livré le 10 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 28 févr. 1997
    Livré le 14 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit 1 3A northbrook road gloucester with the benefit of all rights licences guarantees rent deposit contracts deeds undertakings and warranties relating to the property any shares or membership rights in any management company for the property the goodwill of any business from time to time at the property any rental and all other payments whatever in respect of the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 sept. 1991
    Acquis le 30 juin 1995
    Livré le 08 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit 1 3A northbrook road gloucester gloucestershire t/n gr 87659.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 juil. 1995Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 21 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 29 mai 1991
    Acquis le 30 juin 1995
    Livré le 08 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £57,000 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit 1 3A northbrook road gloucester t/n gr 87659. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Life Assurance Company Limited
    Transactions
    • 08 juil. 1995Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 21 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 23 mai 1991
    Livré le 24 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge on all book & other debts, floating charge on all over the:-. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 24 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 24 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 23 nov. 1990
    Acquis le 30 juin 1995
    Livré le 08 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £115,000 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit 1 3A northbrook road gloucester gloucestershire t/n gr 87659.
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    Transactions
    • 08 juil. 1995Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 21 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 juin 1990
    Livré le 30 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Including heritable property & assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 30 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 08 avr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 avr. 1990
    Livré le 27 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Including heritable property & assets in scotland.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 27 avr. 1990Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0