AMEY DATEL LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | AMEY DATEL LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02254918 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe AMEY DATEL LIMITED ?
Adresse du siège social | Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de AMEY DATEL LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour AMEY DATEL LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 mai 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Latham Nelson le 25 nov. 2021 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Birch le 16 janv. 2020 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Mr Paul Birch en tant qu'administrateur le 15 janv. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Lee Milner en tant que directeur le 12 déc. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 11 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Sherard Secretariat Services Limited le 02 sept. 2019 | 1 pages | CH04 | ||||||||||
Modification des détails de Amey Ow Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 sept. 2019 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de The Sherard Building Edmund Halley Road Oxford OX4 4DQ à Chancery Exchange 10 Furnival Street London EC4A 1AB le 02 sept. 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2017 | 10 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 10 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 10 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Melvyn Ewell en tant que directeur le 31 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de AMEY DATEL LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secrétaire | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom |
| 109588620001 | ||||||||||
BIRCH, Paul | Administrateur | 142 Speke Road L19 2PH Liverpool The Matchworks England England | United Kingdom | British | Corporate Services Director | 76116640004 | ||||||||
NELSON, Andrew Latham | Administrateur | Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London Amey United Kingdom | England | British | Director | 36191090004 | ||||||||
HUI, Carol | Secrétaire | GU8 | British | 72371980001 | ||||||||||
LAWTON, Graham | Secrétaire | 25 Alder Grove FY6 8EJ Poulton Le Fylde Lancashire | British | 2382160001 | ||||||||||
PUGH, Graham John | Secrétaire | The Windmill Mill Lane Wrea Green PR4 2WP Preston Lancashire | British | 24512450001 | ||||||||||
SMITH, Michael John | Secrétaire | 63 Fields Road Haslingden BB4 6QA Rossendale Lancashire | British | 61711420001 | ||||||||||
TETLOW, John Richard | Secrétaire | Whittaker Court, Gawsworth New Hall Church Lane, Gawsworth SK11 9RQ Macclesfield Cheshire | British | Company Secretary | 68445840001 | |||||||||
ADAMS, Richard Hawthorn | Administrateur | Bramley Cottage Coppice Hill Chalford GL6 8DZ Stroud Gloucestershire | United Kingdom | British | Civil Engineer | 56940900001 | ||||||||
BATCHELOR, Graeme Warwick | Administrateur | 2 Brookway Wrea Green PR4 2NU Preston Lancashire | British | Director | 58892340002 | |||||||||
BRADBURY, Richard George | Administrateur | Beech Cottage Beech Lane WA6 6LP Norley Cheshire | British | Group Commercial Director | 42234330002 | |||||||||
CORCORAN, Paul | Administrateur | 2 Cohen Close Chilwell NG9 6RW Nottingham | United Kingdom | British | Engineer | 104822330002 | ||||||||
ENTWISTLE, Richard William | Administrateur | Crossways Crays Pond RG8 7QE Goring Heath Oxfordshire | British | Director | 50174710001 | |||||||||
ENTWISTLE, Richard William | Administrateur | Crossways Crays Pond RG8 7QE Goring Heath Oxfordshire | British | Director | 50174710001 | |||||||||
EWELL, Melvyn | Administrateur | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | England | British | Director | 61515760002 | ||||||||
FARRER, Andrew Peter | Administrateur | 21 Upper Westby Avenue Lytham St Annes FY8 5NH Lancashire | British | Technical Director | 56447940002 | |||||||||
FENTON, Christopher Victor | Administrateur | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building Oxfordshire | England | British | Managing Director | 114610580002 | ||||||||
KAYSER, Michael Arthur | Administrateur | 17 Hartsbourne Avenue WD23 1JP Bushey Heath Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 141893610001 | ||||||||
LEO, Jose | Administrateur | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | Spanish | Group Finance Director | 93348510004 | |||||||||
MCHALE, Damian | Administrateur | 5 Earle Close TS15 9SN Yarm Cleveland | British | Operations Director | 122992530001 | |||||||||
MILLER, David John | Administrateur | 1 Asmara Road NW2 3SS London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 152304230002 | ||||||||
MILNER, Andrew Lee | Administrateur | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building | England | British | Chartered Civil Engineer | 133714170002 | ||||||||
MOGG, Charles Michael | Administrateur | Ladywood Stray Church Road, Wilmcote CV37 9XD Stratford Upon Avon Warwickshire | British | Civil Engineer And Company Dir | 87961010001 | |||||||||
MURAD, Simon William | Administrateur | The Rookeries Roundabout Copse RH20 2RB West Chiltington West Sussex | United Kingdom | British | Director | 75114990001 | ||||||||
PEAT, Stephen Hedley | Administrateur | 25 Canynge Square Clifton BS8 3LB Bristol Avon | British | Director | 70137370001 | |||||||||
POWERS, Glenn Patrick | Administrateur | 23 Sefton Drive M28 2NG Worsley Manchester | British | Company Director | 72486520001 | |||||||||
PUGH, Graham John | Administrateur | The Windmill Mill Lane Wrea Green PR4 2WP Preston Lancashire | British | Director | 24512450001 | |||||||||
REEVES, William Thomas | Administrateur | 3 The Coppins Wildwood ST17 4QB Stafford Staffordshire | British | Company Director | 93316550001 | |||||||||
ROBINSON, John Hamilton | Administrateur | Bull Rush House 8 Kennett Place Chilton Foliat RG17 0TB Hungerford Berkshire | American | Engineer | 69410760003 | |||||||||
ROWAN, Darren | Administrateur | 37 Leach Lane FY8 3AN Lytham St Annes Lancashire | British | Company Director | 59425480001 | |||||||||
SIMPSON, Alan Keith | Administrateur | 4 Riversleigh Avenue FY8 5QZ Lytham St Annes Lancashire | British | Director | 34652910001 | |||||||||
STAPLES, Brian Lynn | Administrateur | Pendle House Castle Hill Prestbury SK10 4AR Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | Director | 55479560003 | ||||||||
SWEENEY, John Trevor | Administrateur | 6 Scarlet Oaks Portsmouth Road GU15 1RD Camberley Surrey | British | Chartered Accountant | 70137390001 | |||||||||
WEBSTER, Christopher Charles | Administrateur | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | Director | 154210550001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AMEY DATEL LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amey Ow Limited | 06 avr. 2016 | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
|
AMEY DATEL LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Fixed and floating security document | Créé le 14 mars 2003 Livré le 26 mars 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 03 août 1998 Livré le 05 août 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0