MACBROWN FORK TRUCK SERVICES LIMITED

MACBROWN FORK TRUCK SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMACBROWN FORK TRUCK SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02255353
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MACBROWN FORK TRUCK SERVICES LIMITED ?

    • Commerce de gros de machines-outils (46620) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe MACBROWN FORK TRUCK SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Impact Fork Trucks Limited Gainsborough Business Park
    Long Eaton
    NG10 1PX Nottingham
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MACBROWN FORK TRUCK SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FORCETERM LIMITED10 mai 198810 mai 1988

    Quels sont les derniers comptes de MACBROWN FORK TRUCK SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour MACBROWN FORK TRUCK SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    État du capital au 04 nov. 2022

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 14 sept. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2021

    3 pagesAA

    Période comptable actuelle prolongée du 31 août 2021 au 31 déc. 2021

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 14 sept. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Statuts

    36 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de Robin Andrew Harris en tant que directeur le 15 juin 2021

    1 pagesTM01

    Comptes de micro-entité établis au 31 août 2020

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 sept. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 août 2019

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 sept. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 août 2018

    26 pagesAA

    Période comptable précédente prolongée du 31 mai 2018 au 31 août 2018

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 14 sept. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mai 2017

    12 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 31 août 2017 au 31 mai 2017

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de David Anthony Macmillan en tant que secrétaire le 08 déc. 2017

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de MACBROWN FORK TRUCK SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HARRIS, Robin Andrew
    Gainsborough Business Park
    Long Eaton
    NG10 1PX Nottingham
    Impact Fork Trucks Limited
    England
    Secrétaire
    Gainsborough Business Park
    Long Eaton
    NG10 1PX Nottingham
    Impact Fork Trucks Limited
    England
    241143940001
    KENDREW, Terence
    Gainsborough Business Park
    Long Eaton
    NG10 1PX Nottingham
    Impact Fork Trucks Limited
    England
    Administrateur
    Gainsborough Business Park
    Long Eaton
    NG10 1PX Nottingham
    Impact Fork Trucks Limited
    England
    EnglandBritishManaging Director97753870001
    MACMILLAN, David Anthony
    Brandy Carr Road
    Kirkhamgate
    WF2 0RE Wakefield
    236
    United Kingdom
    Secrétaire
    Brandy Carr Road
    Kirkhamgate
    WF2 0RE Wakefield
    236
    United Kingdom
    British17952990001
    ASQUITH, Claire
    Brandy Carr Road
    Kirkhamgate
    WF2 0RJ Wakefield
    102
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Brandy Carr Road
    Kirkhamgate
    WF2 0RJ Wakefield
    102
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director124601210002
    ASQUITH, Stuart
    Brandy Carr Road
    Kirkhamgate
    WF2 0RJ Wakefield
    102
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Brandy Carr Road
    Kirkhamgate
    WF2 0RJ Wakefield
    102
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director124601220002
    BROWN, Ernest John
    47 Kingsley Avenue
    Milnthorpe
    WF2 7EA Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    47 Kingsley Avenue
    Milnthorpe
    WF2 7EA Wakefield
    West Yorkshire
    BritishEngineer17953000001
    BROWN, Marcia
    47 Kingsley Avenue
    Milnthorpe
    WF2 7EA Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    47 Kingsley Avenue
    Milnthorpe
    WF2 7EA Wakefield
    West Yorkshire
    BritishCompany Director40521930001
    HARRIS, Robin Andrew
    Gainsborough Business Park
    Long Eaton
    NG10 1PX Nottingham
    Impact Fork Trucks Limited
    England
    Administrateur
    Gainsborough Business Park
    Long Eaton
    NG10 1PX Nottingham
    Impact Fork Trucks Limited
    England
    EnglandBritishFinance Director101078040001
    MACMILLAN, David Anthony
    Brandy Carr Road
    Kirkhamgate
    WF2 0RE Wakefield
    236
    United Kingdom
    Administrateur
    Brandy Carr Road
    Kirkhamgate
    WF2 0RE Wakefield
    236
    United Kingdom
    United KingdomBritishEngineer17952990002
    MACMILLAN, Lynne Patricia
    Brandy Carr Road
    Kirkhamgate
    WF2 0RE Wakefield
    236
    United Kingdom
    Administrateur
    Brandy Carr Road
    Kirkhamgate
    WF2 0RE Wakefield
    236
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director32596460002
    STARK, Richard
    Clarendon Street
    S70 6AH Barnsley
    28
    United Kingdom
    Administrateur
    Clarendon Street
    S70 6AH Barnsley
    28
    United Kingdom
    United KingdomBritish Sales175548920001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MACBROWN FORK TRUCK SERVICES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    58 High Street
    HU1 1QE Hull
    Citadel House
    England
    08 déc. 2017
    58 High Street
    HU1 1QE Hull
    Citadel House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement02550150
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Mrs Lynne Patricia Macmillan
    Gainsborough Business Park
    Long Eaton
    NG10 1PX Nottingham
    Impact Fork Trucks Services Limited
    England
    06 avr. 2016
    Gainsborough Business Park
    Long Eaton
    NG10 1PX Nottingham
    Impact Fork Trucks Services Limited
    England
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    David Anthony Macmillan
    Gainsborough Business Park
    Long Eaton
    NG10 1PX Nottingham
    Impact Fork Trucks Services Limited
    England
    06 avr. 2016
    Gainsborough Business Park
    Long Eaton
    NG10 1PX Nottingham
    Impact Fork Trucks Services Limited
    England
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Claire Asquith
    95 Wakefield Road, Ossett
    Wakefield
    WF5 9JY West Yorkshire
    06 avr. 2016
    95 Wakefield Road, Ossett
    Wakefield
    WF5 9JY West Yorkshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Stuart Asquith
    95 Wakefield Road, Ossett
    Wakefield
    WF5 9JY West Yorkshire
    06 avr. 2016
    95 Wakefield Road, Ossett
    Wakefield
    WF5 9JY West Yorkshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    MACBROWN FORK TRUCK SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Long term licence to sub-let
    Créé le 10 juin 2010
    Livré le 12 juin 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The sub-letting agreements and the benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities.
    Personnes ayant droit
    • Ing Lease (UK) Limited
    Transactions
    • 12 juin 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 déc. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Long-term licence to sub-let
    Créé le 30 juil. 2009
    Livré le 07 août 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The sub-letting agreements the benefit of all guarantees, indemnities neogotiable instruments and securities.
    Personnes ayant droit
    • Ing Lease (UK) LTD
    Transactions
    • 07 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 déc. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 22 sept. 1997
    Livré le 25 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 déc. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplementary schedule
    Créé le 21 nov. 1996
    Livré le 22 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the schedule
    Brèves mentions
    All the company's rights title and interest in and to the sub-hire agreements being agreement dated 23/10/94 with turner soham together with the benefit of all ancillary contracts relating thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royscot Industrial Leasing Limited
    Transactions
    • 22 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 déc. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplementary schedule executed pursuant to a master agreement dated 15/2/95
    Créé le 02 sept. 1996
    Livré le 20 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the company's rights title and interest in the sub-hire agreements in the attached schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royscot Leasing Limited
    Transactions
    • 20 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 déc. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Master agreement
    Créé le 15 févr. 1995
    Livré le 20 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rights title & interest in the sub-hire agreements from time to time entered into pursuant to the master agreement & in all ancillary contracts relating thereto, all contracts, sub-hire agreements etc. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royscot Trust PLC, Royscot Leasing Limited, Royscot Industrial Leasing Limited, Royscotcommercial Leasing Limited and Royscot Spa Leasing Limited
    Transactions
    • 20 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 déc. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 17 janv. 1990
    Livré le 20 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 20 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 24 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0