BMBF (NO.12) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBMBF (NO.12) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02259175
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BMBF (NO.12) LIMITED ?

    • Crédit-bail (64910) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe BMBF (NO.12) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House 1
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BMBF (NO.12) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour BMBF (NO.12) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    12 pagesLIQ13

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 1 Churchill Place London E14 5HP à Barclays Group Archives Dallimore Road Wythenshawe Manchester M23 9JA

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de , 1 Churchill Place, London, E14 5HP, England à Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR le 16 mai 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 27 avr. 2017

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré 1 Churchill Place London E14 5HP

    1 pagesAD04

    Changement d'adresse du siège social de , Churchill Plaza, Churchill Way, Basingstoke, Hampshire, RG21 7GP à Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR le 19 sept. 2016

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    28 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 juin 2016

    État du capital au 24 juin 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nomination de Mr Vukkalam Rangaswami Praveen Kumar en tant qu'administrateur le 20 mai 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ketan Dhirendra Merchant en tant que directeur le 16 févr. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jonathan Terence Leather en tant que directeur le 23 nov. 2015

    2 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    34 pagesAA

    Nomination de Mr Ketan Dhirendra Merchant en tant qu'administrateur le 12 août 2015

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 août 2015

    État du capital au 12 août 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 mai 2015

    État du capital au 12 mai 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    32 pagesAA

    Nomination de David Charles Hawkins en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 mai 2014

    État du capital au 16 mai 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cessation de la nomination de Andrew Asquith en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Andrew Martin Granville Asquith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Duncan Rowberry en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de BMBF (NO.12) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BARCOSEC LIMITED
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Secrétaire
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    49004930002
    BOLTON, Stephen Geoffrey
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish177906520001
    HAWKINS, David Charles
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish188138870001
    KUMAR, Vukkalam Rangaswami Praveen
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    IndiaIndian207316480001
    OTTAWAY, Angela Nicole
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish169152200001
    LEATHER, Jonathan Terence
    57 The Crofts
    Hatch Warren
    RG22 4RE Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    57 The Crofts
    Hatch Warren
    RG22 4RE Basingstoke
    Hampshire
    British69140360001
    SHOOLBRED, Charles Frederick
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    Secrétaire
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    British540290002
    ABLITT, Denis Raymond
    Woodcocks
    38 Park Avenue, Old Basing
    RG24 7HT Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Woodcocks
    38 Park Avenue, Old Basing
    RG24 7HT Basingstoke
    Hampshire
    British71782000001
    ASQUITH, Andrew Martin Granville
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish77784310001
    BOOBYER, Christopher Leslie Richard
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Administrateur
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    British92233050001
    BOX, Sarah
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    Administrateur
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    British47381630004
    CALLENDER, John Dalrymple
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    Administrateur
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    United KingdomBritish2444200001
    CALVERT, Ashley
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish166501700001
    CLARK, Thomas Martin
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    British5529800001
    DOWDING, Eric Robert
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    Administrateur
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    British46728970001
    ELLIS, David James
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    Administrateur
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    EnglandBritish113760650001
    EVANS, Christopher Hewitt
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British121774150001
    HARE, Darren Mark
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish127470250001
    HASSELL, Brian Charles
    10 Blenheim Close
    CM21 0BE Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    10 Blenheim Close
    CM21 0BE Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Great BritainBritish45384250002
    HILLS, Richard Allan
    11 Countess Gardens
    Littledown
    BH7 7RR Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    11 Countess Gardens
    Littledown
    BH7 7RR Bournemouth
    Dorset
    United KingdomBritish71778800001
    LEATHER, Jonathan Terence
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish69140360004
    MACINTOSH, Gordon Paterson
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    Administrateur
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    British25737780001
    MARCHANT, Jeremy
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish154144600001
    MCMILLAN, Richard John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British68601920003
    MERCHANT, Ketan Dhirendra
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    IndiaIndian200060960001
    MILES, Martin Graham
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish108439150001
    RIDOUT, Thomas Geoffrey
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish155056490001
    ROSE, Stephen George
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British143870380001
    ROWAN, Charles Paul
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    British49237910001
    ROWBERRY, Duncan John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish49237880004
    SILCOCK, Frank Avis
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    Administrateur
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    British32895910001
    WATSON, Hazel Anne Marie
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandIrish122291210001
    WEAL, Barry
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    British40203100001
    WEAVING, John Martin
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    Administrateur
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    British58523120001
    BARCOSEC LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Administrateur
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    49004930001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BMBF (NO.12) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    06 avr. 2016
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement898129
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    BMBF (NO.12) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A first preferred vanuatu ship mortgage
    Créé le 16 avr. 2004
    Livré le 26 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Right title and interest in and to the vessel. (Motor vessel 'gsf jack ryan' registered under the vanuatu flag with official number 1561). see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Globalsantafe International Drilling Corporation
    Transactions
    • 26 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 déc. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Account assignment schedule no:52/5050 5371-3
    Créé le 22 janv. 2001
    Livré le 25 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The obligations of the company to make payment to the chargee of any and all moneys by way of rebate of rental in accordance with clauses 10.2 and 20.2 of the lease (as defined)
    Brèves mentions
    The account which means the account of the company withe the account bank with account number 10353817 and designated "global marine inc.,glomar jack ryan" and the amount standing to the credit of the account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Global Marine International Drilling Corporation
    Transactions
    • 25 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 déc. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    First preferred panamanian naval mortgage
    Créé le 26 oct. 2000
    Livré le 10 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee to effect a transfer of title to the vessel being the M.V. "glomar jack ryan" under any sale contract entered into in accordance with clause 19.2 of the head lease being a lease agreement dated 8TH december 1998 between the company and chargee in respect of the vessel and all moneys by way of rebate of rental under clause 20.2 of said head lease
    Brèves mentions
    All the company's right title benefit and interest in and to the vessel in accordance with the provisions of chapter v title iv of book second of the code of commerce of the republic of panama.
    Personnes ayant droit
    • Global Marine International Drilling Corporation
    Transactions
    • 10 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 déc. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Secondary lease security assignment
    Créé le 30 déc. 1992
    Livré le 13 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from i/s oktober-gruppen and /or kim F. rasmussen under the terms of the loan agreement dated 30/12/92
    Brèves mentions
    All th elessees right title interest in and to the assigned payments.see form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sublessee security agreement
    Créé le 30 déc. 1992
    Livré le 14 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sublease dated and the head lease both dated 24/11/92
    Brèves mentions
    All rights title interest in and to the head lease and head security agreement.see form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Triborough Bridge and Tunnel Authority
    Transactions
    • 14 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BMBF (NO.12) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    2
    DateType
    27 avr. 2017Commencement of winding up
    22 nov. 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian Harvey Dean
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0