BMBF (NO.21) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | BMBF (NO.21) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02260145 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BMBF (NO.21) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BMBF (NO.21) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour BMBF (NO.21) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 12 pages | LIQ13 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1 Churchill Place London E14 5HP England à Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR le 05 juin 2018 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 4 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 1 Churchill Place London E14 5HP à Barclays Group Archives Dallimore Road Wythenshawe Manchester M23 9JA | 2 pages | AD02 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 02 mai 2018
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 27 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2017 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré 1 Churchill Place London E14 5HP | 1 pages | AD04 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 10 mars 2017
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Churchill Plaza Churchill Way Basingstoke Hampshire RG21 7GP à 1 Churchill Place London E14 5HP le 19 sept. 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 27 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de David Charles Hawkins en tant qu'administrateur le 17 déc. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Stephen Geoffrey Bolton en tant qu'administrateur le 17 déc. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Angela Nicole Ottaway en tant qu'administrateur le 17 déc. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jonathan Terence Leather en tant que directeur le 20 août 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gavin John Simpson en tant que directeur le 24 août 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 août 2015 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de BMBF (NO.21) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCOSEC LIMITED | Secrétaire | 1 Churchill Place E14 5HP London | 49004930002 | |||||||
| BOLTON, Stephen Geoffrey | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | England | British | 177906520001 | |||||
| HAWKINS, David Charles | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | England | British | 188138870001 | |||||
| KHAIROV, Enver | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 107219950001 | |||||
| OTTAWAY, Angela Nicole | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 169152200001 | |||||
| RUFFELL, Lara Catherine | Secrétaire | 23 Meadowlands Chineham RG24 8XL Basingstoke Hampshire | British | 69140140002 | ||||||
| SHOOLBRED, Charles Frederick | Secrétaire | Timbers Dean Oak Lane RH2 8PZ Leigh Surrey | British | 540290002 | ||||||
| ABLITT, Denis Raymond | Administrateur | Woodcocks 38 Park Avenue, Old Basing RG24 7HT Basingstoke Hampshire | British | 71782000001 | ||||||
| AKRAM, Mohammed | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 169142800001 | |||||
| BOOBYER, Christopher Leslie Richard | Administrateur | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | British | 92233050001 | ||||||
| BOX, Sarah | Administrateur | Court Lodge Lower Road West Farleigh ME15 0PD Maidstone Kent | British | 47381630004 | ||||||
| CALLENDER, John Dalrymple | Administrateur | Fairway Heights GU15 1NJ Camberley 14 Surrey | United Kingdom | British | 2444200001 | |||||
| CLARK, Thomas Martin | Administrateur | Hatch Hill Hatch Lane Kingsley Green GU27 3LJ Haslemere Surrey | British | 5529800001 | ||||||
| DOWDING, Eric Robert | Administrateur | 23 Waldorf Heights Blackwater Howley Hill GU17 9JH Camberley Surrey | British | 46728970001 | ||||||
| ELLIS, David James | Administrateur | Batts Row Cottage Laverstoke Lane, Laverstoke RG28 7PA Whitchurch Hampshire | England | British | 113760650001 | |||||
| EVANS, Christopher Hewitt | Administrateur | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 121774150001 | ||||||
| HARE, Darren Mark | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 127470250001 | |||||
| HILLS, Richard Allan | Administrateur | 11 Countess Gardens Littledown BH7 7RR Bournemouth Dorset | United Kingdom | British | 71778800001 | |||||
| HUCKLE, Jonathan Mark | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 163223760001 | |||||
| LEATHER, Jonathan Terence | Administrateur | 1 Churchill Place E14 5HP London | England | British | 69140360004 | |||||
| MACINTOSH, Gordon Paterson | Administrateur | 7 Paddock Field Chilbolton SO20 6AU Stockbridge Hampshire | British | 25737780001 | ||||||
| MCMILLAN, Richard John | Administrateur | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 68601920003 | ||||||
| MILES, Martin Graham | Administrateur | 1 Churchill Place E14 5HP London | United Kingdom | British | 108439150001 | |||||
| RIDOUT, Thomas Geoffrey | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | England | British | 155056490001 | |||||
| ROSE, Stephen George | Administrateur | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 143870380001 | ||||||
| ROWAN, Charles Paul | Administrateur | 32 Queens Park West Drive Queens Park BH8 9DD Bournemouth Dorset | British | 49237910001 | ||||||
| ROWBERRY, Duncan John | Administrateur | 1 Churchill Place E14 5HP London | England | British | 49237880004 | |||||
| SILCOCK, Frank Avis | Administrateur | Charleston 74 Wellhouse Road Beech GU34 4AG Alton Hampshire | British | 32895910001 | ||||||
| SIMPSON, Gavin John | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 149333050001 | |||||
| WATSON, Hazel Anne Marie | Administrateur | 1 Churchill Place E14 5HP London | England | Irish | 122291210001 | |||||
| WEAL, Barry | Administrateur | Orchard Gate Mill Lane Bramley GU5 0HW Guildford Surrey | British | 40203100001 | ||||||
| WEAVING, John Martin | Administrateur | 57 Bridle Way Colehill BH21 2UP Wimborne Dorset | British | 58523120001 | ||||||
| BARCOSEC LIMITED | Administrateur | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | 49004930001 | |||||||
| BAROMETERS LIMITED | Administrateur | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | 57357300002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BMBF (NO.21) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barclays Mercantile Business Finance Limited | 06 avr. 2016 | Churchill Place E14 5HP London 1 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
BMBF (NO.21) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| First preferred vanuatu mortgage | Créé le 06 oct. 2010 Livré le 15 oct. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The motor vessel "gsf jack ryan" with official no: 1561 see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Account assignment | Créé le 06 oct. 2010 Livré le 12 oct. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The credit balance in relation to the account. Account means account number 10353817 sort code 20 00 00 see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
BMBF (NO.21) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0