P.A. WHITTINGTON (DEVELOPMENTS) LIMITED

P.A. WHITTINGTON (DEVELOPMENTS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéP.A. WHITTINGTON (DEVELOPMENTS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02262239
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de P.A. WHITTINGTON (DEVELOPMENTS) LIMITED ?

    • Administration de biens immobiliers pour compte de tiers (68320) / Activités immobilières

    Où se situe P.A. WHITTINGTON (DEVELOPMENTS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Willow Barn Manor Road
    Stutton
    LS24 9BR Tadcaster
    North Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de P.A. WHITTINGTON (DEVELOPMENTS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GLOBALCERTAIN LIMITED26 mai 198826 mai 1988

    Quels sont les derniers comptes de P.A. WHITTINGTON (DEVELOPMENTS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour P.A. WHITTINGTON (DEVELOPMENTS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021

    7 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2019

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 mars 2017

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2016

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 janv. 2016

    État du capital au 19 janv. 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 janv. 2015

    État du capital au 09 janv. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2014

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 janv. 2014

    État du capital au 28 janv. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2012

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2010

    10 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de P.A. WHITTINGTON (DEVELOPMENTS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WHITTINGTON, Peter Alan
    Willow Barn
    Manor Road
    LS25 9BR Stutton
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Willow Barn
    Manor Road
    LS25 9BR Stutton
    North Yorkshire
    British106159980001
    WHITTINGTON, Penelope Ann
    Willow Barn
    Manor Road Stutton
    LS24 9BR Tadcaster
    N Yorks
    Administrateur
    Willow Barn
    Manor Road Stutton
    LS24 9BR Tadcaster
    N Yorks
    EnglandBritish4226330001
    WHITTINGTON, Peter Alan
    Willow Barn
    Manor Road
    LS25 9BR Stutton
    North Yorkshire
    Administrateur
    Willow Barn
    Manor Road
    LS25 9BR Stutton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish106159980001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur P.A. WHITTINGTON (DEVELOPMENTS) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Peter Alan Whittington
    Willow Barn Manor Road
    Stutton
    LS24 9BR Tadcaster
    North Yorkshire
    31 déc. 2016
    Willow Barn Manor Road
    Stutton
    LS24 9BR Tadcaster
    North Yorkshire
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.

    P.A. WHITTINGTON (DEVELOPMENTS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 03 avr. 2003
    Livré le 05 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    79 high street starbeck harrogate north yorkshire HG2 7LH. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 août 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 juil. 2002
    Livré le 12 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    402 meanwood road leeds west yorkshire LS6 2LP. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 août 2001
    Livré le 30 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage 34 cross speedwell street woodhouse leeds LS6 2SG. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 27 mars 2000
    Livré le 07 avr. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as 1 west grove road harrowgate north yorkshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 27 févr. 1998
    Livré le 05 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property k/a 40 reginald mount leeds west yorkshire t/n WYK464625. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 23 janv. 1998
    Livré le 06 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 44 reginald mount leeds west yorkshire t/n WYK543194. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 27 avr. 1990
    Livré le 03 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    16 beeches eng hall park boston spa near wetherby west yorkshire t/no wyk 171110 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 11 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0