PEOPLES PHONE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPEOPLES PHONE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02262870
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PEOPLES PHONE LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe PEOPLES PHONE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PEOPLES PHONE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THE PEOPLES PHONE COMPANY PLC28 févr. 199428 févr. 1994
    CELLULAR COMMUNICATIONS CORPORATION PLC27 mai 198827 mai 1988

    Quels sont les derniers comptes de PEOPLES PHONE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour PEOPLES PHONE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 19 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 16 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 15 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 17 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 14 en totalité

    1 pagesMR04

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 07 mars 2018

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share premium a/c 22/02/2018
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Vodafone House the Connection Newbury Berkshire RG14 2FN

    1 pagesAD04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 mars 2016

    État du capital au 14 mars 2016

    • Capital: GBP 437,028
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de PEOPLES PHONE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2357692
    75473330004
    EVANS, David Nigel
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector134975040001
    MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director173703620001
    DAWE-LANE, Patrick John Beachim
    Marsh Lane
    Rowde
    SN10 1RE Devizes
    Upper Foxhangers Farm
    Wiltshire
    England
    Secrétaire
    Marsh Lane
    Rowde
    SN10 1RE Devizes
    Upper Foxhangers Farm
    Wiltshire
    England
    Other130771170001
    EMETULU, Lola
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British88619360002
    HOWIE, Philip Robert Sutherland
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British77939460004
    PARRISH, Keith John
    33 Reads Field
    Four Marks
    GU34 5XA Alton
    Hampshire
    Secrétaire
    33 Reads Field
    Four Marks
    GU34 5XA Alton
    Hampshire
    British65075990001
    SCOTT, Stephen Roy
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    BritishCompany Secretary25660590003
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishDirector123612980001
    BAMFORD, Peter Richard
    Lantern House
    4a Queens Gate Place
    SW7 5NT London
    Administrateur
    Lantern House
    4a Queens Gate Place
    SW7 5NT London
    BritishDirector54076100002
    BEST, Pauline Ann
    Honeysuckle Cottage
    Sutton Lane Sutton
    OX29 5RU Witney
    Oxfordshire
    Administrateur
    Honeysuckle Cottage
    Sutton Lane Sutton
    OX29 5RU Witney
    Oxfordshire
    BritishHuman Resources Director68015830001
    BISWAS, Sumit Kumar
    21 South Street
    OX2 0BE Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    21 South Street
    OX2 0BE Oxford
    Oxfordshire
    BritishDirector63870460001
    BREWER, Stephen
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Director79186090002
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Administrateur
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    BritishDirector83126790001
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishDirector99525280001
    EDWARDS, Peter David
    Hockets
    Oriental Road
    SL5 7AZ Sunninghill
    Berkshire
    Administrateur
    Hockets
    Oriental Road
    SL5 7AZ Sunninghill
    Berkshire
    BritishDirector1908570001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishChief Financial Officer127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishSenior Finance Manager158146620001
    FREEMAN, William Ian Bede
    Herons Cottage
    Ferry Lane, Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Herons Cottage
    Ferry Lane, Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector64442870001
    GARDNER, Malcolm William
    Dryson House Edge Business Centre
    Humber Road
    NW2 6EW London
    Administrateur
    Dryson House Edge Business Centre
    Humber Road
    NW2 6EW London
    BritishCompany Director48770690002
    GENT, Christopher Charles
    Crowshott
    Highclere
    RG20 9RY Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Crowshott
    Highclere
    RG20 9RY Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Director50867930001
    GIBBINS, Michael Edward Stanley
    36 Hurlingham Square
    Peterborough Road
    SW6 3DZ London
    Administrateur
    36 Hurlingham Square
    Peterborough Road
    SW6 3DZ London
    BritishDirector39579200001
    GRAY, Ian
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    Administrateur
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    United KingdomBritishDirector50246030004
    HALFORD, Andrew Nigel
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    BritishDirector33951180005
    HANFORD, Raymond Clifford
    Romney Cottage Park Horsley
    East Horsley
    KT24 5RZ Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Romney Cottage Park Horsley
    East Horsley
    KT24 5RZ Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant45868080001
    HANFORD, Raymond Clifford
    Romney Cottage Park Horsley
    East Horsley
    KT24 5RZ Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Romney Cottage Park Horsley
    East Horsley
    KT24 5RZ Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant45868080001
    HEXT, Jane Helen
    2 Saint Katherines
    Winterbourne Bassett
    SN4 9QG Swindon
    Wiltshire
    Administrateur
    2 Saint Katherines
    Winterbourne Bassett
    SN4 9QG Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector152305810001
    HOLMES, Stephen Edward
    Parsonage Farm
    Stanbridge Earls
    SO51 0HE Romsey
    Hampshire
    Administrateur
    Parsonage Farm
    Stanbridge Earls
    SO51 0HE Romsey
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director6218790003
    JONES, David Leslie
    Three Oak Barn
    RH14 0PY Plaistow
    West Sussex
    Administrateur
    Three Oak Barn
    RH14 0PY Plaistow
    West Sussex
    BritishCompany Director83517310001
    KEAYS, Helen Margaret
    Clematis Cottage
    Old Warwick Road Rowington
    CV35 7AA Warwick
    Warwickshire
    Administrateur
    Clematis Cottage
    Old Warwick Road Rowington
    CV35 7AA Warwick
    Warwickshire
    BritishDirector55393460002
    KEY, Matthew David
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishDirector62981720001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Administrateur
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritishDirector24471140001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishDirector86697870001
    MELHUISH-HANCOCK, Douglas Charles
    22 Nightingale House
    E1W 1UA London
    Administrateur
    22 Nightingale House
    E1W 1UA London
    United KingdomBritishChartered Accountant6218780001
    NOWAK, Thomas, Dr
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomGermanDirector174443800001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PEOPLES PHONE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement3381659
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    PEOPLES PHONE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of rental deposit
    Créé le 13 mai 1998
    Livré le 20 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a lease dated 9TH december 1992
    Brèves mentions
    The sum of £32,500 together with all other sums to be paid into the account.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 20 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mai 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 16 oct. 1995
    Livré le 18 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the debenture and under the facility letter and/or in each case any deed or document supplemental thereto
    Brèves mentions
    Units 2,3 & 4 edge business centre humber road london NW2 6EF t/nos.NGL643301 NGL643288 and NGL668789. Peoples phone house edgware road london NW2 being the f/h property formerly k/a carlton forge garage edgware road cricklewood t/no. NGL525914. Victory park edgware road london being the f/h property on the north east side of edgware road cricklewood t/nos.NGL638762 NGL697023. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 18 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 08 août 1995
    Livré le 09 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company to the chargees pursuant to the terms of a lease dated 22/9/86
    Brèves mentions
    The amount from time to time standing to the credit of an interest earning deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Peter Francis Ringrose David Michael Flather and Alexander Humphrey Fletcher
    Transactions
    • 09 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mai 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 23 mai 1995
    Livré le 09 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 6TH january 1978
    Brèves mentions
    All amounts which are now or which may from time to time be standing to the credit of the account number 10733040 with barclays bank PLC.
    Personnes ayant droit
    • Pentagon Developments (Chatham) Limited
    Transactions
    • 09 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mai 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 07 avr. 1995
    Livré le 13 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an underlease dated 15 april 1985 and this deed
    Brèves mentions
    £17,250 in a separate designated deposit account in the name of dibb lupton broomhead solicitors to the chargee.
    Personnes ayant droit
    • Dollond & Aitchison Group (Holdings) Limited
    Transactions
    • 13 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mai 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 27 janv. 1995
    Livré le 07 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £13,500 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    £13,500 in a separate designated deposit account in the name of dibb lupton broomhead solicitors to the chargee.
    Personnes ayant droit
    • Dollond & Aitchison Group (Holdings) Limited
    Transactions
    • 07 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mai 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 17 janv. 1995
    Livré le 21 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £17,000 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    £17,000 in a separate designated deposit account in the name of dibb lupton broomhead solicitors to the chargee.
    Personnes ayant droit
    • Dollond & Aitchison Group (Holdings) Limited
    Transactions
    • 21 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mai 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 11 janv. 1995
    Livré le 13 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The company's obligations to the chargee under the terms of the lease
    Brèves mentions
    The amount of the deposit being £11,875.00 together with any additions thereto pursuant to the provisions of the deed.
    Personnes ayant droit
    • Signet Group PLC
    Transactions
    • 13 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mai 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 22 déc. 1994
    Livré le 04 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the loan agreement
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hawthorn Leslie Group Limited
    Transactions
    • 04 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of charge
    Créé le 22 déc. 1994
    Livré le 24 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of the services provider agreements (as defined) or on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The interest of the company in it's customers from time to time and all goodwill associated with the vodafon network and benefit of the service provider agreements see form 395 for full details of all charged assets.
    Personnes ayant droit
    • Vodafone Limited
    Transactions
    • 24 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 janv. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Agreement and charge
    Créé le 22 déc. 1994
    Livré le 23 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility documents (as defined)
    Brèves mentions
    By way of equitable assignment all it's right title interest and benefit in and to the receivables. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 03 oct. 1994
    Livré le 04 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The obligations of the purchaser to the vendor under the terms of the lease
    Brèves mentions
    The amount of the deposit being £3,125.00 together with any additions thereto pursuant to the provisions of the deed.
    Personnes ayant droit
    • Signet Group PLC
    Transactions
    • 04 oct. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mai 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 11 août 1994
    Livré le 19 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The company's obligations to the chargee under the terms of the leases
    Brèves mentions
    The amount of deposit being 411.542.00 together with any additions thereto pursuant to the provisions of the deed.
    Personnes ayant droit
    • Signet Group PLC
    Transactions
    • 19 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mai 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 11 août 1994
    Livré le 19 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The company's obligations to the chargee under the terms of the leases
    Brèves mentions
    The amount of deposit being £115,656.oo together with any additions thereto pursuant to the provisions of the deed.
    Personnes ayant droit
    • Signet Group PLC
    Transactions
    • 19 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mai 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Instrument
    Créé le 14 janv. 1994
    Livré le 27 janv. 1994
    Date de l'acte de garantie 14 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Personnes ayant droit
    • Singer & Friedlander Group PLC
    Transactions
    • 27 janv. 1994Enregistrement d'une charge pour garantir une série de débentures (397)
    • 29 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of deposit
    Créé le 28 juil. 1989
    Livré le 01 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 28.7.89
    Brèves mentions
    The companys' interest in the deposit account.
    Personnes ayant droit
    • P & R Properties Limited
    Transactions
    • 01 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 07 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 juin 1989
    Livré le 14 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that l/h property k/a unit 1 the edge business centre, humber rd london NW2 including all fixed & moveable plant & machinery & fixture furniture implements & utensils & the goodwill of the business of a licensed hotelier & the benefit of all justices' excise or other licences.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transactions
    • 14 juin 1989Enregistrement d'une charge
    • 12 nov. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 nov. 1988
    Livré le 21 nov. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan stock as defined in the deed.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Ocean Venture Limited
    Transactions
    • 21 nov. 1988Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 08 nov. 1988
    Livré le 10 nov. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures & fittings fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 nov. 1988Enregistrement d'une charge
    • 07 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0