MYTRE PROPERTY TRUST LIMITED

MYTRE PROPERTY TRUST LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMYTRE PROPERTY TRUST LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02265367
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MYTRE PROPERTY TRUST LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe MYTRE PROPERTY TRUST LIMITED ?

    Adresse du siège social
    10 Upper Berkeley Street
    London
    W1H 7PE
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MYTRE PROPERTY TRUST LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RAPID 6224 LIMITED07 juin 198807 juin 1988

    Quels sont les derniers comptes de MYTRE PROPERTY TRUST LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour MYTRE PROPERTY TRUST LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    pagesGAZ1(A)

    Déclaration de confirmation établie le 07 juin 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2020

    5 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 01 oct. 2020

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 07 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2019

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Richard Jeremy De Barr en tant que secrétaire le 23 juin 2017

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 07 juin 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Neil Steinberg le 02 mai 2017

    2 pagesCH01

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 juil. 2016

    État du capital au 06 juil. 2016

    • Capital: GBP 5,011,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Steven Ross Collins le 01 sept. 2015

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2015

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 juil. 2015

    État du capital au 22 juil. 2015

    • Capital: GBP 5,011,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de MYTRE PROPERTY TRUST LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COLE, Terence Shelby
    Phillimore Gardens
    W8 7QE London
    24
    Administrateur
    Phillimore Gardens
    W8 7QE London
    24
    United KingdomBritish71810060003
    COLLINS, Steven Ross
    Bulstrode Street
    W1U 2JH London
    17
    England
    Administrateur
    Bulstrode Street
    W1U 2JH London
    17
    England
    EnglandBritish7128850005
    STEINBERG, Mark Neil
    Cadogan Square
    SW1X 0HU London
    Flat 2, 25
    England
    Administrateur
    Cadogan Square
    SW1X 0HU London
    Flat 2, 25
    England
    United KingdomBritish59275730001
    DE BARR, Richard Jeremy
    38 Tring Avenue
    W5 3QB London
    Secrétaire
    38 Tring Avenue
    W5 3QB London
    British43885410001
    HOWLAND, Nora
    64 Albion Street
    CT10 1NF Broadstairs
    Kent
    Secrétaire
    64 Albion Street
    CT10 1NF Broadstairs
    Kent
    British7553810001
    MELLISH, Richard Paul
    18 Graham Avenue
    W13 9TQ London
    Secrétaire
    18 Graham Avenue
    W13 9TQ London
    British121886140001
    BRILLING, Michael John
    24 Lexham House
    53 Lexham Gardens
    W8 5JT London
    Administrateur
    24 Lexham House
    53 Lexham Gardens
    W8 5JT London
    EnglandBritish7553820001
    JAYE, Andrew Ian
    Weatheroak
    The Common
    HA7 3HP Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    Weatheroak
    The Common
    HA7 3HP Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritish10174290002
    KLEEMAN, David George
    141 Hamilton Terrace
    NW8 9QS London
    Administrateur
    141 Hamilton Terrace
    NW8 9QS London
    British33770960001
    LEAVER, Brian Ivan
    The Garden House
    72 Paines Lane
    HA5 3BL Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    The Garden House
    72 Paines Lane
    HA5 3BL Pinner
    Middlesex
    EnglandBritish13082210001
    NADLER, Robert Arthur
    123 Old Church Street
    SW3 6EA London
    Administrateur
    123 Old Church Street
    SW3 6EA London
    United KingdomBritish33752790002
    ROSS, Nigel Keith
    60 Cumberland Terrace
    NW1 4HJ London
    Administrateur
    60 Cumberland Terrace
    NW1 4HJ London
    United KingdomBritish47878830001
    RUBENS, Kenneth David
    61 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    Administrateur
    61 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    United KingdomBritish35531750001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MYTRE PROPERTY TRUST LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Innerwyke Investments Limited
    Upper Berkeley Street
    W1H 7PE London
    10
    England
    06 avr. 2016
    Upper Berkeley Street
    W1H 7PE London
    10
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    MYTRE PROPERTY TRUST LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 26 mars 2012
    Livré le 11 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the security trustee and each of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H 13-23 military road chatham t/nos K560673 and K700134. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for Each of the Finance Parties (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 11 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 05 sept. 2003
    Livré le 24 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee for and Onbehalf of the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transactions
    • 24 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge
    Créé le 07 juil. 1995
    Livré le 19 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or seymour development limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility letter dated 6TH july 1995 and/or in connection with the facility thereby granted and/or under the charge
    Brèves mentions
    Freehold land and building known as farringdon point, 29-35(odd numbers) farringdon road, london EC1 title number LN229578 and the proceeds of sale thereof a floating charge over all moveable plant, machienery, implements, building materials of all kinds, utensils, furniture and equipment.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transactions
    • 19 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 08 août 1989
    Livré le 09 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    142/148 (even) high street, new malden. T/n sgl 523804. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 09 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 06 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 08 août 1989
    Livré le 09 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    104, wigmore street, london W1. T/n ngl 23361. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 09 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 25 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 08 août 1989
    Livré le 09 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    190/196, walton street, chelsea, london, SW3 t/n 441548.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 09 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 25 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 08 août 1989
    Livré le 09 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    122/124, malden road, and 120/120B malden road, new malden, kingston upon thames t/n sy 21760.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 09 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 12 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 06 juin 1989
    Livré le 14 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    142/148 (even) high street new malden t/no. Sgl 523804 fixed charge only.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 14 juin 1989Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 06 juin 1989
    Livré le 14 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    190/196 walton street chelsea london SW3 t/no. 441548 fixed charge only.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 14 juin 1989Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 06 juin 1989
    Livré le 14 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    104 wigmore street london SW3 t/no. Ngl 23361 fixed charge only.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 14 juin 1989Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 06 juin 1989
    Livré le 14 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    122/124 maldon road and 120A/120B maldon road new malden kingston upon thames t/no. SY21760 fixed charge only.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 14 juin 1989Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0