PARAMOUNT COMPUTER RENTALS LIMITED

PARAMOUNT COMPUTER RENTALS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPARAMOUNT COMPUTER RENTALS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02268398
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PARAMOUNT COMPUTER RENTALS LIMITED ?

    • Crédit-bail (64910) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe PARAMOUNT COMPUTER RENTALS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Wimbledon Bridge House
    1 Hartfield Road London
    SW19 3RU
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PARAMOUNT COMPUTER RENTALS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SYSCAP COMPUTER RENTALS LIMITED31 juil. 200631 juil. 2006
    SYSCAP COMPUTER RENTALS PLC08 avr. 199908 avr. 1999
    PARAMOUNT COMPUTER RENTALS PLC17 déc. 199217 déc. 1992
    BALTIC RENTALS LIMITED24 janv. 199224 janv. 1992
    GENESIS CONTRACT HIRE (1988) LIMITED20 oct. 198820 oct. 1988
    SHELFCO (NO.230) LIMITED16 juin 198816 juin 1988

    Quels sont les derniers comptes de PARAMOUNT COMPUTER RENTALS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour PARAMOUNT COMPUTER RENTALS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    5 pagesDS01

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    13 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Philip David White le 03 janv. 2012

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 déc. 2011

    État du capital au 14 déc. 2011

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Nomination de Mr Steven Michael Dunne en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Frederick Yue en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Steven Michael Dunne en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Frederick Yue en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Frederick Yue en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Mark Cottrill en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    11 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 16 août 2010

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Divers

    Sect 519 ca 2006
    1 pagesMISC

    Cessation de la nomination de Mark Gidge en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Philip David White le 06 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mark Jonathan Gidge le 06 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de PARAMOUNT COMPUTER RENTALS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DUNNE, Steven Michael
    Wimbledon Bridge House
    1 Hartfield Road London
    SW19 3RU
    Secrétaire
    Wimbledon Bridge House
    1 Hartfield Road London
    SW19 3RU
    162700330001
    DUNNE, Steven Michael
    Wimbledon Bridge House
    1 Hartfield Road London
    SW19 3RU
    Administrateur
    Wimbledon Bridge House
    1 Hartfield Road London
    SW19 3RU
    EnglandBritishChartered Accountant127774430001
    WHITE, Philip David
    Wimbledon Bridge House
    1 Hartfield Road London
    SW19 3RU
    Administrateur
    Wimbledon Bridge House
    1 Hartfield Road London
    SW19 3RU
    United KingdomBritishCompany Director93102140001
    BIGGS, Diana Joy
    2 Prior Street
    Greenwich
    SE10 8SF London
    Secrétaire
    2 Prior Street
    Greenwich
    SE10 8SF London
    UsCs8375660001
    BUTTERFIELD, Mark Clifford
    10 Six Acres
    RH13 0TH Slinfold
    West Sussex
    Secrétaire
    10 Six Acres
    RH13 0TH Slinfold
    West Sussex
    British101896730001
    COTTRILL, Mark Robert
    56 Langdon Road
    BA2 1LT Bath
    Avon
    Secrétaire
    56 Langdon Road
    BA2 1LT Bath
    Avon
    British117829240001
    HUGHES, Maureen Patricia
    Mulberry Cottage Irene Road
    BR6 0HA Orpington
    Kent
    Secrétaire
    Mulberry Cottage Irene Road
    BR6 0HA Orpington
    Kent
    British3069310002
    NAYLOR, Philip
    45 Stubbs Court
    Chaseley Drive
    W4 4BD London
    Secrétaire
    45 Stubbs Court
    Chaseley Drive
    W4 4BD London
    British73736780001
    STEINGOLD, Lawrence Gerald
    Flat 33
    20 Lawn Lane Vauxhall
    SW8 1GA London
    Secrétaire
    Flat 33
    20 Lawn Lane Vauxhall
    SW8 1GA London
    BritishAccountant96504890001
    YUE, Frederick
    Wimbledon Bridge House
    1 Hartfield Road London
    SW19 3RU
    Secrétaire
    Wimbledon Bridge House
    1 Hartfield Road London
    SW19 3RU
    160947960001
    BROOK, Philip Neville
    3 High Coombe Place
    Warren Cutting
    KT2 7HH Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    3 High Coombe Place
    Warren Cutting
    KT2 7HH Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director71011280001
    BUTTERFIELD, Mark Clifford
    10 Six Acres
    RH13 0TH Slinfold
    West Sussex
    Administrateur
    10 Six Acres
    RH13 0TH Slinfold
    West Sussex
    BritishAccountant101896730001
    ELLIS, Christopehr John
    48 Palace Road
    KT8 9DW East Molesey
    Surrey
    Administrateur
    48 Palace Road
    KT8 9DW East Molesey
    Surrey
    BritishFinance Director121825610001
    FIELDEN, David Shaw
    Kingsfield
    Old Midford Road
    BA2 7DH Bath
    Administrateur
    Kingsfield
    Old Midford Road
    BA2 7DH Bath
    EnglandBritishDirector8502310001
    GIDGE, Mark Jonathan
    Dewsbury House
    31 Duttonslane
    CW6 0QW Kelsall
    Cheshire
    Administrateur
    Dewsbury House
    31 Duttonslane
    CW6 0QW Kelsall
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director156974560001
    GODDARD, Michael
    107 Clifton Hill
    NW8 0JS London
    Administrateur
    107 Clifton Hill
    NW8 0JS London
    BritishChartered Accoutant3069320001
    HYMAN, Harry Abraham
    Tara House Cleardown
    The Hockering
    GU22 7HH Woking
    Surrey
    Administrateur
    Tara House Cleardown
    The Hockering
    GU22 7HH Woking
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant35560380001
    MANGHAM, Michael
    Kyrle Road
    SW11 6BB London
    67
    Administrateur
    Kyrle Road
    SW11 6BB London
    67
    EnglandBritishManaging Director66849650002
    MITCHELL, Lord
    3 Elm Row
    NW3 1AA London
    Administrateur
    3 Elm Row
    NW3 1AA London
    BritishDirector5598400001
    MOULTON, Nicholas John
    Flat 3
    Grants Court Victoria Road
    CO14 8BU Walton On The Naze
    Essex
    Administrateur
    Flat 3
    Grants Court Victoria Road
    CO14 8BU Walton On The Naze
    Essex
    BritishManaging Director74912680001
    READ, Sean Peter
    17 Harlands Mews
    Ridgewood
    TN22 5JQ Uckfield
    East Sussex
    Administrateur
    17 Harlands Mews
    Ridgewood
    TN22 5JQ Uckfield
    East Sussex
    United KingdomBritishCompany Director114674290001
    ROUND, Michael Andrew
    Lukes
    The Common
    SN8 1DL Marlborough
    Wiltshire
    Administrateur
    Lukes
    The Common
    SN8 1DL Marlborough
    Wiltshire
    EnglandEnglishCo Director40324810001
    TAYLOR, Graham
    70 Toms Lane
    WD4 8NB Kings Langley
    Hertfordshire
    Administrateur
    70 Toms Lane
    WD4 8NB Kings Langley
    Hertfordshire
    BritishDirector75384820002
    TAYLOR, Joan Eileen
    65 East Road
    E15 3QS London
    Administrateur
    65 East Road
    E15 3QS London
    BritishOperations Director36423460001
    WILLIAMS, Alan Leslie
    2 Bellmoor
    NW3 1DY London
    Administrateur
    2 Bellmoor
    NW3 1DY London
    BritishAccountant23638580001
    WILLIAMS, Sean Russell
    28 Ellerby Street
    SW6 6EY London
    Administrateur
    28 Ellerby Street
    SW6 6EY London
    United KingdomBritishDirector20975080005
    YUE, Frederick
    Wimbledon Bridge House
    1 Hartfield Road London
    SW19 3RU
    Administrateur
    Wimbledon Bridge House
    1 Hartfield Road London
    SW19 3RU
    United KingdomBritishFinance Director140437120001

    PARAMOUNT COMPUTER RENTALS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A target group debenture
    Créé le 03 août 2006
    Livré le 15 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee and Agent for the Finance Parties
    Transactions
    • 15 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement
    Créé le 30 janv. 2006
    Livré le 06 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due of each chargor to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 29 sept. 2004
    Livré le 18 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of assignment
    Créé le 31 mai 1995
    Livré le 06 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £8,394,511.56 due from the company to the chargee payable under 8 promissory notes as defined therein
    Brèves mentions
    The full benefit of the rights of pcr in and the right to reassignment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Michael Charles Hall(Trading as Atrium Finis Leasing) and Any Holder for the Time Being of the Promissory Notes
    Transactions
    • 06 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 06 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    Certificate of assignment pursuant to a master agreement dated 22 february 1995
    Créé le 08 mars 1995
    Livré le 29 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of agreements entered into from time to time and the master agreement
    Brèves mentions
    All monies due to the company under the sub-hire agreements the benefit of all guarantees, indemnities, negotiable instruments etc see form 395 for details.
    Personnes ayant droit
    • Nws Bank PLC
    Transactions
    • 29 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment dated 22ND february 1995
    Créé le 22 févr. 1995
    Livré le 07 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of agreements entered into from time to time and the master assignment
    Brèves mentions
    All monies under the sub-hire agreements specified in the schedule and benefit of all guarantees,indemnities,securities.......etc.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nws Bank PLC
    Transactions
    • 07 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment
    Créé le 22 févr. 1995
    Livré le 09 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of agreements entered into from time to time and the master assignment
    Brèves mentions
    All monies under the sub-hire agreements as specified in schedules to certificates of assignment and benefit of all guarantees,indemnities......securities......etc.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nws Bank PLC
    Transactions
    • 09 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment
    Créé le 21 déc. 1994
    Livré le 07 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master lease purchase agreement dated 21ST december 1994
    Brèves mentions
    All right title & interest in the sub leases all monies arising out of the sub leases all claims for damage the benefit of all guarantees etc. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Central Hispano Leasing Limited
    Transactions
    • 07 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 sept. 1993
    Livré le 01 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 12 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture and floating charge
    Créé le 22 août 1988
    Livré le 24 août 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (For fuell dutails see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Baltic Motolease Limited
    Transactions
    • 24 août 1988Enregistrement d'une charge
    • 11 déc. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0