OLD GIROVEND LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOLD GIROVEND LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02277364
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OLD GIROVEND LIMITED ?

    • (9999) /

    Où se situe OLD GIROVEND LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Challenge House
    International Drive
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Gloucestershire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de OLD GIROVEND LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GIROVEND LIMITED17 déc. 200317 déc. 2003
    G2 INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED 23 mai 200323 mai 2003
    GIROVEND LIMITED04 févr. 200004 févr. 2000
    GIROVEND CASHLESS SYSTEMS (UK) LIMITED21 oct. 199721 oct. 1997
    GIROVEND SYSTEMS LIMITED29 sept. 198829 sept. 1988
    DINGLEMOOR LIMITED14 juil. 198814 juil. 1988

    Quels sont les derniers comptes de OLD GIROVEND LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour OLD GIROVEND LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    legacy

    1 pages652a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    8 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Statuts

    6 pagesMA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed girovend LIMITED\certificate issued on 29/12/08
    2 pagesCERTNM

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    9 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    10 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages225

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 30 sept. 2005

    6 pagesAA

    legacy

    1 pages225

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de OLD GIROVEND LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    THORINGTON-JONES, Gary, Mr.
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    Secrétaire
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    British85541780001
    THORINGTON-JONES, Gary, Mr.
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    Administrateur
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    EnglandBritish85541780001
    WHITELOCK, Noel Keith
    154 Cheltenham Road
    WR11 2LW Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    154 Cheltenham Road
    WR11 2LW Evesham
    Worcestershire
    United KingdomBritish14940620001
    ALLEN, Matthew Charles
    75 Park Road
    W4 3EY London
    Secrétaire
    75 Park Road
    W4 3EY London
    British37599910001
    BAILEY, John
    Stockton Grange The Village
    Stockton On The Forest
    YO3 9UW York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Stockton Grange The Village
    Stockton On The Forest
    YO3 9UW York
    North Yorkshire
    British41823950002
    BANYARD, Alec William James
    17 Hampstead Gardens
    SS5 5HN Hockley
    Essex
    Secrétaire
    17 Hampstead Gardens
    SS5 5HN Hockley
    Essex
    British32189370001
    FIETH, Robin Paul
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    British49907850002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    English107835250001
    KATZ, Peter David
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    Secrétaire
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    British64682050001
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Secrétaire
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    British116252510001
    PECK, Martin David
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    Secrétaire
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    British78149370002
    WELCH, David Michael Geoffrey
    Inigo House
    29 Bedford Street
    WC2E 9ED London
    Secrétaire
    Inigo House
    29 Bedford Street
    WC2E 9ED London
    British43153490002
    WELCH, David Michael Geoffrey
    7 Southampton Place
    WC1A 2DR London
    Secrétaire
    7 Southampton Place
    WC1A 2DR London
    British43153490001
    BARNSLEY, Micheal John
    Church Lane
    Marchington
    ST14 8LJ Uttoxeter
    Buttyard Croft
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Church Lane
    Marchington
    ST14 8LJ Uttoxeter
    Buttyard Croft
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish140579250001
    BUTT, Hanz Helmuth
    Schluchtblick 14
    Johannesberg
    63867
    South Africa
    Administrateur
    Schluchtblick 14
    Johannesberg
    63867
    South Africa
    German68163180001
    CAMPBELL, Sylvia
    18 Forth Place
    NE1 4EU Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    18 Forth Place
    NE1 4EU Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish53211510001
    DITCHBURN, John Blackett Dennison
    The Laurels
    Frieth
    RG9 6PJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Laurels
    Frieth
    RG9 6PJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    British61233990002
    DRUDY, Carmel Ann
    15 Cinnamon Row
    Battersea
    SW11 3TW London
    Administrateur
    15 Cinnamon Row
    Battersea
    SW11 3TW London
    British40928410001
    FIETH, Robin Paul
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    Administrateur
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    EnglandBritish49907850002
    GAHAGNON, Jacques Andre
    92 Place Louvois
    Velizy
    78140
    France
    Administrateur
    92 Place Louvois
    Velizy
    78140
    France
    French68163380001
    GOVETT, Nigel Jeremy Cloudesley
    15 Tantallon Court
    Woodstone Village
    DH4 6TJ Houghton Le Spring
    County Durham
    Administrateur
    15 Tantallon Court
    Woodstone Village
    DH4 6TJ Houghton Le Spring
    County Durham
    British89929500001
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Administrateur
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandEnglish107835250001
    HARRIS, Glyn
    113-116 Bute Street
    CF1 6SB Cardiff
    South Glamorgan
    Administrateur
    113-116 Bute Street
    CF1 6SB Cardiff
    South Glamorgan
    British8555610002
    MCGRANE, Paul Steven
    21 Stony Lane
    NR10 4QS Reepham
    Norwich
    Administrateur
    21 Stony Lane
    NR10 4QS Reepham
    Norwich
    United KingdomBritish51004210002
    MCNAIR, Iain
    23 Mycenae Road
    SE3 7SF London
    Greater London
    Administrateur
    23 Mycenae Road
    SE3 7SF London
    Greater London
    British85499250001
    MILLS, Mark Richard
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    Administrateur
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    British10402540005
    MORINAY, Luc Jean Marie
    14 Rue De Tramelay
    Elancourt
    78990
    France
    Administrateur
    14 Rue De Tramelay
    Elancourt
    78990
    France
    French68163140001
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Administrateur
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    EnglandBritish116252510001
    NWOSU HOPE, Nigel Peter
    Lakewood
    Minsteracres
    DH8 9RR Consett
    County Durham
    Administrateur
    Lakewood
    Minsteracres
    DH8 9RR Consett
    County Durham
    United KingdomBritish64095750001
    PERKINS, Dennis
    18 Spring Grove
    HR8 2XB Ledbury
    Herefordshire
    Administrateur
    18 Spring Grove
    HR8 2XB Ledbury
    Herefordshire
    United KingdomBritish44490630001
    RICHARDS, Keith
    43 Malford Grove
    Gilwern
    NP7 0RN Abergavenny
    Gwent
    Administrateur
    43 Malford Grove
    Gilwern
    NP7 0RN Abergavenny
    Gwent
    British25612680001
    SARGENT, Christian William Lance
    26 Cheriton Drive
    Thornhill
    CF14 9DF Cardiff
    South Glamorgan
    Administrateur
    26 Cheriton Drive
    Thornhill
    CF14 9DF Cardiff
    South Glamorgan
    British68162920001
    SCHOFIELD, Janet Elizabeth
    43 Florence Road
    Wimbledon
    SW19 8TH London
    Administrateur
    43 Florence Road
    Wimbledon
    SW19 8TH London
    British36356290002
    SMART, Richard Ernest
    Oak House,Webbs Lane
    Beenham
    RG7 5LL Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Oak House,Webbs Lane
    Beenham
    RG7 5LL Reading
    Berkshire
    British7970090001
    SMYTH, Peter Francis
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Administrateur
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Irish63863190002

    OLD GIROVEND LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit deed
    Créé le 30 avr. 2003
    Livré le 03 mai 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All monies (including interest accrued thereto) standing to the credit of the account to be opened in a UK clearing bank to be operated solely by the chargee or its solicitors in which the sum of fifteen thousand two hundred and thirty nine pounds has been deposited.
    Personnes ayant droit
    • Helical (Westfields) Limited
    Transactions
    • 03 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 25 févr. 1997
    Livré le 11 mars 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All f/h and l/h land in england and wales including (but not limited to) the property at unit 6 (formerly unit B4) progress business centre,whittle parkway,bath road,slough t/no.bk 266697. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 06 sept. 1996
    Livré le 19 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Single debenture
    Créé le 09 mars 1992
    Livré le 13 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0