ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02284553 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED ?
Adresse du siège social | 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York North Yorkshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 11 pages | LIQ13 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP à 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor York North Yorkshire YO30 4XG le 14 mars 2017 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 12 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Cocker en tant que directeur le 27 juin 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Lorna Edwards en tant qu'administrateur le 27 juin 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nigel Paul Featham en tant que directeur le 27 juin 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 2 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 03 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Anthony Bowler en tant que directeur le 22 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 03 mai 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 20 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 03 mai 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mrs Lorna Edwards en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Elizabeth Davies en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2012 | 19 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Anthony Bowler le 16 août 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 03 mai 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2011 | 19 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Ms Elizabeth Anne Thorpe le 26 mai 2012 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDWARDS, Lorna | Secrétaire | James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York 11 Clifton Moor Business Village North Yorkshire | 183720710001 | |||||||
EDWARDS, Lorna | Administrateur | James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York 11 Clifton Moor Business Village North Yorkshire | England | British | Company Director | 205425080001 | ||||
COCKER, David | Secrétaire | 49 The Mount Wrenthorpe WF2 0NZ Wakefield West Yorkshire | British | Finance Director And Company S | 37574310001 | |||||
DAVIES, Elizabeth Anne | Secrétaire | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | British | 102907000002 | ||||||
LAUCHT, Robert Ian | Secrétaire | 1 High Meadows, Church Lane Kirk Ella HU10 7NJ Hull East Riding Yorkshire | British | 13774020001 | ||||||
TURNER, David Paul | Secrétaire | 139 Eastern Way Darras Hall Ponteland NE20 9RH Newcastle Upon Tyne | British | 48937720001 | ||||||
BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED | Secrétaire | 54 Endless Street SP1 3UH Salisbury Wiltshire | 42985760001 | |||||||
ADCOCK, Paul | Administrateur | 1 Field View Cawston CV22 7FE Rugby Warwickshire | United Kingdom | British | Operations Director | 112858780001 | ||||
BARFOOT, Vernon | Administrateur | 1 Montague Court Santa Cruz Drive BN23 5 Eastbourne East Sussex | British | Engineering Director | 89516570001 | |||||
BARKER, Neil James | Administrateur | 50 Woodfield Road B13 9UJ Kings Heath Birmingham | England | British | Managing Director | 165014000001 | ||||
BAYFIELD, Stephen | Administrateur | Windy Ridge Riverside Close Stoford SP2 0PX Salisbury Wiltshire | British | Company Director | 42058550001 | |||||
BOOKER, Philip Geoffrey | Administrateur | 22 Naseby Road DE56 0ER Belper Derbyshire | British | Commercial Director | 84332090001 | |||||
BOWLER, Richard Anthony | Administrateur | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | Company Director | 35116070003 | ||||
BOWLER, Richard Charles | Administrateur | 25 Rock Farm Lane Sandford On Thames OX4 4YL Oxford | British | Director | 51739150002 | |||||
CLARKE, Kenneth Barry | Administrateur | 2 Sherwood Drive WF2 7QT Wakefield West Yorkshire | British | Managing Director | 76952760002 | |||||
CLAYTON, Stephen John | Administrateur | New Hall Farmhouse Fanhams Hall Road Newhall Green Wareside SG12 7SD Ware Hertfordshire | England | British | Company Director | 46866840005 | ||||
COCKER, David | Administrateur | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | Finance Director | 37574310001 | ||||
CUMMINS, Philip | Administrateur | 7 Marina Avenue Sutton WA9 3TA St Helens Merseyside | United Kingdom | British | Engineering Director | 153482060001 | ||||
DAVIES, Justin Wyn | Administrateur | 7 Hawkenbury Road TN2 5BN Tunbridge Wells Kent | British | Company Director | 66657430002 | |||||
FEATHAM, Nigel Paul | Administrateur | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | Company Director | 161124990001 | ||||
FLYNN, James Sidney | Administrateur | 4 Milnthorpe Drive Sandal WF2 7HU Wakefield West Yorkshire | Irish | Engineering Director | 77440240001 | |||||
HARVEY, Peter | Administrateur | Chapel End 36 Main Street Swithland LE12 8TH Loughborough Leicestershire | United Kingdom | British | Company Director | 30318040003 | ||||
HODGSON, Kenneth | Administrateur | The Grange Church Lane Elvington YO41 4HD York | United Kingdom | British | Company Director | 9946200002 | ||||
HOSKINS, Neil Terence | Administrateur | 45 Brand Hill Drive Crofton WF4 1PF Wakefield West Yorkshire | British | Managing Director | 14322510001 | |||||
HUNTER, Michael John | Administrateur | 100 Manygates Lane Sandal WF2 7DP Wakefield West Yorkshire | British | Company Director | 1058260002 | |||||
JACKSON, Brian Malcolm | Administrateur | Cedar House Manor Court Barton Under Needwood DE13 8AU Burton On Trent Staffordshire | British | Managing Director | 90088220001 | |||||
JONES, Michael Adrian | Administrateur | 3 Old Shaftesbury Drive Old Blandford Road Harnham SP2 8QH Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | Company Director | 77984700001 | ||||
LAUCHT, Robert Ian | Administrateur | 1 High Meadows, Church Lane Kirk Ella HU10 7NJ Hull East Riding Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 13774020001 | ||||
LONSDALE, Stephen Philip | Administrateur | 5 Lintfort Picktree Farm Picktree NE38 9HX Chester Le Street County Durham | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 4971910001 | ||||
MARTIN, David Robert | Administrateur | Bondwood Barn Repton Shrubs Bretby DE15 0RJ Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | Company Director | 6874440001 | ||||
NOBLE, Stephen Leslie | Administrateur | Brewery Close Stamfordham NE18 0PQ Northumberland Close House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 128655430001 | ||||
RAY, John Alfred | Administrateur | 50 The Gables Sedgefield TS21 3EU Stockton On Tees Cleveland | British | Company Director | 58415290001 | |||||
ROBERTS, Ralph Robert | Administrateur | 46 Jackson Drive Crowwod Grange G33 6GF Stepps Lanarkshire | British | Company Director | 127760350001 | |||||
STONE, Philip Martin | Administrateur | 21 Beechfield Road Mayfield PR25 3BG Leyland Lancashire | England | British | Company Director | 69200640003 | ||||
WALLACE, Neale Howard | Administrateur | 17 Greenside Denby Dale HD8 8QY Huddersfield West Yorkshire | British | Commercial Director | 43081660003 |
ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Mortgage | Créé le 19 mai 2008 Livré le 22 mai 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The goods X687YUG 001281 volvo X688YUG 001275 volvo X689YUG 001260 volvo arriva yorkshire west limited for further items charged please see form 395 see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 23 nov. 2006 Livré le 02 déc. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All right title and interest in the goods being chassis: 13336 vdl.reg no:YJ06 wwv.chassis type:DB250. Bodywork: e lancs. Body type: lowlander. Chassis: 13335 vdl. Reg no: YJ06 wwl. Chassis type: DB250. Bodywork: e lancs. Body type: lowlander. Chassis: 13337 vdl. Reg no: YJ06 wwx. Chassis type: DB250. Bodywork: e lancs. Body type: lowlander. (For details of further goods charged please see form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 15 juin 1995 Livré le 20 juin 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the loan agreement,any interest rate agreement or any other grant or security under any of the security documents (as defined therein) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed charge | Créé le 13 avr. 1995 Livré le 20 avr. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti £3,335,000.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Fixed charge over the goods listed in the schedule to the form 395 including several leyland lynx, dennis lance and mercedes benz. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 23 mars 1990 Livré le 29 mars 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed chage over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts (excluding those mentioned above). Uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0