DASHRACE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDASHRACE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02288800
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DASHRACE LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe DASHRACE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    440-450 Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    Northamptonshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de DASHRACE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au26 févr. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour DASHRACE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Mark Derrick Beacham en tant que secrétaire le 03 févr. 2012

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Julia Reynolds en tant que directeur le 03 févr. 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Dominic Joseph Lavelle en tant que directeur le 03 févr. 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mark Derrick Beacham en tant que directeur le 03 févr. 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Marcello Lombardo en tant que directeur le 16 déc. 2011

    1 pagesTM01

    Nomination de Dominic Joseph Lavelle en tant qu'administrateur le 21 nov. 2011

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 26 févr. 2011

    5 pagesAA

    Nomination de Ms Julia Reynolds en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juin 2011

    État du capital au 15 juin 2011

    • Capital: GBP 1,250,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Richard Hitt en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Mark Derrick Beacham en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 27 févr. 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    legacy

    10 pagesMG01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Mark Derrick Beacham le 01 oct. 2009

    3 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Marcello Lombardo le 01 oct. 2009

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard John Hitt le 01 oct. 2009

    3 pagesCH01

    Résolutions

    Resolutions
    39 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175
    RES13
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Comptes établis au 28 févr. 2009

    3 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de DASHRACE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BEACHAM, Mark Derrick
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    Secrétaire
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    British135313320001
    BENNETT, Terry
    Randolph Avenue
    W9 1BG London
    72d
    Secrétaire
    Randolph Avenue
    W9 1BG London
    72d
    British135196530001
    DAWSON, Mary Louise
    57 Elms Road
    SW4 9EP London
    Secrétaire
    57 Elms Road
    SW4 9EP London
    British68983920002
    HOLDSWORTH, Cheryl Irene
    26 Chelveston
    AL7 2PW Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Secrétaire
    26 Chelveston
    AL7 2PW Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British48354260001
    MURRAY, Philip John
    44 Hauxley Drive
    Waldridge Park
    DH2 3TE Chester Le Street
    County Durham
    Secrétaire
    44 Hauxley Drive
    Waldridge Park
    DH2 3TE Chester Le Street
    County Durham
    BritishGroup Finance Mgr79329620001
    O'KEEFFE, Mark John
    5 Fowey Close
    NN8 5WW Wellingborough
    Northamptonshire
    Secrétaire
    5 Fowey Close
    NN8 5WW Wellingborough
    Northamptonshire
    BritishAccountant57880430001
    PILLAY, Paul Vijayasingam
    69 Lilleshall Avenue
    Monkston
    MK10 9HU Milton Keynes
    Secrétaire
    69 Lilleshall Avenue
    Monkston
    MK10 9HU Milton Keynes
    OtherHead Of Finance & Company Secr79416150001
    PLANT, William Allan
    10 The Parks
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    County Durham
    Secrétaire
    10 The Parks
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    County Durham
    BritishFinancial Controller87465680001
    WILKINSON, John Richard
    Abbey Cottage 1 Elm Lane
    Well End
    SL8 5PF Bourne End
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Abbey Cottage 1 Elm Lane
    Well End
    SL8 5PF Bourne End
    Buckinghamshire
    British2545190001
    BEACHAM, Mark Derrick
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    Administrateur
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritishCompany Secretary160095260001
    BENNETT, Paul David
    The Manor House
    Exelby
    DL8 2HB Bedale
    North Yorkshire
    Administrateur
    The Manor House
    Exelby
    DL8 2HB Bedale
    North Yorkshire
    BritishCompany Director49486180001
    BENNINGTON, Glenn Martin
    7 Hartburn Avenue
    Hartburn
    TS18 4ES Stockton On Tees
    Cleveland
    Administrateur
    7 Hartburn Avenue
    Hartburn
    TS18 4ES Stockton On Tees
    Cleveland
    BritishSales Dir39700130001
    BENTLEY, Simon Anthony
    Glen Wood House
    5 Cedars Close
    NW4 1TR London
    Administrateur
    Glen Wood House
    5 Cedars Close
    NW4 1TR London
    United KingdomBritishChartered Accountant3007630001
    CROSLAND, Roy Nicholson
    35 Addison Avenue
    W11 4QS London
    Administrateur
    35 Addison Avenue
    W11 4QS London
    BritishManaging Director30882970002
    FLEMING, Keith
    Brookmead House
    The Warren, East Horsley
    KT24 5RH Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Brookmead House
    The Warren, East Horsley
    KT24 5RH Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritishDirector112723440002
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishFinance Director30306840002
    HARDY, Russell Stephen Mons
    The Reddings
    Langley Road, Claverdon
    CV35 8P Warwick
    Warwickshire
    Administrateur
    The Reddings
    Langley Road, Claverdon
    CV35 8P Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritishChief Executive45844210003
    HARTLEY, Peter Christopher
    17 Jacobean Lane
    Knowle
    B93 9LP Solihull
    Administrateur
    17 Jacobean Lane
    Knowle
    B93 9LP Solihull
    United KingdomBritishFinance Director96458190001
    HITT, Richard John
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    Administrateur
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritishBusiness Analyst & Insight127468180001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    Administrateur
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritishFinance Director137285750001
    LOMBARDO, Marcello
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    Administrateur
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritishFinance Director135699240001
    MALONE, Desmond Philip
    1 Morpeth
    B77 1JF Tamworth
    Staffordshire
    Administrateur
    1 Morpeth
    B77 1JF Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector87170450001
    PLANT, William Allan
    10 The Parks
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    County Durham
    Administrateur
    10 The Parks
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    County Durham
    BritishFinancial Controller87465680001
    REYNOLDS, Julia
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    Administrateur
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritishChief Executive127468460001
    SMITH, David Andrew Gordon
    5 Dann Place The Waterfront
    Wilford Village
    NG11 7FA Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    5 Dann Place The Waterfront
    Wilford Village
    NG11 7FA Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishCompany Director124619670001
    SPURLING, Anthony James
    Park Cottage 49 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2JA St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Park Cottage 49 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2JA St Albans
    Hertfordshire
    BritishCompany Director5224490001
    WILKINSON, John Richard
    Abbey Cottage 1 Elm Lane
    Well End
    SL8 5PF Bourne End
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Abbey Cottage 1 Elm Lane
    Well End
    SL8 5PF Bourne End
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishFinance Director2545190001

    DASHRACE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of accession
    Créé le 18 nov. 2009
    Livré le 23 nov. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    Guarantee & debenture
    Créé le 07 déc. 1999
    Livré le 14 déc. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities ( whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or as principal debtor, guarantor, surety or otherwise or as the equivalent obligor under the laws of any other jurisdiction) of each obligor to the security trustee and the secured parties
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Security Trustee for Itself and for Each of the Secured Parties
    Transactions
    • 14 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 25 juil. 1996
    Livré le 08 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from blacks leisure group PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 3A stephenson road stephenson industrial estate washington tyne & wear t/n's TY271234 and TY271235 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 févr. 1994
    Livré le 08 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the deed
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Meespierson N.V.
    Transactions
    • 08 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 mai 1992
    Livré le 02 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land adjoining unit 3A stephenson industrial estate washington tyne & wear.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 déc. 1991
    Livré le 08 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 3A stephenson industrial estate washington tyne and wear.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 avr. 1991
    Livré le 14 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to a facility letter dated 19/4/91 and this charge
    Brèves mentions
    By way of floating charge the company'S. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Bank Meeb and Hope N.V.
    Transactions
    • 14 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 23 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge on current account
    Créé le 22 nov. 1989
    Livré le 13 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of assignment of the bank all debts represented by sums standing to the credit of the charger on a current account no. 911117548 with midland bank PLC (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • National Bank of Canada
    Transactions
    • 13 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    • 21 mars 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 nov. 1989
    Livré le 13 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1 by way of legal mortgage all freehold andleasehold property vested in the company on 22/11/89 2. by way of first fixed charge:- leasehold & freehold property, shares & rights & the acquisition of shares, stocks & other securities, all uncalled capital goodwill patents trade marks, book debts & other debts (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 déc. 1989Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0