AVOCET HARDWARE (TAIWAN) LTD

AVOCET HARDWARE (TAIWAN) LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAVOCET HARDWARE (TAIWAN) LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02292488
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AVOCET HARDWARE (TAIWAN) LTD ?

    • (5154) /

    Où se situe AVOCET HARDWARE (TAIWAN) LTD ?

    Adresse du siège social
    Duff & Phelps Ltd 43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AVOCET HARDWARE (TAIWAN) LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WONG SHI LIMITED14 mai 199014 mai 1990
    CAPE (HARDWARE) LIMITED11 oct. 198811 oct. 1988
    PRIME ROOFING LIMITED02 sept. 198802 sept. 1988

    Quels sont les derniers comptes de AVOCET HARDWARE (TAIWAN) LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour AVOCET HARDWARE (TAIWAN) LTD ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour AVOCET HARDWARE (TAIWAN) LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Achèvement de la liquidation

    1 pagesL64.07

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    3 pagesCOCOMP

    Avis d'ordonnance du tribunal pour mettre fin à l'administration

    24 pages2.33B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B/2.15B

    10 pages2.16B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    2 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    34 pages2.17B

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Changement d'adresse du siège social de * Brookfoot Mills Elland Road Brighouse West Yorkshire HD6 2RW* le 01 févr. 2012

    2 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    19 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 avr. 2011

    État du capital au 15 avr. 2011

    • Capital: GBP 125,002
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    19 pagesAA

    legacy

    11 pagesMG01

    legacy

    6 pagesMG01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ian Gary Jones le 09 avr. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Nicholas Ridings le 09 avr. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Michael Colin Tuck le 09 avr. 2010

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    19 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    19 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de AVOCET HARDWARE (TAIWAN) LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RIDINGS, Nicholas Andrew
    Firwood Cottage Mottram Road
    SK9 7DW Alderley Edge
    Cheshire
    Secrétaire
    Firwood Cottage Mottram Road
    SK9 7DW Alderley Edge
    Cheshire
    BritishFinance Director48835840002
    JONES, Ian Gary
    Brentwood
    Greave House Fields
    HX2 6PQ Halifax
    West Yorkshire
    Administrateur
    Brentwood
    Greave House Fields
    HX2 6PQ Halifax
    West Yorkshire
    EnglandBritishChief Executive125696390001
    RIDINGS, Nicholas Andrew
    Firwood Cottage Mottram Road
    SK9 7DW Alderley Edge
    Cheshire
    Administrateur
    Firwood Cottage Mottram Road
    SK9 7DW Alderley Edge
    Cheshire
    EnglandBritishFinance Director48835840002
    TUCK, Michael Colin
    10 Park Mews
    DN22 6UT Retford
    Nottinghamshire
    Administrateur
    10 Park Mews
    DN22 6UT Retford
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector125904620001
    BIELINSKI BRADBURY, Graham Eric
    4 Sunny Bank
    Cragg Vale
    HX7 5SL Halifax
    West Yorkshire
    Secrétaire
    4 Sunny Bank
    Cragg Vale
    HX7 5SL Halifax
    West Yorkshire
    British51471960001
    BIGNALL, John
    Mistletoe Farm
    Cuckoo Hill
    HA5 2BB Pinner
    Middlesex
    Secrétaire
    Mistletoe Farm
    Cuckoo Hill
    HA5 2BB Pinner
    Middlesex
    British907580001
    COATS, Peter Herbert
    Bridge Place Farm
    Camerton
    BA2 OPS Bath
    Bath And North East Somerset
    Secrétaire
    Bridge Place Farm
    Camerton
    BA2 OPS Bath
    Bath And North East Somerset
    BritishCompany Director81633470001
    FAULDING, William Allen
    14 Pengarth
    Eldwick
    BD16 3DX Bingley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    14 Pengarth
    Eldwick
    BD16 3DX Bingley
    West Yorkshire
    British24857610001
    HOWARTH, Leigh James
    56 Midford Drive
    Sharples
    BL1 7LY Bolton
    Secrétaire
    56 Midford Drive
    Sharples
    BL1 7LY Bolton
    BritishFinancial Executive50401190001
    JONES, Ian Gary
    Brentwood
    Greave House Fields
    HX2 6PQ Halifax
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Brentwood
    Greave House Fields
    HX2 6PQ Halifax
    West Yorkshire
    BritishDirector125696390001
    PARKER, Alan Thomas
    59 Moorlands
    Wickersley
    S66 0AS Rotherham
    South Yorkshire
    Secrétaire
    59 Moorlands
    Wickersley
    S66 0AS Rotherham
    South Yorkshire
    British2847310001
    THORPE, Andrew
    21 Ringwood Crescent
    S20 2DT Beighton
    Sheffield
    Secrétaire
    21 Ringwood Crescent
    S20 2DT Beighton
    Sheffield
    BritishChartered Accountant39468080001
    ADAT, Sheroz Mohamedali
    111 Hyde Park Road
    King Cross
    HX1 3LJ Halifax
    West Yorkshire
    Administrateur
    111 Hyde Park Road
    King Cross
    HX1 3LJ Halifax
    West Yorkshire
    BritishCompany Director54964420003
    BUDHRANI, Haresh Satram
    457 8th Floor 2 Ta Tung Road
    Taichung
    FOREIGN Taiwan R O C
    Administrateur
    457 8th Floor 2 Ta Tung Road
    Taichung
    FOREIGN Taiwan R O C
    IndianDirector55198330001
    COATS, Peter Herbert
    Bridge Place Farm
    Camerton
    BA2 OPS Bath
    Bath And North East Somerset
    Administrateur
    Bridge Place Farm
    Camerton
    BA2 OPS Bath
    Bath And North East Somerset
    BritishFinance Director81633470001
    FORRESTER, William Wilson
    Coombs Hay
    16 Burre Close
    DE45 1GD Bakewell
    Derbyshire
    Administrateur
    Coombs Hay
    16 Burre Close
    DE45 1GD Bakewell
    Derbyshire
    EnglandBritishCompany Director27743040001
    GOOLD, Edward William
    The Old School Cottage
    1 Main Street
    CV13 0BZ Carlton
    Warwickshire
    Administrateur
    The Old School Cottage
    1 Main Street
    CV13 0BZ Carlton
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Executive176032570001
    HOWARTH, Leigh James
    56 Midford Drive
    Sharples
    BL1 7LY Bolton
    Administrateur
    56 Midford Drive
    Sharples
    BL1 7LY Bolton
    BritishCompany Director50401190001
    JONES, Robert Glyn
    17 Wellington Lodge
    North Street Winkfield
    SL4 4TA Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    17 Wellington Lodge
    North Street Winkfield
    SL4 4TA Windsor
    Berkshire
    BritishDirector116871110002
    KENT, David James
    3 Old Hall
    Clough Lostock
    BL6 4LB Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    3 Old Hall
    Clough Lostock
    BL6 4LB Bolton
    Lancashire
    BritishDirector14720610001
    MCCARTHY, James Bernard
    Houndsfield
    Hunt Paddock Rouncil Lane
    CV8 1NL Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    Houndsfield
    Hunt Paddock Rouncil Lane
    CV8 1NL Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector93785750001
    MOORE, Joseph
    Ashlea
    19 Woodhouse Lane
    HD6 3TH Brighouse
    West Yorkshire
    Administrateur
    Ashlea
    19 Woodhouse Lane
    HD6 3TH Brighouse
    West Yorkshire
    BritishDirector32504330001
    MUNRO, Lorraine
    1 Woodroyd
    Golcar
    HD7 4PG Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    1 Woodroyd
    Golcar
    HD7 4PG Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishCompany Director30384080001
    PARKER, Alan Thomas
    59 Moorlands
    Wickersley
    S66 0AS Rotherham
    South Yorkshire
    Administrateur
    59 Moorlands
    Wickersley
    S66 0AS Rotherham
    South Yorkshire
    BritishManaging Director2847310001
    PRUST, Francis Charles
    Peverill
    25 Wharfe Bank
    LS22 5JP Collingham
    West Yorkshire
    Administrateur
    Peverill
    25 Wharfe Bank
    LS22 5JP Collingham
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant54280001
    SATRAM, Ramesh
    No 2 8th Floor 1 Ta Tun
    15th Street
    Taichung
    Taiwan
    Administrateur
    No 2 8th Floor 1 Ta Tun
    15th Street
    Taichung
    Taiwan
    IndianGeneral Manager33472480001
    THORPE, Andrew
    21 Ringwood Crescent
    S20 2DT Beighton
    Sheffield
    Administrateur
    21 Ringwood Crescent
    S20 2DT Beighton
    Sheffield
    BritishChartered Accountant39468080001

    AVOCET HARDWARE (TAIWAN) LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 29 juin 2010
    Livré le 03 juil. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the parent and the company to any or all of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hotbed Limited
    Transactions
    • 03 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 29 juin 2010
    Livré le 02 juil. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kbc Business Capital (A Division of Kbc Bank Nv)
    Transactions
    • 02 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 19 mars 1997
    Livré le 26 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to any finance document (including this deed) as defined therein
    Brèves mentions
    See form M395 for property details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    AVOCET HARDWARE (TAIWAN) LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 janv. 2012Administration started
    30 mai 2012Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Andrew Gordon Stoneman
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    practitioner
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Benjamin John Wiles
    43-45 Portman Square
    London
    England
    practitioner
    43-45 Portman Square
    London
    England
    2
    DateType
    05 févr. 2016Conclusion of winding up
    17 mai 2012Petition date
    30 mai 2012Commencement of winding up
    12 mai 2016Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or Leeds
    3rd Floor
    1 City Walk
    LS11 9DA Leeds
    practitioner
    3rd Floor
    1 City Walk
    LS11 9DA Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0