ROOFLITE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéROOFLITE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02293123
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ROOFLITE LIMITED ?

    • (2811) /

    Où se situe ROOFLITE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Seymour House
    Loddon
    NR14 6JD Norwich
    Norfolk
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ROOFLITE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LODDON LIMITED15 nov. 199915 nov. 1999
    LODDON LIVESTOCK EQUIPMENT LIMITED20 juil. 198920 juil. 1989
    LANWOOD LIMITED05 sept. 198805 sept. 1988

    Quels sont les derniers comptes de ROOFLITE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ROOFLITE LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ROOFLITE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré C/O Johnson Holmes & Co Towlers Court 3a Elm Hill Norwich Norfolk NR3 1HG

    1 pagesAD03
    X4L0XTRF

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Avis d'achèvement de l'accord volontaire

    12 pages1.4
    A40IORCZ

    Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 19 août 2014

    13 pages1.3
    A3K3MYKG

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 déc. 2012

    6 pagesAA
    X2OA43AH

    Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 19 août 2013

    11 pages1.3
    A2J7Z235

    Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 19 août 2012

    16 pages1.3
    A1LMVW6G

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 déc. 2011

    5 pagesAA
    A1KPJDAX

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 déc. 2010

    6 pagesAA
    A12AX9Z4

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 déc. 2009

    7 pagesAA
    A12AXA2H

    Avis au registre des sociétés de l'accord volontaire prenant effet

    1.1
    AGLBMMXR

    Avis au registre des sociétés de l'accord volontaire prenant effet

    1.1
    AGLBMMXR

    Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 19 août 2011

    10 pages1.3
    AGZ60ZPJ

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 nov. 2011

    État du capital au 24 nov. 2011

    • Capital: GBP 2
    SH01
    XFHKSZIM

    Changement d'adresse du siège social de * Little Money Road Loddon Norwich Norfolk NR14 6JJ* le 24 nov. 2011

    1 pagesAD01
    XFHKRZIL

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Phillip Patrick Jeans le 01 nov. 2011

    2 pagesCH01
    XCIEAZAO

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Phillip Patrick Jeans le 01 nov. 2011

    1 pagesCH03
    XCIBXZA8

    Avis au registre des sociétés de l'accord volontaire prenant effet

    7 pages1.1
    AGLBMMXR

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    XQFJ6M3G

    Période comptable précédente prolongée du 30 juin 2009 au 30 déc. 2009

    1 pagesAA01
    XGE0KHF7

    Certificat de changement de nom

    Company name changed loddon LIMITED\certificate issued on 01/02/10
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    01 févr. 2010

    NOTICE OF CHANGE OF NAME NM01 - RESOLUTION

    CONNOT
    AES6GH2L

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    legacy

    4 pagesMG04
    AOLIPGEK

    Changement d'adresse du siège social de * Beccles Road Loddon Norwich Norfolk NR14 6JJ* le 27 oct. 2009

    1 pagesAD01
    XRMXHEGI

    Qui sont les dirigeants de ROOFLITE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JEANS, Phillip Patrick
    Loddon
    NR14 6JD Norwich
    Seymour House
    Norfolk
    United Kingdom
    Secrétaire
    Loddon
    NR14 6JD Norwich
    Seymour House
    Norfolk
    United Kingdom
    BritishDirector39194380004
    JEANS, Phillip Patrick
    Loddon
    NR14 6JD Norwich
    Seymour House
    Norfolk
    United Kingdom
    Administrateur
    Loddon
    NR14 6JD Norwich
    Seymour House
    Norfolk
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector39194380007
    FENSOM, Thomas Charles
    Weavers Lodge Hallfield Road
    Thompson
    IP24 1PT Thetford
    Norfolk
    Secrétaire
    Weavers Lodge Hallfield Road
    Thompson
    IP24 1PT Thetford
    Norfolk
    British47671060001
    JEANS, Judith Mary
    The Old Barn 6 Market Place
    Loddon
    NR14 6EY Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    The Old Barn 6 Market Place
    Loddon
    NR14 6EY Norwich
    Norfolk
    British11885450001
    JEANS, Patrick Stephen
    Mundham House
    Mundham
    NR14 6EN Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    Mundham House
    Mundham
    NR14 6EN Norwich
    Norfolk
    BritishDirector122408420001
    JEANS, Phillip Patrick
    The Lodge
    High Green
    NR15 1HY Brooke
    Norfolk
    Secrétaire
    The Lodge
    High Green
    NR15 1HY Brooke
    Norfolk
    BritishDirector39194380001
    JEANS, Rebecca Louise
    The Old Barn 6 Market Place
    Loddon
    NR14 6EY Norwich
    Secrétaire
    The Old Barn 6 Market Place
    Loddon
    NR14 6EY Norwich
    British42167850001
    JEANS, Robert Stanley
    Wendover
    10 The Warren
    NR27 0AR Cromer
    Norfolk
    Secrétaire
    Wendover
    10 The Warren
    NR27 0AR Cromer
    Norfolk
    British38198550005
    JEANS, Robert Stanley
    4 Furze Hill
    NR27 0HU Cromer
    Norfolk
    Secrétaire
    4 Furze Hill
    NR27 0HU Cromer
    Norfolk
    BritishDirector38198550003
    JEANS, Robert Stanley
    4 Furze Hill
    NR27 0HU Cromer
    Norfolk
    Secrétaire
    4 Furze Hill
    NR27 0HU Cromer
    Norfolk
    BritishDirector38198550003
    JEANS, Sandra Verna
    Mundham House
    Mundham
    NR14 6EN Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    Mundham House
    Mundham
    NR14 6EN Norwich
    Norfolk
    British39194540003
    JEANS, Sandra Verna
    The Lodge
    High Green
    NR15 1HY Brooke
    Norfolk
    Secrétaire
    The Lodge
    High Green
    NR15 1HY Brooke
    Norfolk
    British39194540001
    JEANS, Stephanie Marie
    Coburg Street
    NR1 3BF Norwich
    Flat 21 Chapelfield Gardens
    Norfolk
    Secrétaire
    Coburg Street
    NR1 3BF Norwich
    Flat 21 Chapelfield Gardens
    Norfolk
    BritishPurchase Officer131603860001
    MALPASS, Richard Ian Thomas
    15 Silvertrees Drive
    SL6 4QJ Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    15 Silvertrees Drive
    SL6 4QJ Maidenhead
    Berkshire
    BritishDirector13749850001
    NEALE, Benita Louise
    Grove Cottage
    Polls Lane Ringsfield
    NR34 8LP Beccles
    Suffolk
    Secrétaire
    Grove Cottage
    Polls Lane Ringsfield
    NR34 8LP Beccles
    Suffolk
    BritishSecretary100740020001
    ALEXANDER, Peter John
    Wensum Valley View
    8a Station Road
    NR9 5AA Atilebridge
    Norwich Norfolk
    Administrateur
    Wensum Valley View
    8a Station Road
    NR9 5AA Atilebridge
    Norwich Norfolk
    BritishDirector Of Manufacture75999550001
    BRADFORD, Richard Neville
    1 Trinity Gardens
    Staithe Road
    NR35 1HH Bungay
    Suffolk
    Administrateur
    1 Trinity Gardens
    Staithe Road
    NR35 1HH Bungay
    Suffolk
    BritishManagement Consultant38373800001
    HORNE, Ian Joseph
    73 Peacock Street
    NR3 1TB Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    73 Peacock Street
    NR3 1TB Norwich
    Norfolk
    BritishEngineer76568370001
    JEANS, David Dennis
    The Old Barn 6 Market Place
    Loddon
    NR14 6EY Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    The Old Barn 6 Market Place
    Loddon
    NR14 6EY Norwich
    Norfolk
    BritishManaging Director12323060001
    JEANS, Patrick Stephen
    Mundham House
    Mundham
    NR14 6EN Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Mundham House
    Mundham
    NR14 6EN Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishDirector122408420001
    JEANS, Patrick Stephen
    Mundham House
    Mundham
    NR14 6EN Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Mundham House
    Mundham
    NR14 6EN Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishDirector122408420001
    JEANS, Robert Stanley
    Wendover
    10 The Warren
    NR27 0AR Cromer
    Norfolk
    Administrateur
    Wendover
    10 The Warren
    NR27 0AR Cromer
    Norfolk
    EnglandBritishDirector38198550005
    JEANS, Robert Stanley
    Wendover
    10 The Warren
    NR27 0AR Cromer
    Norfolk
    Administrateur
    Wendover
    10 The Warren
    NR27 0AR Cromer
    Norfolk
    EnglandBritishDirector38198550005
    JEANS, Robert Stanley
    4 Furze Hill
    NR27 0HU Cromer
    Norfolk
    Administrateur
    4 Furze Hill
    NR27 0HU Cromer
    Norfolk
    BritishDirector38198550003
    JERMY, Richard S
    12 Links Way
    Thurlton
    NR14 6RF Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    12 Links Way
    Thurlton
    NR14 6RF Norwich
    Norfolk
    BritishSales Director12323070001
    MALPASS, Richard Ian Thomas
    15 Silvertrees Drive
    SL6 4QJ Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    15 Silvertrees Drive
    SL6 4QJ Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector13749850001
    TRUESDELL, Alan Peter
    36 Firs Road
    Hethersett
    NR9 3EH Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    36 Firs Road
    Hethersett
    NR9 3EH Norwich
    Norfolk
    BritishManager94916510001

    ROOFLITE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over cash sum
    Créé le 30 avr. 2008
    Livré le 06 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge the deposit and all the entitlements to interest the right to repayment and other rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Technical & General Guarantee S.A.
    Transactions
    • 06 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 30 avr. 2008
    Livré le 06 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the company's present and future undertaking and assets whatever and wherever.
    Personnes ayant droit
    • Technical & General Guarantee Company S.A.
    Transactions
    • 06 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 juin 1998
    Livré le 18 juin 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 janv. 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    Legal charge
    Créé le 18 juin 1996
    Livré le 25 juin 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land comprising parts of the national grid enclosure numbers 6500, 7200 and 8100 at little money road loddon norfolk.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)

    ROOFLITE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 août 2010Date of meeting to approve CVA
    27 janv. 2015Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Frank Simms
    F A Simms & Partners
    Insol House
    LE17 4AP 39 Station Road
    Lutterworth Leicestershire
    practitioner
    F A Simms & Partners
    Insol House
    LE17 4AP 39 Station Road
    Lutterworth Leicestershire
    Carolynn Jean Best
    Insol House 39 Station Road
    LE17 4AP Lutterworth
    Leicestershire
    practitioner
    Insol House 39 Station Road
    LE17 4AP Lutterworth
    Leicestershire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0