G B AIRWAYS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéG B AIRWAYS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02294109
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de G B AIRWAYS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe G B AIRWAYS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o ERNST AND YOUNG LLP
    No 1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de G B AIRWAYS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FORGEUPPER LIMITED08 sept. 198808 sept. 1988

    Quels sont les derniers comptes de G B AIRWAYS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour G B AIRWAYS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour G B AIRWAYS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de * Hanger 89 London Luton Airport Luton Bedfordshire LU2 9PF* le 01 juil. 2013

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 23 mai 2013

    • Capital: GBP 1.00
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    3 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 21 en totalité

    3 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 20 en totalité

    3 pagesMR04

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Qui sont les dirigeants de G B AIRWAYS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PEMBERTON, Giles
    c/o Ernst And Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    Secrétaire
    c/o Ernst And Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    British112636270002
    CAMPBELL, Michael
    c/o Ernst And Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    Administrateur
    c/o Ernst And Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    EnglandBritish77951860002
    KENNEDY, Christopher John
    c/o Ernst And Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    Administrateur
    c/o Ernst And Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    United KingdomBritish62227310005
    MCCALL, Carolyn Julia
    c/o Ernst And Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    Administrateur
    c/o Ernst And Young Llp
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    EnglandBritish39252480013
    ATTWOOD, Christopher Raymond
    Southwinds 1 The Drive
    Warwick Park
    TN2 5ER Tunbridge Wells
    Kent
    Secrétaire
    Southwinds 1 The Drive
    Warwick Park
    TN2 5ER Tunbridge Wells
    Kent
    British106529990001
    HAWKINS, John Charles
    5 Broom Grove
    RG11 4TX Wokingham
    Berkshire
    Secrétaire
    5 Broom Grove
    RG11 4TX Wokingham
    Berkshire
    British15916200002
    MAY, Iain Richard Campbell
    Oak Tree House 17 Curlew Close
    Tytherington
    SK10 2SX Macclesfield
    Cheshire
    Secrétaire
    Oak Tree House 17 Curlew Close
    Tytherington
    SK10 2SX Macclesfield
    Cheshire
    British32619030002
    ALEXANDER CBE, William John
    Roughwood Croft
    Fair Mile
    RG9 2OX Henley On Thames
    Oxon
    Administrateur
    Roughwood Croft
    Fair Mile
    RG9 2OX Henley On Thames
    Oxon
    British124928410001
    ALIKER, Paul Charles
    3 Greenford Close
    Orwell
    S98 5QA Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    3 Greenford Close
    Orwell
    S98 5QA Cambridge
    Cambridgeshire
    British39046710001
    ATTWOOD, Christopher Raymond
    Southwinds 1 The Drive
    Warwick Park
    TN2 5ER Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    Southwinds 1 The Drive
    Warwick Park
    TN2 5ER Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish106529990001
    CARR, Jeffrey
    5 Bellridge Place
    Knotty Green
    HP9 2DN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    5 Bellridge Place
    Knotty Green
    HP9 2DN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish103780760001
    GAGGERO, James Peter George
    3 Europa Road
    Gibraltar
    Administrateur
    3 Europa Road
    Gibraltar
    GibraltarBritish133601430001
    GAGGERO, Joseph James
    Flat 27
    Chalfont House
    SW1X 8NG 49 Gadogan Lane
    London
    Administrateur
    Flat 27
    Chalfont House
    SW1X 8NG 49 Gadogan Lane
    London
    United KingdomBritish11079290001
    GILMOUR, William Macmillan Davidson
    85 Leicester Road
    Shepshed
    LE12 9DF Loughborough
    Leicestershire
    Administrateur
    85 Leicester Road
    Shepshed
    LE12 9DF Loughborough
    Leicestershire
    EnglandBritish65542220001
    GOODING, Valerie Frances
    No 19 Bloomsbury Mansions
    13-16 Bedford Way
    WC1B 5ER London
    Administrateur
    No 19 Bloomsbury Mansions
    13-16 Bedford Way
    WC1B 5ER London
    United KingdomBritish36478520005
    GOODING, Valerie Frances
    22 Spencer Road
    KT8 0SP East Molesey
    Surrey
    Administrateur
    22 Spencer Road
    KT8 0SP East Molesey
    Surrey
    EnglandBritish36478520001
    GURASSA, Charles Mark
    60 Camden Square
    NW1 9XE London
    Administrateur
    60 Camden Square
    NW1 9XE London
    British46748300002
    HAMMAD, Saad Hassan
    3 Priory Gardens
    W4 1TT London
    Administrateur
    3 Priory Gardens
    W4 1TT London
    UkBritish38921050004
    HARRISON, Andrew
    Wimbushes
    Ragged Hall Lane
    AL2 3NW St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Wimbushes
    Ragged Hall Lane
    AL2 3NW St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish9006050004
    HATTON, Anthony Kevin
    Stoke Park Farm Cottage London Road
    GU1 1XJ Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Stoke Park Farm Cottage London Road
    GU1 1XJ Guildford
    Surrey
    EnglandBritish29381720001
    HAWKINS, John Charles
    5 Broom Grove
    RG11 4TX Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    5 Broom Grove
    RG11 4TX Wokingham
    Berkshire
    British15916200002
    HYDE, David
    Bimini Christchurch Road
    GU25 4PX Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    Bimini Christchurch Road
    GU25 4PX Virginia Water
    Surrey
    British5068070001
    KENWORTHY, Peter
    5 Bakehouse Barn Close
    RH12 5JE Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    5 Bakehouse Barn Close
    RH12 5JE Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish47694840001
    MAY, Iain Richard Campbell
    Oak Tree House 17 Curlew Close
    Tytherington
    SK10 2SX Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    Oak Tree House 17 Curlew Close
    Tytherington
    SK10 2SX Macclesfield
    Cheshire
    GbrBritish32619030002
    MITCHELL, George Alexander
    19 Rivermount Gardens
    GU2 4DN Guildford
    Surrey
    Administrateur
    19 Rivermount Gardens
    GU2 4DN Guildford
    Surrey
    British95548010001
    MORGAN, John Sherwood
    Brackley Cottage
    Bull Lane
    SL9 8RY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Brackley Cottage
    Bull Lane
    SL9 8RY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish99812910001
    OSBORNE, John Graham
    73 Honeycrock Lane
    Salfords
    RH1 5DG Redhill
    Surrey
    Administrateur
    73 Honeycrock Lane
    Salfords
    RH1 5DG Redhill
    Surrey
    British56259410001
    PATTERSON, John Howard
    The Oaks Horsham Road
    Mid Holmwood
    RH5 4ER Dorking
    Surrey
    Administrateur
    The Oaks Horsham Road
    Mid Holmwood
    RH5 4ER Dorking
    Surrey
    British27951160001
    PECK, Graham Douglas Grindell, Captain
    Flower Garden Cottage Birch Grove
    Horsted Keynes
    RH17 7DQ Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    Flower Garden Cottage Birch Grove
    Horsted Keynes
    RH17 7DQ Haywards Heath
    West Sussex
    British59440780001
    SAYER, Raymond
    14 Llanvair Close
    South Ascot
    SL5 9HX Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    14 Llanvair Close
    South Ascot
    SL5 9HX Ascot
    Berkshire
    British15916230001
    SERRANO, Guillermo, Senor
    4 Gavilanes
    28035
    FOREIGN Madrid
    Spain
    Administrateur
    4 Gavilanes
    28035
    FOREIGN Madrid
    Spain
    Spanish20295130001
    STREET, Michael Anthony
    The Waterfront
    300 Thames Valley Park Drive
    RG6 1PT Reading
    Berkshire
    Administrateur
    The Waterfront
    300 Thames Valley Park Drive
    RG6 1PT Reading
    Berkshire
    EnglandBritish46956720001
    WARD, William John James, Captain
    37 Blackheath Park
    SE3 9RW London
    Administrateur
    37 Blackheath Park
    SE3 9RW London
    Irish104699510001

    G B AIRWAYS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage
    Créé le 25 mai 2007
    Livré le 31 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the lenders,security trustee and/or the facility agent on any account whatsover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right,title and interest (present and future) in and to the aircraft. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsh Nordbank Ag,London Branch
    Transactions
    • 31 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of insurances
    Créé le 25 mai 2007
    Livré le 31 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the assignor to the lenders,security trustee and/or the facility agent on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the assignor's right,title and interest (present and future) in,to and under the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsh Nordbank Ag,London Branch
    Transactions
    • 31 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of deposit
    Créé le 22 nov. 2006
    Livré le 23 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All deposits now and in the future credited to account designation 22368918 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge of deposit
    Créé le 03 nov. 2006
    Livré le 04 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The deposit initially of us $700,000 credited to account designation rbsgbairusda with the bank and any addition to that deposit and any deposit from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from or out of such initial deposit or account.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge of deposit
    Créé le 23 août 2006
    Livré le 12 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The deposit credited to account number 22368918 and all other monies standing to the credit of that account and any other deposit or account from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment of insurances
    Créé le 23 mai 2006
    Livré le 13 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the lenders, the chargee and/or the facility agent on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the assignors right title and interest in to and under the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch
    Transactions
    • 13 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 23 mai 2006
    Livré le 13 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the lenders, the chargee and/or the facility agent on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights title and interest in and to the aircraft being airbus A321-200 s/n 2682 registration mark g-ttie. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch
    Transactions
    • 13 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Purchase agreement assignment
    Créé le 10 avr. 2006
    Livré le 28 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the lenders, the chargee and/or the facility agent on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights title and interest in under and to the ba purchase agreement in so far as it relates to the aircraft being airbus A321-200 aircraft to be registered as g-ttif. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch
    Transactions
    • 28 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Purchase agreement assignment
    Créé le 10 avr. 2006
    Livré le 28 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the lenders, the chargee and/or the facility agent on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights title and interest in under and to the ba purchase agreement in so far as it relates to the aircraft being airbus A321-200 aircraft with s/no 2682 to be registered as g-ttie. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch
    Transactions
    • 28 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    An assignment of insurances
    Créé le 16 nov. 2005
    Livré le 23 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the company's rights, title and interest, present and future, to the benefit of, and in respect of the proceeds arising, under: all insurances and any requisistion compensation. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Aerospace Limited
    Transactions
    • 23 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    An aircraft lease agreement relating to one airbus A320-232 serial number 2137
    Créé le 14 nov. 2005
    Livré le 23 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any amount paid to the lessor from time to time in accordance with clause 8 of the lease as a security deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Aerospace Limited
    Transactions
    • 23 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment of insurances
    Créé le 12 mai 2005
    Livré le 24 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the lenders, the chargee and/or the facility agent under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Assigned property being all of the rights, title and interest, present and future of the company to all the benefits of, and all the claims under, all policies and contracts of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norddeutsche Landesbank Girozentrale (The Security Trustee)
    Transactions
    • 24 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Aircraft mortgage
    Créé le 12 mai 2005
    Livré le 24 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the lenders, the security trustee and/or the facility agent under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The aircraft. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norddeutsche Landesbank Girozentrale
    Transactions
    • 24 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of insurances
    Créé le 30 mars 2004
    Livré le 07 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The right title and interest present and future to the benefit of and in respect of proceeds arising under all insurances and any requisition compensation relating to the aircraft. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lombard Aviation Capital Limited
    Transactions
    • 07 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Aircraft lease agreement
    Créé le 19 déc. 2003
    Livré le 06 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A security deposit of two months' rent and all interest accrued thereon.
    Personnes ayant droit
    • Lombard Aviation Capital Limited
    Transactions
    • 06 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage deed
    Créé le 11 déc. 2003
    Livré le 22 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other part to the operative documents to any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right, tite and interest (present and future) in and to the aircraft being one (1) airbus A320-232 aircraft bearing manufacturer's s/no 2137 excluding the engines or engines from time to time installed on the aircraft. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norddeutsche Landesbank Girozentrale, as Security Trustee
    Transactions
    • 22 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of insurances
    Créé le 11 déc. 2003
    Livré le 22 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due form the company or any other party to the operative documents to any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Right title and interest of the company in and to the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norddeutsche Landesbank Girozentrale as Security Trustee
    Transactions
    • 22 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of insurances
    Créé le 02 mai 2003
    Livré le 06 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to the proceeds arising out of all insurances and all requisition compensation.
    Personnes ayant droit
    • Acg Acquisition 38 Llc
    Transactions
    • 06 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juin 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 29 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment of insurances
    Créé le 10 avr. 2003
    Livré le 14 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest to and in all insurances in respect of all risks of physical loss or damage effected in relation to the aircraft and all benefits thereof. Any requisition compensation relating to the aircraft. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Acg Acquisition 37 Llc
    Transactions
    • 14 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juin 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 29 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment of insurances
    Créé le 13 févr. 2003
    Livré le 18 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All insurances; any requisition compensation. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Acg Acquisition 31 Llc
    Transactions
    • 18 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juin 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 29 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Lease relating to one airbus A320-232 aircraft bearing serial number 1918
    Créé le 23 janv. 2003
    Livré le 07 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A security deposit in the sum of one month's rent payable by the lessee to the lessor pursuant to clause 7.1 of the lease and all rights of the lessee to payment thereof the debt represented thereby and all interest thereon and/or any and all interest of the lessee therein. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Acg Acquisition 31 Llc
    Transactions
    • 07 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juin 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 29 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Lease relating to one airbus A320-232 aircraft bearing serial number 1969
    Créé le 23 janv. 2003
    Livré le 07 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A security deposit in the sum of one month's rent payable by the lessee to the lessor pursuant to clause 7.1 of the lease and all rights of the lessee to payment thereof the debt represented thereby and all interest thereon and/or any and all interest of the lessee therein. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Acg Aquisition 37 Llc
    Transactions
    • 07 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juin 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 29 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Lease relating to one airbus A320-232 aircraft bearing serial number 1993
    Créé le 23 janv. 2003
    Livré le 07 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A security deposit in the sum of one month's rent payable by the lessee to the lessor pursuant to clause 7.1 of the lease and all rights of the lessee to payment thereof the debt represented thereby and all interest thereon and/or any and all interest of the lessee therein. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Acg Acquisition 38 Llc
    Transactions
    • 07 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juin 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 29 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment of insurances
    Créé le 12 déc. 2002
    Livré le 20 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other party to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the rights title and interest of the assignor in and to the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 12 déc. 2002
    Livré le 20 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other party to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its rights title and interest (present and future) in and to the aircraft. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    G B AIRWAYS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 juin 2013Commencement of winding up
    11 sept. 2014Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Guy Boughey
    No 1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    practitioner
    No 1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Tomislav Lukic
    Ernst & Young
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    practitioner
    Ernst & Young
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0