WHYTE AGROCHEMICALS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWHYTE AGROCHEMICALS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02295801
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WHYTE AGROCHEMICALS LIMITED ?

    • fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques (20200) / Industries manufacturières

    Où se situe WHYTE AGROCHEMICALS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Quantuma Llp High Holborn House
    52-54 High Holborn
    WC1V 6RL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WHYTE AGROCHEMICALS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MIRFIELD SALES SERVICES LIMITED 23 sept. 199723 sept. 1997
    MIRFIELD SALES SERVICES LIMITED 11 janv. 198911 janv. 1989
    GLOBALFIT LIMITED13 sept. 198813 sept. 1988

    Quels sont les derniers comptes de WHYTE AGROCHEMICALS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour WHYTE AGROCHEMICALS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    23 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 23 sept. 2021

    23 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 23 sept. 2020

    32 pagesLIQ03

    Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 022958010007

    6 pagesMR05

    Changement d'adresse du siège social de Marlborough House 298 Regents Park Road London N3 2UA à C/O Quantuma Llp High Holborn House 52-54 High Holborn London WC1V 6RL le 10 oct. 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 24 sept. 2019

    LRESEX

    Déclaration des affaires

    8 pagesLIQ02

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Melvyn Mark Whyte en tant que directeur le 26 avr. 2019

    1 pagesTM01

    Inscription de la charge 022958010007, créée le 17 mai 2018

    59 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 022958010006 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    2 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 04 janv. 2018 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge 022958010006, créée le 19 janv. 2018

    9 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    2 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 30 juin 2016

    15 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2015

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 janv. 2016

    État du capital au 22 janv. 2016

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 janv. 2015

    État du capital au 06 janv. 2015

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2014

    7 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Bhagwant Singh Rattan le 01 oct. 2014

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de WHYTE AGROCHEMICALS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RATTAN, Bhagwant Singh
    High Holborn House
    52-54 High Holborn
    WC1V 6RL London
    C/O Quantuma Llp
    Secrétaire
    High Holborn House
    52-54 High Holborn
    WC1V 6RL London
    C/O Quantuma Llp
    British55223090002
    RATTAN, Bhagwant Singh
    High Holborn House
    52-54 High Holborn
    WC1V 6RL London
    C/O Quantuma Llp
    Administrateur
    High Holborn House
    52-54 High Holborn
    WC1V 6RL London
    C/O Quantuma Llp
    United KingdomBritishAccountant55223090005
    HARRIS, Colin Michael
    58 Murray Crescent
    HA5 3QE Pinner
    Middlesex
    Secrétaire
    58 Murray Crescent
    HA5 3QE Pinner
    Middlesex
    British1829510001
    WHYTE, Lily
    15 Dollis Avenue
    N3 1UD London
    Secrétaire
    15 Dollis Avenue
    N3 1UD London
    British2378240001
    HANOVER SECRETARIES LIMITED
    Apollo House
    56 New Bond Street
    W1S 1RG London
    Secrétaire
    Apollo House
    56 New Bond Street
    W1S 1RG London
    8463460002
    BLOOMFIELD, Jeremy Roger Gray
    1 The Parsonage Dean Lane
    Sixpenny Handley
    SP5 5QJ Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    1 The Parsonage Dean Lane
    Sixpenny Handley
    SP5 5QJ Salisbury
    Wiltshire
    BritishDirector69141350001
    ELLIS, Peter Douglas
    Coverdale House 11 New Force Court
    Towthorpe Road Haxby
    YO3 3YA York
    Yorkshire
    Administrateur
    Coverdale House 11 New Force Court
    Towthorpe Road Haxby
    YO3 3YA York
    Yorkshire
    BritishSales Director57974970001
    HARRIS, Colin Michael
    58 Murray Crescent
    HA5 3QE Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    58 Murray Crescent
    HA5 3QE Pinner
    Middlesex
    BritishAccountant1829510001
    WHYTE, Lily
    15 Dollis Avenue
    N3 1UD London
    Administrateur
    15 Dollis Avenue
    N3 1UD London
    EnglandBritishDirector2378240001
    WHYTE, Melvyn Mark
    298 Regents Park Road
    N3 2UA London
    Marlborough House
    England
    Administrateur
    298 Regents Park Road
    N3 2UA London
    Marlborough House
    England
    United KingdomBritishChemist1718220001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WHYTE AGROCHEMICALS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    298 Regents Park Road
    N3 2UA London
    Marlborough House
    England
    06 avr. 2016
    298 Regents Park Road
    N3 2UA London
    Marlborough House
    England
    Non
    Forme juridiqueCompany
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement01286190
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    WHYTE AGROCHEMICALS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 17 mai 2018
    Livré le 24 mai 2018
    En cours
    Brève description
    N/A.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Gqs Finance Limited
    Transactions
    • 24 mai 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 18 déc. 2019Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge (MR05)
    A registered charge
    Créé le 19 janv. 2018
    Livré le 22 janv. 2018
    Totalement satisfaite
    Brève description
    1. by way of fixed charge (“the fixed charge”). I) all freehold and leasehold land and buildings of the company both present and future including the land and buildings specified in section 2 of the schedule and all trade fixtures and fittings and all fixed plant and machinery from time to time in or on any such land and buildings;. (Ii) all patents, patent applications, trade marks, trade names, registered designs, copyrights, knowhow, and other intellectual property rights and all licences and ancillary rights and benefits (including royalties fees and other income deriving from the same ) now owned or at any time hereafter to be owned by the company.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nucleus Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 22 janv. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 18 mai 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 16 juin 2006
    Livré le 30 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank Sa/Nv. UK Branch
    Transactions
    • 30 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 avr. 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 01 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 16 juin 2006
    Livré le 28 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 28 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 mars 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 15 août 2005
    Livré le 16 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD
    Transactions
    • 16 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating charge
    Créé le 22 févr. 1996
    Livré le 02 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 02 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 02 mars 1989
    Livré le 14 mars 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 mars 1989Enregistrement d'une charge
    • 22 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    WHYTE AGROCHEMICALS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    24 sept. 2019Commencement of winding up
    22 déc. 2022Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Michael Kiely
    High Holborn House
    52-54 High Holborn
    WC1V 6RL London
    practitioner
    High Holborn House
    52-54 High Holborn
    WC1V 6RL London
    Andrew Lawrence Hosking
    High Holborn House
    52-54 High Holborn
    WC1V 6RL London
    practitioner
    High Holborn House
    52-54 High Holborn
    WC1V 6RL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0