THE UK CHANNEL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE UK CHANNEL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02301363
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE UK CHANNEL LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe THE UK CHANNEL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The London Television Centre
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE UK CHANNEL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THE HOME SERVICE CHANNEL LIMITED20 juil. 198920 juil. 1989
    MANI LIMITED30 sept. 198830 sept. 1988

    Quels sont les derniers comptes de THE UK CHANNEL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour THE UK CHANNEL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 nov. 2009

    État du capital au 24 nov. 2009

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Eleanor Kate Irving le 16 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Helen Jane Tautz le 16 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de 200 Grays Inn Road London WC1X 8HF le 12 oct. 2009

    1 pagesAD01

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    2 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    4 pages363a

    Statuts

    8 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolutions

    Section 175(5)a 22/09/2008
    RES13

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    2 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    2 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de THE UK CHANNEL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    IRVING, Eleanor Kate
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    Administrateur
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish79177030002
    TAUTZ, Helen Jane
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    Administrateur
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish37564540001
    ABDOO, David
    78 Airedale Avenue
    Chiswick
    W4 2NN London
    Secrétaire
    78 Airedale Avenue
    Chiswick
    W4 2NN London
    British40437090001
    HOWLE, Michael Anthony
    46 Dowlans Road
    KT23 4LE Great Bookham
    Surrey
    Secrétaire
    46 Dowlans Road
    KT23 4LE Great Bookham
    Surrey
    British32460850001
    LUCAS, Anthony Ronald
    Flat 12 Beatrix House
    208 Old Beatrix Road
    SW5 0BP London
    Secrétaire
    Flat 12 Beatrix House
    208 Old Beatrix Road
    SW5 0BP London
    British30771870001
    TAUTZ, Helen Jane
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    Secrétaire
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    British37564540001
    ANCLIFF, Christopher John
    121 Chestnut Grove
    SW12 8JH London
    Administrateur
    121 Chestnut Grove
    SW12 8JH London
    British52876050001
    BIRDSEYE, Sarah Elizabeth
    4 Bowood Road
    SW11 6PE London
    Administrateur
    4 Bowood Road
    SW11 6PE London
    British69659880002
    BUGGY, Alan Richard
    927 Westover Road
    Stamford Connecticut
    FOREIGN
    Usa
    Administrateur
    927 Westover Road
    Stamford Connecticut
    FOREIGN
    Usa
    American4860890001
    CONSTANT, Richard Michael
    6 Balniel Gate
    SW1V 3SD London
    Administrateur
    6 Balniel Gate
    SW1V 3SD London
    United KingdomBritish43836310003
    CRESSWELL, John
    Rosslyn House 8 Park Road
    SO22 6AA Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    Rosslyn House 8 Park Road
    SO22 6AA Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish39795820003
    DILNOTT-COOPER, Rupert Michael Walter James
    23 Glenmore Road
    NW3 4BY London
    Administrateur
    23 Glenmore Road
    NW3 4BY London
    EnglandBritish52448400001
    FORREST, Ian Mcclure
    Brewhurst House
    Brewhurst
    RH14 0RJ Loxwood
    West Sussex
    Administrateur
    Brewhurst House
    Brewhurst
    RH14 0RJ Loxwood
    West Sussex
    British2327400003
    GOROG, William Christopher
    9044 Melrose Avenue
    FOREIGN Los Angeles
    90069
    Usa
    Administrateur
    9044 Melrose Avenue
    FOREIGN Los Angeles
    90069
    Usa
    American96074620002
    HAIMOVITZ, Jules
    10551 Wilshire Boulevard
    90024 Los Angeles
    California
    U.S.A.
    Administrateur
    10551 Wilshire Boulevard
    90024 Los Angeles
    California
    U.S.A.
    American43075680001
    HUTCHINGS, David George
    Crepping Hall
    CO6 2AL Wakes Colne
    Essex
    Administrateur
    Crepping Hall
    CO6 2AL Wakes Colne
    Essex
    British10085500002
    JACQUES, John Douglas
    White Gates 81 East Lane
    West Horsley
    KT24 6LR Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    White Gates 81 East Lane
    West Horsley
    KT24 6LR Leatherhead
    Surrey
    British3170310001
    JOHNSON, David
    50 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1BA Brentwood
    Essex
    Administrateur
    50 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1BA Brentwood
    Essex
    EnglandBritish76706450001
    LUCAS, Anthony Ronald
    Flat 12 Beatrix House
    208 Old Beatrix Road
    SW5 0BP London
    Administrateur
    Flat 12 Beatrix House
    208 Old Beatrix Road
    SW5 0BP London
    British30771870001
    MARRINAN, James
    206815 Hot Springs Place
    Agoura Hills California Ca91301
    FOREIGN
    Usa
    Administrateur
    206815 Hot Springs Place
    Agoura Hills California Ca91301
    FOREIGN
    Usa
    American17905570001
    MEDLICOTT, William Jonathan
    Wild Boars
    Monteswood Lane
    RH17 7NS Horsted Keynes
    West Sussex
    Administrateur
    Wild Boars
    Monteswood Lane
    RH17 7NS Horsted Keynes
    West Sussex
    EnglandEnglish44636500002
    POHL, Henry Theodore
    227 Hanworth Road
    TW12 3EF Hampton
    Middlesex
    Administrateur
    227 Hanworth Road
    TW12 3EF Hampton
    Middlesex
    British32450180001
    SANITSKY, Robert
    9100 Wilshire Boulevard
    Suite 600
    90212 Beverley Hills
    Los Angeles California
    Usa
    Administrateur
    9100 Wilshire Boulevard
    Suite 600
    90212 Beverley Hills
    Los Angeles California
    Usa
    Usa53433450001
    SMITH, Kathryn
    9 Hanover Steps
    Saint Georges Fields
    W2 2YG London
    Administrateur
    9 Hanover Steps
    Saint Georges Fields
    W2 2YG London
    British77161950001
    TILL, Stewart Myles
    Barrymore 6 High Street
    RG10 8HY Wargrave
    Berkshire
    Administrateur
    Barrymore 6 High Street
    RG10 8HY Wargrave
    Berkshire
    British24204890001
    WILLIAMS, Lucinda Mary
    34 Helena Road
    SL4 1JN Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    34 Helena Road
    SL4 1JN Windsor
    Berkshire
    British55121890001

    THE UK CHANNEL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee & debenture
    Créé le 06 févr. 1991
    Livré le 14 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreements dated 5/2/91 and all other facility documents on defined
    Brèves mentions
    (See doc M132 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank Plcas Agent and Trustee for and on Behalf of Trelfand the Banks
    Transactions
    • 14 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Amanded and restated copyright collaterol assignment agreement
    Créé le 05 févr. 1991
    Livré le 14 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreement dated 10TH february 1991 and all other facility documents (as defined)
    Brèves mentions
    All of the company's right title and interest in the " collaferal" (see form 395 ref M108 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC(As Agent for the Benefit of the Beneficiaries as Defined)
    Transactions
    • 14 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trademark security agreement
    Créé le 05 févr. 1991
    Livré le 14 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreement dated 10TH february 1991 and all other facility documents (as defined)
    Brèves mentions
    All of the company's right title and interest in the "collaferal" (see form 395 - ref M124 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC(As Agent for the Benefit of the Beneficiaries as Defined)
    Transactions
    • 14 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Us security agreement (created by the home service channel limited now k/a the U.K. channel limited)
    Créé le 05 févr. 1991
    Livré le 14 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreement dated 10TH february 1991 and all other facility documents (as defined)
    Brèves mentions
    All of the company's right title and interest in the "collaferal" (see form 396- ref m 116 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC(As Agent for the Benefit of the Beneficiaries as Defined)
    Transactions
    • 14 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0