HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED

HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02303704
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED ?

    • Vente de voitures neuves et de véhicules légers (45111) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    No 1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HIGHTHIRD LIMITED11 oct. 198811 oct. 1988

    Quels sont les derniers comptes de HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    7 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 2 Penman Way, Grove Park Leicester Leicestershire LE19 1st à No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP le 08 oct. 2015

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 28 sept. 2015

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Cessation de la nomination de Gerard Edward Nieuwenhuys en tant que directeur le 07 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 avr. 2015

    État du capital au 24 avr. 2015

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 avr. 2014

    État du capital au 29 avr. 2014

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Mr Adam Collinson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jeremy Mallett en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robert Kurnick en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Geoffrey Page-Morris en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Laurence Vaughan en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    14 pagesAA

    Cessation de la nomination de David Kevin Jones en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COLLINSON, Adam
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    148166240001
    COLLINSON, Adam
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish136375910001
    BAKER, Lorna Margaret
    47 Summerleys Road
    HP27 9DS Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    47 Summerleys Road
    HP27 9DS Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British48588210001
    CARPENTER, Mark Gwilym
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    British105829630002
    JONES, David Kevin
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    157724100001
    MORRIS, Mark Christopher
    Curtis House
    LE15 9JG Stoke Dry
    Rutland
    Secrétaire
    Curtis House
    LE15 9JG Stoke Dry
    Rutland
    British147628740001
    CARPENTER, Mark Gwilym
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish105829630002
    HAMILTON, John
    12 Hardwick Close
    SL6 5JU Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    12 Hardwick Close
    SL6 5JU Maidenhead
    Berkshire
    British26625940001
    KURNICK, Robert Harold
    670 Pleasant
    Birmingham
    Michigan 48009
    Usa
    Administrateur
    670 Pleasant
    Birmingham
    Michigan 48009
    Usa
    United StatesAmerican82981540007
    MALLETT, Jeremy Richard
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish71752820001
    MORRIS, Mark Christopher
    Curtis House
    LE15 9JG Stoke Dry
    Rutland
    Administrateur
    Curtis House
    LE15 9JG Stoke Dry
    Rutland
    EnglandBritish147628740001
    NIEUWENHUYS, Gerard Edward
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish66435290003
    PAGE-MORRIS, Geoffrey Giovanni
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish105444550002
    VAUGHAN, Laurence Edward William
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandEnglish40326440010

    HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 20 oct. 2000
    Livré le 26 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a valley road hughenden way high wycombe buckinghamshire t/n BM19263. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 28 sept. 2000
    Livré le 03 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a valley road hughenden valley high wycombe buckinghamshire t/no. BM128087. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 déc. 1998
    Livré le 13 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land k/a land and buildings on the south east side of hughenden road high wycombe t/n BM19263 and l/a land and buildings on the south east side of friars gardens hughendedn high wycombe t/n BM128087 by way of assignment the benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Ucb Group Limited
    Transactions
    • 13 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Residual floating charge
    Créé le 31 déc. 1998
    Livré le 13 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of floating charge the company's undertaking property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Ucb Group Limited
    Transactions
    • 13 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 26 janv. 1993
    Livré le 28 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of overdraft facilities (as defined in the charge)
    Brèves mentions
    First all the company's present and future stock of used motor vehicles of whatsoever nature and all the company's right title and interest therein. Secondly all moneys from time to time payable under any insurances in respect of motor vehicles. And thirdly all goods given in exchange for the motor vehicles.
    Personnes ayant droit
    • Bmw Finance (GB) Limited
    Transactions
    • 28 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 01 mai 1992
    Livré le 02 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The company's present and future stock of used vehicles and all the company's right, title and interest therein all moneys from time to time payable under any insurances all debts from time to time owing to the company in respect of motor vehicles. See doc for details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 02 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 14 sept. 1989
    Livré le 03 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    • 23 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 sept. 1989
    Livré le 19 sept. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3 I PLC
    Transactions
    • 19 sept. 1989Enregistrement d'une charge
    • 24 sept. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 sept. 1989
    Livré le 15 sept. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed
    Brèves mentions
    All monies from time to time owing to the company by the chargor in respect of refund monies (continued see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Bmw Finance (GB) Limited
    Transactions
    • 15 sept. 1989Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 14 sept. 1989
    Livré le 15 sept. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First all the chargors present and future stock of used motor vehicles of whatsoever nature and all the chargor's right title and interest therein (for full details see form 395).
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited.
    Transactions
    • 15 sept. 1989Enregistrement d'une charge
    • 16 juin 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 sept. 2015Commencement of winding up
    16 nov. 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    practitioner
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0