HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02303704 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED ?
| Adresse du siège social | No 1 Dorset Street SO15 2DP Southampton Hampshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2014 |
Quels sont les derniers dépôts pour HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 6 pages | 4.71 | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 2 Penman Way, Grove Park Leicester Leicestershire LE19 1st à No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP le 08 oct. 2015 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gerard Edward Nieuwenhuys en tant que directeur le 07 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2011 | 12 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Adam Collinson en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jeremy Mallett en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Kurnick en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Geoffrey Page-Morris en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Laurence Vaughan en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2010 | 14 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Kevin Jones en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLINSON, Adam | Secrétaire | Penman Way Grove Park LE19 1ST Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | 148166240001 | |||||||
| COLLINSON, Adam | Administrateur | Penman Way Grove Park LE19 1ST Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | England | British | 136375910001 | |||||
| BAKER, Lorna Margaret | Secrétaire | 47 Summerleys Road HP27 9DS Princes Risborough Buckinghamshire | British | 48588210001 | ||||||
| CARPENTER, Mark Gwilym | Secrétaire | Penman Way Grove Park LE19 1ST Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | British | 105829630002 | ||||||
| JONES, David Kevin | Secrétaire | Penman Way Grove Park LE19 1ST Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | 157724100001 | |||||||
| MORRIS, Mark Christopher | Secrétaire | Curtis House LE15 9JG Stoke Dry Rutland | British | 147628740001 | ||||||
| CARPENTER, Mark Gwilym | Administrateur | Penman Way Grove Park LE19 1ST Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 105829630002 | |||||
| HAMILTON, John | Administrateur | 12 Hardwick Close SL6 5JU Maidenhead Berkshire | British | 26625940001 | ||||||
| KURNICK, Robert Harold | Administrateur | 670 Pleasant Birmingham Michigan 48009 Usa | United States | American | 82981540007 | |||||
| MALLETT, Jeremy Richard | Administrateur | Penman Way Grove Park LE19 1ST Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 71752820001 | |||||
| MORRIS, Mark Christopher | Administrateur | Curtis House LE15 9JG Stoke Dry Rutland | England | British | 147628740001 | |||||
| NIEUWENHUYS, Gerard Edward | Administrateur | Penman Way Grove Park LE19 1ST Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 66435290003 | |||||
| PAGE-MORRIS, Geoffrey Giovanni | Administrateur | Penman Way Grove Park LE19 1ST Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | England | British | 105444550002 | |||||
| VAUGHAN, Laurence Edward William | Administrateur | Penman Way Grove Park LE19 1ST Leicester 2 Leicestershire United Kingdom | England | English | 40326440010 |
HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Créé le 20 oct. 2000 Livré le 26 oct. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The f/h property k/a valley road hughenden way high wycombe buckinghamshire t/n BM19263. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 28 sept. 2000 Livré le 03 oct. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H property k/a valley road hughenden valley high wycombe buckinghamshire t/no. BM128087. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 31 déc. 1998 Livré le 13 janv. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land k/a land and buildings on the south east side of hughenden road high wycombe t/n BM19263 and l/a land and buildings on the south east side of friars gardens hughendedn high wycombe t/n BM128087 by way of assignment the benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Residual floating charge | Créé le 31 déc. 1998 Livré le 13 janv. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of floating charge the company's undertaking property and assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 26 janv. 1993 Livré le 28 janv. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of overdraft facilities (as defined in the charge) | |
Brèves mentions First all the company's present and future stock of used motor vehicles of whatsoever nature and all the company's right title and interest therein. Secondly all moneys from time to time payable under any insurances in respect of motor vehicles. And thirdly all goods given in exchange for the motor vehicles. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 01 mai 1992 Livré le 02 mai 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The company's present and future stock of used vehicles and all the company's right, title and interest therein all moneys from time to time payable under any insurances all debts from time to time owing to the company in respect of motor vehicles. See doc for details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 14 sept. 1989 Livré le 03 oct. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 14 sept. 1989 Livré le 19 sept. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 14 sept. 1989 Livré le 15 sept. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed | |
Brèves mentions All monies from time to time owing to the company by the chargor in respect of refund monies (continued see form 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 14 sept. 1989 Livré le 15 sept. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions First all the chargors present and future stock of used motor vehicles of whatsoever nature and all the chargor's right title and interest therein (for full details see form 395). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0