HOLIDAYBREAK LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | HOLIDAYBREAK LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02305562 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HOLIDAYBREAK LIMITED ?
Adresse du siège social | Suite 3.05-06 3rd Floor, 80 Coleman Street EC2R 5BJ London England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HOLIDAYBREAK LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2025 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 30 mars 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour HOLIDAYBREAK LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 23 févr. 2026 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 09 mars 2026 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 23 févr. 2025 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour HOLIDAYBREAK LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Satisfaction de la charge 023055620030 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Suite 3.05-06 3rd Floor 80, Coleman Street London EC2R 5BJ England à Suite 3.05-06 3rd Floor 80 Coleman Street London EC2R 5BJ | 1 pages | AD02 | ||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 3rd Floor 30 Millbank London SW1P 4DU United Kingdom à Suite 3.05-06 3rd Floor 80, Coleman Street London EC2R 5BJ | 1 pages | AD02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 23 févr. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Notification de Ares Management Corporation en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 juil. 2020 | 2 pages | PSC02 | ||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Suite 3.05-06 3rd Floor, 80 Coleman Street London EC2R 5BJ | 1 pages | AD04 | ||
Inscription de la charge 023055620037, créée le 27 févr. 2025 | 22 pages | MR01 | ||
Inscription de la charge 023055620036, créée le 20 déc. 2024 | 15 pages | MR01 | ||
Période comptable actuelle prolongée du 30 mars 2025 au 31 mars 2025 | 1 pages | AA01 | ||
Comptes consolidés établis au 30 mars 2024 | 79 pages | AA | ||
Nomination de Ms. Annabelle Cai en tant qu'administrateur le 12 nov. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Yeow Ming Chong en tant que directeur le 12 nov. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Richard Cooke le 05 nov. 2024 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jason Aleksander Kardachi le 05 nov. 2024 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr. Yeow Ming Chong le 05 nov. 2024 | 2 pages | CH01 | ||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 3rd Floor 30 Millbank London SW1P 4DU | 1 pages | AD03 | ||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Suite 3.05-06 3rd Floor, 80 Coleman Street London EC2R 5BJ | 1 pages | AD04 | ||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Suite 3.05-06 3rd Floor, 80 Coleman Street London EC2R 5BJ | 1 pages | AD04 | ||
Changement d'adresse du siège social de 3rd Floor 30 Millbank London SW1P 4DU United Kingdom à Suite 3.05-06 3rd Floor, 80 Coleman Street London EC2R 5BJ le 20 août 2024 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 23 févr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes consolidés établis au 30 mars 2023 | 77 pages | AA | ||
Inscription de la charge 023055620035, créée le 28 nov. 2023 | 15 pages | MR01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr. Chong Yeow Ming le 07 août 2023 | 2 pages | CH01 | ||
Nomination de Mr. Chong Yeow Ming en tant qu'administrateur le 07 août 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr. Ben Graham Cawley-Harrison en tant qu'administrateur le 07 août 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Qui sont les dirigeants de HOLIDAYBREAK LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAI, Annabelle, Ms. | Administrateur | 3rd Floor, 80 Coleman Street EC2R 5BJ London Suite 3.05-06 England | Singapore | Singaporean | Company Director | 329381860001 | ||||
CAWLEY-HARRISON, Ben Graham, Mr. | Administrateur | 3rd Floor, 80 Coleman Street EC2R 5BJ London Suite 3.05-06 England | England | British | Director | 312389320001 | ||||
COOKE, Michael Richard | Administrateur | 3rd Floor, 80 Coleman Street EC2R 5BJ London Suite 3.05-06 England | England | British | Director | 179814320001 | ||||
KARDACHI, Jason Aleksander | Administrateur | 3rd Floor, 80 Coleman Street EC2R 5BJ London Suite 3.05-06 England | Singapore | Australian | Director | 249369590002 | ||||
BADDELEY, Robert Gregory | Secrétaire | 52 Eyebrook Road Bowdon WA14 3LP Altrincham Cheshire | British | 28024220002 | ||||||
BALI, Navneet | Secrétaire | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire England | 192314080001 | |||||||
CULLEN, Dominique | Secrétaire | 30 Millbank SW1P 4DU London 3rd Floor United Kingdom | 196105250001 | |||||||
HARAN, Gordon Cosworth | Secrétaire | Lake House Leek Old Road SK11 0HZ Sutton Cheshire | British | 41723780001 | ||||||
KINSEY, Martin Lowther | Secrétaire | 32 Bodmin Avenue SK10 3JU Macclesfield Cheshire | British | 39254470001 | ||||||
MAY, Timothy William | Secrétaire | 7 Newby Drive Broadheath WA14 4EW Altrincham Cheshire | British | 27408660001 | ||||||
VICKERS, Julie Alison | Secrétaire | 22 Barlow Way CW11 1PB Sandbach Cheshire | British | 71031050002 | ||||||
WILLIAMSON, Alexandra Dilys | Secrétaire | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | British | 100325220002 | ||||||
ALLAN, Leslie Stewart | Administrateur | 78 Honor Oak Road SE23 3RR London | British | Company Director | 1704690001 | |||||
ATKINSON, Richard Westaway | Administrateur | Smithy Lane Farm Rainow SK10 5UP Macclesfield Cheshire | England | British | Chief Executive | 111861370001 | ||||
AYLING, Robert John | Administrateur | 83 Hepworth Court 30 Gatliff Road SW1W 8QN London | United Kingdom | British | Director | 51938690003 | ||||
BADDELEY, Robert Gregory | Administrateur | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | Great Britain | British | Chartered Accountant | 28024220020 | ||||
BALI, Navneet | Administrateur | 30 Millbank SW1P 4DU London 3rd Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 83088120002 | ||||
BANCE, Patrick | Administrateur | Whampoa East 8 Riversuites 338526 20 Singapore | Singapore | Irish | Director | 264706800001 | ||||
BANERJI, Sujit | Administrateur | Orange Grove Road Apt No. 05-02 Singapore 8 Singapore | Singapore | Indian | Company Director | 262901860001 | ||||
BORRELLI, Cosimo | Administrateur | (Duplex), Block 20 Coastline Villa 20 Discovery Bay Road, Peninsula Village Discovery Bay Flat B 4-5/F Lantau New Territories Hong Kong | Hong Kong | Australian | Director | 263975030002 | ||||
BRIGHT, Neil Irvine | Administrateur | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 180993450001 | ||||
CHEETHAM, Matthew James | Administrateur | Carn Brae Upcast Lane SK9 7SE Alderley Edge Cheshire | United Kingdom | British | Company Director | 20227170002 | ||||
CHONG, Yeow Ming, Mr. | Administrateur | 3rd Floor, 80 Coleman Street EC2R 5BJ London Suite 3.05-06 England | Singapore | Malaysian | Director | 312389720002 | ||||
COLEMAN, John | Administrateur | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 56366250007 | ||||
COX, Travers Vincent | Administrateur | Warren Hill Frensham GU10 3AA Farnham Surrey | Australian | Director | 7860450002 | |||||
CREW, James Robert | Administrateur | 123 Hale Road Hale WA15 9HQ Altrincham Cheshire | British | Divisional Managing Director | 15842470001 | |||||
CRICHTON-MILLER, Hugh Angus | Administrateur | 25 Abercromby Place EH3 6QE Edinburgh | Scotland | British | Consultant/Director | 16687350004 | ||||
CUST, Nicholas Pury | Administrateur | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 159977730001 | ||||
DAVIES, Martin William Oliver | Administrateur | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | England | British | Director | 98399000002 | ||||
FLORENCE, Ngu Chia Yi, Ms. | Administrateur | Marine Vista #06 - 65 449027 Neptune Court 3 Singapore | Singapore | Singaporean | Company Director | 295385830001 | ||||
FOLKMAN, Peter John | Administrateur | 6 Oakfield Road Didsbury M20 6XA Manchester Lancashire | England | British | Venture Capital | 35541320001 | ||||
GOEL, Dinesh, Mr. | Administrateur | 30 Millbank SW1P 4DU London 3rd Floor United Kingdom | Singapore | Indian | Director | 254873760001 | ||||
GOENKA, Abhishek | Administrateur | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire England | England | Indian | General Manager | 192313750001 | ||||
GREENBURY, James Brett | Administrateur | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 13172950005 | ||||
HARMAN, Gordon | Administrateur | Withinlee Cottage Within Lee Road Mottram SK10 4QE St Andrew Cheshire | British | Non-Executive Director | 102037580001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HOLIDAYBREAK LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ares Management Corporation | 02 juil. 2020 | Avenue Of The Stars 12th Floor CA 90067 Los Angeles 2000 United States | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Prometheon Holdings (Uk) Limited | 06 avr. 2016 | 30 Millbank SW1P 4EE London 6th Floor England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0