C. G. PALETTA LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéC. G. PALETTA LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueConverti ou fermé
    Numéro de société 02305653
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de C. G. PALETTA LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe C. G. PALETTA LIMITED ?

    Adresse du siège social
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de C. G. PALETTA LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au01 janv. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour C. G. PALETTA LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour C. G. PALETTA LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Certificat d'immatriculation d'une société de secours mutuel

    CERTIPS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Convert to an I & ps 17/06/2011
    RES13

    Divers

    Convert to I & ps
    2 pagesMISC

    Cessation de la nomination de Stephen Humes en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 01 janv. 2011

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 sept. 2010

    État du capital au 27 sept. 2010

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy Hurrell le 01 août 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen Humes le 01 août 2010

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 02 janv. 2010

    4 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 11 janv. 2010 au 02 janv. 2010

    1 pagesAA01

    Nomination de Mrs Caroline Jane Sellers en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Katherine Eldridge en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 sept. 2009 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 10 janv. 2009

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages190

    legacy

    1 pages353

    Comptes pour une société dormante établis au 12 janv. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de C. G. PALETTA LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SELLERS, Caroline Jane
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    Secrétaire
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    150156790001
    HURRELL, Timothy
    5th Floor New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    Administrateur
    5th Floor New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United KingdomBritish99724260001
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Secrétaire
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Secrétaire
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    English43686960001
    PALETTA, Carmello Gino
    Bryn Issa
    Vicarage Lane Gresford
    LL12 8US Wrexham
    Clwyd
    Secrétaire
    Bryn Issa
    Vicarage Lane Gresford
    LL12 8US Wrexham
    Clwyd
    British36708180001
    UNITED CO OPERATIVES SECRETARY LIMITED
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    Secrétaire
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    110061750001
    BEAUMONT, Martin Dudley
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish10084840001
    GRIFFITHS, Paul
    The Old Vicarage
    The Cobbles Lower Peover
    WA16 9PZ Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    The Old Vicarage
    The Cobbles Lower Peover
    WA16 9PZ Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish34401430002
    HUMES, Stephen
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Administrateur
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritish84087790001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    United KingdomEnglish43686960001
    KEW, Philip Anthony
    31 Maypole Gardens
    Wistowgate
    YO8 3TG Cawood
    North Yorkshire
    Administrateur
    31 Maypole Gardens
    Wistowgate
    YO8 3TG Cawood
    North Yorkshire
    EnglandBritish84868550001
    MCCRACKEN, Philip Guy
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    Administrateur
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish106997230001
    PALETTA, Carmello Gino
    Bryn Issa
    Vicarage Lane Gresford
    LL12 8US Wrexham
    Clwyd
    Administrateur
    Bryn Issa
    Vicarage Lane Gresford
    LL12 8US Wrexham
    Clwyd
    United KingdomBritish36708180001
    PALETTA, Jeanette Denise
    Bryn Issa
    Vicarage Lane Gresford
    LL12 8US Wrexham
    Clwyd
    Administrateur
    Bryn Issa
    Vicarage Lane Gresford
    LL12 8US Wrexham
    Clwyd
    WalesBritish15710130002
    WATES, Martyn James
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish60114700001
    UNITED CO OPERATIVES DIRECTOR 1 LIMITED
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    Administrateur
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    110062190001

    C. G. PALETTA LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge by the company and robert graham lewis & gwenna catherine lewis as mortgagor,by the company as trustee for the mortgagor and by the company as principal debtor
    Créé le 07 mai 1997
    Livré le 15 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever but the security as constituted shall be enforceable only in respect of the liabilities of the principal debtor to the bank under the terms of a facility letter dated 8 july 1996 a copy of which is annexed to the charge,or any subsequent renewal or amendment thereof
    Brèves mentions
    Dovenby chester road rossett near wrexham t/no.WA619282.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 août 1996
    Livré le 08 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    171/173 chester road, garden village, wrexham, clwyd.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 août 1996
    Livré le 08 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    12 borras road, wrexham, clwyd title no. WA78736.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 juin 1995
    Livré le 22 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    175 chester road, acton, wrexham clwyd t/no: WA743764.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 juin 1995
    Livré le 22 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at shones lane, llay, near wrexham (k/a the spar shop) clwyd t/no: WA474880.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 mai 1995
    Livré le 02 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    81 & 83 holt road, wrexham, clwyd.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 janv. 1995
    Livré le 09 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    90/94 (even numbers only) hoole road, woodchurch, wirral, merseyside.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 sept. 1993
    Livré le 04 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Plot of land situated at and fronting to mold road, gwersyllt, wrexham, clwyd t/no: wa 652507.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 déc. 1992
    Livré le 29 déc. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Eurobuild belle vue road wrexham clwyd t/n WA629389.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 déc. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 juin 1989
    Livré le 15 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 1989Enregistrement d'une charge
    • 23 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0