EUROPEAN INTEGRATED CARRIERS LIMITED

EUROPEAN INTEGRATED CARRIERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEUROPEAN INTEGRATED CARRIERS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02315826
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EUROPEAN INTEGRATED CARRIERS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe EUROPEAN INTEGRATED CARRIERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Global Shipping Services Ltd
    Kiln Lane Trading Estate
    DN41 8DY Stallingborough Grimsby
    North East Lincolnshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EUROPEAN INTEGRATED CARRIERS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EIC LIMITED27 janv. 198927 janv. 1989
    RAPID 7101 LIMITED10 nov. 198810 nov. 1988

    Quels sont les derniers comptes de EUROPEAN INTEGRATED CARRIERS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour EUROPEAN INTEGRATED CARRIERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 27 sept. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 27 sept. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2018

    8 pagesAA

    Nomination de Mr Peter Robert Hickson en tant qu'administrateur le 12 juin 2019

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 27 sept. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2017

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 27 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2016

    15 pagesAA

    Cessation de la nomination de Roger Thomas Leitch en tant que directeur le 16 avr. 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 27 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 oct. 2015

    État du capital au 12 oct. 2015

    • Capital: GBP 1,017
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 oct. 2014

    État du capital au 02 oct. 2014

    • Capital: GBP 1,017
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    11 pagesAA

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 sept. 2013

    État du capital au 27 sept. 2013

    • Capital: GBP 1,017
    SH01

    Qui sont les dirigeants de EUROPEAN INTEGRATED CARRIERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JOBES, David Alan
    26 The Avenue
    Healing
    DN41 7NE Grimsby
    North East Lincolnshire
    Secrétaire
    26 The Avenue
    Healing
    DN41 7NE Grimsby
    North East Lincolnshire
    British55316290002
    HICKSON, Peter Robert
    C/O Global Shipping Services Ltd
    Kiln Lane Trading Estate
    DN41 8DY Stallingborough Grimsby
    North East Lincolnshire
    Administrateur
    C/O Global Shipping Services Ltd
    Kiln Lane Trading Estate
    DN41 8DY Stallingborough Grimsby
    North East Lincolnshire
    EnglandBritish259446490001
    JOBES, David Alan
    26 The Avenue
    Healing
    DN41 7NE Grimsby
    North East Lincolnshire
    Administrateur
    26 The Avenue
    Healing
    DN41 7NE Grimsby
    North East Lincolnshire
    EnglandBritish55316290002
    COPLAND, Colin George
    19 Claire Avenue
    RG11 1EB Wokingham
    Berkshire
    Secrétaire
    19 Claire Avenue
    RG11 1EB Wokingham
    Berkshire
    British35697780001
    DREWETT, Denis
    9 Cavendish Court
    PR9 9EE Southport
    Merseyside
    Administrateur
    9 Cavendish Court
    PR9 9EE Southport
    Merseyside
    British30834910001
    GOODHART, Joseph
    Great Givendale
    Pocklington
    YO4 2TT York
    Administrateur
    Great Givendale
    Pocklington
    YO4 2TT York
    British30834920001
    LEITCH, Roger Thomas
    Beech House43 Main Street
    Saxby All Saints
    DN20 0QF Brigg
    South Humberside
    Administrateur
    Beech House43 Main Street
    Saxby All Saints
    DN20 0QF Brigg
    South Humberside
    EnglandBritish94573040001
    LIMB, Arthur Brian
    Fircroft Kemp Road
    Swanland
    HU14 3LY North Ferriby
    North Humberside
    Administrateur
    Fircroft Kemp Road
    Swanland
    HU14 3LY North Ferriby
    North Humberside
    British23039300001
    RYAN, Charles John
    Braxholme
    St Giles Croft
    HU17 8LD Beverley
    North Humberside
    Administrateur
    Braxholme
    St Giles Croft
    HU17 8LD Beverley
    North Humberside
    British21697760001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EUROPEAN INTEGRATED CARRIERS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Global Shipping Services Group Ltd
    Kiln Lane Trading Estate
    Stallingborough
    DN41 8DY Grimsby
    Global Shipping
    North East Lincolnshire
    England
    27 sept. 2016
    Kiln Lane Trading Estate
    Stallingborough
    DN41 8DY Grimsby
    Global Shipping
    North East Lincolnshire
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement3369710
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    EUROPEAN INTEGRATED CARRIERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 10 oct. 2011
    Livré le 11 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 28 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Omnibus guarantee & set-off agreement
    Créé le 03 janv. 2006
    Livré le 05 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from or by any one or more of the principals to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Its credit balance and all other money and liabilities.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 05 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 17TH june 1997 and
    Créé le 04 juil. 2002
    Livré le 12 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 17 juin 1997
    Livré le 19 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Letter of charge
    Créé le 12 oct. 1992
    Livré le 14 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All omnies due or to become due from spacehire (goole) limited abd all or any of the other companies named therein to the charge on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the banks books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 oct. 1992
    Livré le 13 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 05 févr. 1990
    Livré le 12 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future including book & other book uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 12 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 18 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0