EVOLUTION SECURITIES LIMITED

EVOLUTION SECURITIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEVOLUTION SECURITIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02316630
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EVOLUTION SECURITIES LIMITED ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe EVOLUTION SECURITIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Greyfriars Court
    Paradise Square
    OX1 1BE Oxford
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EVOLUTION SECURITIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EVOLUTION BEESON GREGORY LIMITED01 août 200201 août 2002
    BEESON GREGORY LIMITED23 mars 198923 mars 1989
    RAVENRIDGE LIMITED14 nov. 198814 nov. 1988

    Quels sont les derniers comptes de EVOLUTION SECURITIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour EVOLUTION SECURITIES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour EVOLUTION SECURITIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 17 déc. 2015

    6 pages4.68

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Changement d'adresse du siège social de 2 Gresham Street London EC2V 7QP à Greyfriars Court Paradise Square Oxford OX1 1BE le 06 janv. 2015

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 18 déc. 2014

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Steven Mark Burgess en tant que directeur le 28 nov. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Brian Mark Johnson en tant que directeur le 17 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Kevin Patrick Mckenna en tant qu'administrateur le 08 déc. 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Christopher Stephen Heyworth en tant qu'administrateur le 08 déc. 2014

    2 pagesAP01

    Deuxième dépôt de AR01 précédemment soumis à Companies House mis à jour jusqu'au 04 mai 2014

    16 pagesRP04

    Nomination de Mr. Brian Mark Johnson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Currie en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 mai 2014

    État du capital au 19 mai 2014

    • Capital: GBP 203,179
    SH01
    Annotations
    DateAnnotation
    06 juin 2014A SECOND FILED AR01 WAS REGISTERED ON 6/6/14

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    26 pagesAA

    Deuxième dépôt de AR01 précédemment soumis à Companies House mis à jour jusqu'au 04 mai 2013

    18 pagesRP04

    Cessation de la nomination de Ian Hurst en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Ian James Hurst en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    17 pagesAR01
    Annotations
    DateAnnotation
    06 nov. 2013A second filed AR01 was registered on 06/11/2013

    Qui sont les dirigeants de EVOLUTION SECURITIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MILLER, David
    Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    United Kingdom
    Secrétaire
    Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    United Kingdom
    166685880001
    BARNES, Andrew James
    c/o Investec Bank Plc
    Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    Administrateur
    c/o Investec Bank Plc
    Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    EnglandBritishAccountant73560970002
    HEYWORTH, Christopher Stephen
    Paradise Square
    OX1 1BE Oxford
    Greyfriars Court
    Administrateur
    Paradise Square
    OX1 1BE Oxford
    Greyfriars Court
    EnglandBritishChartered Accountant193541040001
    MCKENNA, Kevin Patrick
    Paradise Square
    OX1 1BE Oxford
    Greyfriars Court
    Administrateur
    Paradise Square
    OX1 1BE Oxford
    Greyfriars Court
    EnglandIrishChief Operating Officer Of Investec Bank Plc169418850001
    FONG, Yew Meng
    8 Lindsay Square
    SW1V 3SB London
    Secrétaire
    8 Lindsay Square
    SW1V 3SB London
    Malaysian47414480001
    GORDON, Nigel Raymond
    22 Adelaide Close
    HA7 3EN Stanmore
    Middlesex
    Secrétaire
    22 Adelaide Close
    HA7 3EN Stanmore
    Middlesex
    British34955700003
    LEE, Tony
    8 Rossdale
    TN2 3PG Tunbridge Wells
    Kent
    Secrétaire
    8 Rossdale
    TN2 3PG Tunbridge Wells
    Kent
    British49293090003
    THOMAS, David Albert
    132 Castelnau
    SW13 9ET London
    Secrétaire
    132 Castelnau
    SW13 9ET London
    United Kingdom74169870001
    WILSON, Robert Ian
    35 Horn Park Lane
    Lee
    SE12 8UX London
    Secrétaire
    35 Horn Park Lane
    Lee
    SE12 8UX London
    British10213920001
    BALDOCK, Norman Frank
    13 Paveley Drive
    SW11 3TP London
    Administrateur
    13 Paveley Drive
    SW11 3TP London
    BritishCompany Director4599850001
    BARTLETT, Anthony David
    19 Tedworth Square
    SW3 4DR London
    Administrateur
    19 Tedworth Square
    SW3 4DR London
    ScotlandBritishChartered Accountant43397430001
    BEESON, Andrew Nigel Wendover
    21 Warwick Square
    SW1V 2AB London
    Administrateur
    21 Warwick Square
    SW1V 2AB London
    BritishStockbroker89501920001
    BELL, Guy Anthony
    The Stables Maidstone Road
    TN11 0DN Hadlow
    Kent
    Administrateur
    The Stables Maidstone Road
    TN11 0DN Hadlow
    Kent
    BritishCompany Director55256600003
    BELL, Guy Anthony
    53 Montholme Road
    SW11 6HX London
    Administrateur
    53 Montholme Road
    SW11 6HX London
    BritishStockbroker55256600002
    BENNETT, John
    4 Sword Close
    EN10 7TE Broxbourne
    Hertfordshire
    Administrateur
    4 Sword Close
    EN10 7TE Broxbourne
    Hertfordshire
    BritishDirector103783440001
    BOYS STONES, George Francis
    21 Ouseley Road
    SW12 8ED London
    Administrateur
    21 Ouseley Road
    SW12 8ED London
    BritishStockbroker77487620003
    BROMHEAD, James Claude
    Hill End
    Monk Sherborne
    RG26 5HB Tadley
    Hampshire
    Administrateur
    Hill End
    Monk Sherborne
    RG26 5HB Tadley
    Hampshire
    EnglandBritishStockbroker39786240002
    BROOKS, Howard Paul
    Yew Cottage
    Chownes Mead Lane
    RH16 4BS Cuckfield
    Administrateur
    Yew Cottage
    Chownes Mead Lane
    RH16 4BS Cuckfield
    BritishEngineer69620780002
    BURGESS, Steven Mark
    c/o Investec Bank Plc
    Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    Administrateur
    c/o Investec Bank Plc
    Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    England
    EnglandBritishAccountant3631530002
    BUTTERWORTH, Rachel Michele
    1 Saint Maur Road
    Fulham
    SW6 4DR London
    Administrateur
    1 Saint Maur Road
    Fulham
    SW6 4DR London
    BritishStockbroker77487650001
    BYFORD, Charles William
    2b Lee Terrace
    Blackheath
    SE3 9TZ London
    Administrateur
    2b Lee Terrace
    Blackheath
    SE3 9TZ London
    BritishChartered Accountant489360002
    CALLAWAY, Christopher Alan
    Brook House 105 Church End Lane
    SS11 7DN Wickford
    Essex
    Administrateur
    Brook House 105 Church End Lane
    SS11 7DN Wickford
    Essex
    BritishStockbroker43470340001
    CARTER, Graham Crispin
    12 Falconers Park
    CM21 0AU Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    12 Falconers Park
    CM21 0AU Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    BritishSettlements Director454510001
    CLUCAS, Richard Paul
    40 Kings Drive
    HA8 8SE Edgware
    Middlesex
    Administrateur
    40 Kings Drive
    HA8 8SE Edgware
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director33496520002
    COLE, Graham
    18 Shepherd House
    5 Shepherd Street
    W1J 7HN London
    Administrateur
    18 Shepherd House
    5 Shepherd Street
    W1J 7HN London
    BritishChartered Accountant105172590001
    COOLE, Raymond Douglas
    9 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Orpington
    Kent
    Administrateur
    9 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Orpington
    Kent
    EnglandBritishCorporate Finance Executive31443400002
    CORNELIUS, Guy
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    9th Floor
    Administrateur
    100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    9th Floor
    BritishBanker139457440001
    CURRIE, David Scott
    Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7QP London
    2
    United Kingdom
    United KingdomBritishBanker167052740001
    DELL, Graeme John
    72 Mount Ararat Road
    TW10 6PN Richmond
    Surrey
    Administrateur
    72 Mount Ararat Road
    TW10 6PN Richmond
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director107996430001
    FLOWER, James Herbert
    Flat 5 Waveney House
    SW3 4HA London
    Administrateur
    Flat 5 Waveney House
    SW3 4HA London
    BritishStockbroker10213960001
    FORSYTHE, Bruce Hector William
    35 Barlings Road
    AL5 2AW Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    35 Barlings Road
    AL5 2AW Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishHead Of Research322680080002
    FORSYTHE, Bruce Hector William
    Coronel
    29 Saint Albans Road East
    AL10 0EJ Hatfield
    Hertfordshire
    Administrateur
    Coronel
    29 Saint Albans Road East
    AL10 0EJ Hatfield
    Hertfordshire
    BritishResearch Analyst77487770001
    FRASER, Rupert Michael
    Acfold Road
    SW6 2AJ London
    31
    Administrateur
    Acfold Road
    SW6 2AJ London
    31
    United KingdomBritishBanker138932880001
    FREEMAN, Jonathan David
    79 Sisters Avenue
    SW11 5SW London
    Administrateur
    79 Sisters Avenue
    SW11 5SW London
    BritishCorporate Finance Executive65531350001
    GORDON, John Edwin
    Great Jenkins
    Jenkins Lane
    CM22 7QL Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    Great Jenkins
    Jenkins Lane
    CM22 7QL Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishStockbroker29696440002

    EVOLUTION SECURITIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A custody agreement
    Créé le 17 août 2011
    Livré le 26 août 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any custodian under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Under the agreement the custodian shall be entitled to retain securities, which any of them has been instructed to receive against payment on behalf of the client or client's customer, but for which the sufficient funds in the cash account are not available or the relevant custodian has not received payment. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nordea Bank Danmark a/S, Nordea Bank Finland PLC, Nordea Bank Norge Asa and Nordea Bank Ab
    Transactions
    • 26 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Pledge agreement
    Créé le 17 août 2011
    Livré le 26 août 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All such financial instruments which are from time to time registered on the custody account and all such funds which are from time to time deposited to the bank account 2000671047832 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nordea Bank Ab (Publ)
    Transactions
    • 26 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Collateral agreement governing secured borrowings by participants in the euroclear system
    Créé le 26 juin 2009
    Livré le 10 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All collateral including cash and securities clearance accounts in connection with the euroclear system see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Euroclear Bank S.A./N.V.
    Transactions
    • 10 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 03 juil. 2003
    Livré le 14 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All personal property and fixtures of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Bank of New York
    Transactions
    • 14 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 08 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 14 mars 2001
    Livré le 20 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security deed
    Créé le 22 juin 2000
    Livré le 05 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All debts, obligations and liabilities whatsoever on the date of the security deed and from time to time thereafter (whether before or after the service of a default notice) due, owing or incurred by the company to the chargee (whether solely or jointly or jointly or severally with another or others and whether as principal or surely and whether actual or contingent present and future) including (whether before or after any judgement) all interest, costs and other charges whatsover and including without limitation, any such debts, obligations and liabilities which arise out of or in connection with the provision of crest settlement bank facilities (as defined in the security deed)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges all sums and payments on the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or for the account of the company referable to the crest member in crest or any transfer by the company or the crest member of any of its right title or interest to and in stock represented by any credit balance on any such eligible account see ch microfiche for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 10 juin 1997
    Livré le 18 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Account number 30907170. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 juin 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 oct. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge in favour of the stock exchange
    Créé le 08 nov. 1989
    Livré le 09 nov. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All shares, stock and other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • The International Stock Exchange of the United Kingdom and the Republic of Ireland LTD London
    Transactions
    • 09 nov. 1989Enregistrement d'une charge
    • 15 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed.
    Créé le 26 oct. 1989
    Livré le 27 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £250,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the deed.
    Brèves mentions
    By way of legal charge the sum of £250,000.
    Personnes ayant droit
    • Capel-Cure Myers Capital Management Limited.
    Transactions
    • 27 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    • 15 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Broker dealer debenture
    Créé le 14 juin 1989
    Livré le 22 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All bookdebts and other debts sums of moneys (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 1989Enregistrement d'une charge
    • 06 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    EVOLUTION SECURITIES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 déc. 2014Commencement of winding up
    14 juil. 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Susan Margaret Roscoe
    Critchleys
    Greyfriars Court
    OX1 1BE Paradise Square
    Oxford
    practitioner
    Critchleys
    Greyfriars Court
    OX1 1BE Paradise Square
    Oxford
    Lawrence John King
    Greyfriars Court Paradise Square
    OX1 1BE Oxford
    Oxfordshire
    practitioner
    Greyfriars Court Paradise Square
    OX1 1BE Oxford
    Oxfordshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0