ENERVEO LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ENERVEO LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02317133 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ENERVEO LIMITED ?
| Adresse du siège social | Unit 34 Palmerston Business Park PO14 1DJ Fareham England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ENERVEO LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour ENERVEO LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 13 août 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 27 août 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 13 août 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour ENERVEO LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Cessation de la nomination de Peter Craig Schoeneberg en tant que directeur le 10 avr. 2026 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2025 | 47 pages | AA | ||
Satisfaction de la charge 023171330004 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 023171330005 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Déclaration de confirmation établie le 13 août 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Changement d'adresse du siège social de Second Floor Eagle Court 2 Hatchford Way Birmingham B26 3RZ England à Unit 34 Palmerston Business Park Fareham PO14 1DJ le 11 juil. 2025 | 1 pages | AD01 | ||
Nomination de Peter Craig Schoeneberg en tant qu'administrateur le 01 juil. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Luca Warnke en tant que directeur le 01 juil. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Nathan Sanders en tant que directeur le 01 juil. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Adrian Marc James Rudd en tant qu'administrateur le 01 juil. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Ronan Beale en tant que secrétaire le 24 mars 2025 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Mr Bernard Michael O'connor en tant que secrétaire le 24 mars 2025 | 2 pages | AP03 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2024 | 41 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 13 août 2024 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Satisfaction de la charge 023171330001 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 023171330003 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 023171330002 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Cessation de la nomination de Zak Simon Charles Houlahan en tant que directeur le 08 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Nathan Sanders en tant qu'administrateur le 12 avr. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mrs Elaine Harley en tant qu'administrateur le 12 avr. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Notification de Sse Contracting Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 mars 2024 | 2 pages | PSC02 | ||
Cessation de Aurelius Antelope Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 mars 2024 | 1 pages | PSC07 | ||
Nomination de Mr Kieran Gilmurray en tant qu'administrateur le 22 mars 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Ronan Beale en tant que secrétaire le 22 mars 2024 | 2 pages | AP03 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2023 | 42 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de ENERVEO LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'CONNOR, Bernard Michael | Secrétaire | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | 333759080001 | |||||||
| GILMURRAY, Kieran | Administrateur | Waterloo Street G2 6AY Glasgow 1 Waterloo Street Scotland | Scotland | British | 112397330002 | |||||
| HARLEY, Elaine | Administrateur | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | Scotland | British | 267341500001 | |||||
| RUDD, Adrian Marc James | Administrateur | Park Approach Thorpe Park LS15 8GB Leeds Sse Thermal | England | British | 245515390010 | |||||
| BEALE, Ronan | Secrétaire | Waterloo Street G2 6AY Glasgow 1 Waterloo Street Scotland | 320997350001 | |||||||
| DANDY, David James | Secrétaire | Eagle Court 2 Hatchford Way B26 3RZ Birmingham Second Floor England | 287408840001 | |||||||
| DONNELLY, Lawrence John Vincent | Secrétaire | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth | British | 62794440002 | ||||||
| HEARSEY, Peter Geoffrey | Secrétaire | 76 Montgomery Street BN3 5BE Hove | British | 100685710005 | ||||||
| KHALID, Mohammed Shehzad | Secrétaire | EH28 8PL Newbridge Unit 4 Queen Anne Dr United Kingdom | 261684930001 | |||||||
| MCCOMBE, Helen Elizabeth | Secrétaire | Waterloo Street G2 6AY Glasgow 1 United Kingdom | 267351200001 | |||||||
| MORRIS, Derek Aubrey Goodall | Secrétaire | 98 Braywick Road SL6 1DJ Maidenhead Berkshire | British | 9343110001 | ||||||
| SHARMA, Brian Dominic | Secrétaire | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place United Kingdom | 180722590001 | |||||||
| TANNER, Elizabeth Anne | Secrétaire | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire United Kingdom | 164973080001 | |||||||
| WALKER, Hazel Louise | Secrétaire | 41a Broughton Street EH1 3JU Edinburgh Midlothian | British | 63949790001 | ||||||
| ANDERSON, Scott Keelor | Administrateur | 200 Dunkeld Road PH1 3GH Perth Grampian House Scotland | United Kingdom | British | 204396790001 | |||||
| BARNES, Colin | Administrateur | Sheen Old Odiham Road GU34 4BW Alton Hampshire | England | British | 59878130001 | |||||
| BEVERIDGE, Steven | Administrateur | Waterloo Street G2 6AY Glasgow 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 206192530001 | |||||
| BLINCOW, Andrew Duncan | Administrateur | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 203581190001 | |||||
| BREUGELMANS, Adrianus Johannes Petrus Maria | Administrateur | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | United Kingdom | Dutch | 202301340001 | |||||
| CASLEY, Henry Roberts | Administrateur | Dogmore Cottage Stoke Row RG9 5PD Henley On Thames Oxfordshire | England | British | 21786610001 | |||||
| CASLEY, Henry Roberts | Administrateur | Dogmore Cottage Stoke Row RG9 5PD Henley On Thames Oxfordshire | England | British | 21786610001 | |||||
| CHAPMAN, Stuart John | Administrateur | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 156589490001 | |||||
| CHAPMAN, Stuart John | Administrateur | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire Ireland | United Kingdom | British | 156589490001 | |||||
| CHASTON, Stuart Paul | Administrateur | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place United Kingdom | United Kingdom | British | 230387390003 | |||||
| CULBERT, Paul | Administrateur | 55 Vastern Road RG1 8BU Reading Berkshire | British | 85030070002 | ||||||
| FARRELL, John | Administrateur | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place United Kingdom | United Kingdom | Irish | 217206050001 | |||||
| FRANKLIN, Stewart Frederick | Administrateur | Forces Farm Butterleigh EX15 1PJ Cullompton Devon | United Kingdom | British | 30560310001 | |||||
| GARNAR, Philip Douglas | Administrateur | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire United Kingdom | England | British | 36306780003 | |||||
| GAUNTLETT, David Michael | Administrateur | 1 Poplar Close Baughurst RG26 5LH Basingstoke Hampshire | British | 55769350001 | ||||||
| GRAY, David Mclaren | Administrateur | Dykeneuk Butterstone PH8 0HA Dunkeld Perthshire | Scotland | British | 140884530001 | |||||
| GREENHORN, Kevin David Andrew | Administrateur | 200 Dunkeld Road PH1 3GH Perth Grampian House Scotland | Scotland | British | 145709970001 | |||||
| HALL, Robert Michael | Administrateur | 55 Vastern Road RG1 8BU Reading Berkshire | British | 62702340002 | ||||||
| HART, James, Doctor | Administrateur | Skerrols East Road St Georges Hill KT13 0LF Weybridge Surrey | British | 10014240003 | ||||||
| HILLMAN, Christopher Michael | Administrateur | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire Ireland | England | British | 17572470002 | |||||
| HOOD, Colin William | Administrateur | 1 Wharfe Lane RG9 2LL Henley | British | 80184130001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ENERVEO LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sse Contracting Group Limited | 22 mars 2024 | No.1 Forbury Place 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Aurelius Antelope Limited | 28 sept. 2021 | Glasshouse Street W1B 5DG London 33 England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Aurelius Investment Lux Two Sarl | 28 sept. 2021 | Rue Du Château D’Eau L-3364 Leudelange 2-4 Luxembourg | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Aurelius Investments Limited | 30 juin 2021 | 33 Glasshouse Street W1B 5DG London 6th Floor United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Sse Contracting Group Limited | 06 avr. 2016 | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0