SOLENT FORKLIFT TRUCKS LIMITED

SOLENT FORKLIFT TRUCKS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSOLENT FORKLIFT TRUCKS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02320695
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SOLENT FORKLIFT TRUCKS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe SOLENT FORKLIFT TRUCKS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Orbital 7 Orbital Way
    WS11 8XW Cannock
    Staffordshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SOLENT FORKLIFT TRUCKS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour SOLENT FORKLIFT TRUCKS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    legacy

    62 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 déc. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    2 pagesAA

    legacy

    69 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Déclaration de confirmation établie le 06 déc. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Martyn Howard Fletcher en tant que secrétaire le 30 nov. 2021

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Richard Michael Greaves en tant que directeur le 30 nov. 2021

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Statuts

    7 pagesMA

    Deuxième dépôt de la déclaration de confirmation datée du 06 déc. 2016

    7 pagesRP04CS01

    Modification des détails de Forkway Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 nov. 2021

    2 pagesPSC05

    Cessation de la nomination de Martyn Howard Fletcher en tant que directeur le 30 nov. 2021

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Peter Brian Jones en tant qu'administrateur le 30 nov. 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Iain Robert Wilton en tant que secrétaire le 30 nov. 2021

    2 pagesAP03

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 janv. 2022 au 31 déc. 2021

    1 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de Unit 7 Corinium Industrial Estate Raans Road Amersham Buckinghamshire HP6 6JQ à Orbital 7 Orbital Way Cannock Staffordshire WS11 8XW le 02 déc. 2021

    1 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de SOLENT FORKLIFT TRUCKS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILTON, Iain Robert
    Orbital Way
    WS11 8XW Cannock
    Orbital 7
    Staffordshire
    England
    Secrétaire
    Orbital Way
    WS11 8XW Cannock
    Orbital 7
    Staffordshire
    England
    290139540001
    JONES, Peter Brian
    Orbital Way
    WS11 8XW Cannock
    Orbital 7
    Staffordshire
    England
    Administrateur
    Orbital Way
    WS11 8XW Cannock
    Orbital 7
    Staffordshire
    England
    EnglandBritishDirector206742000001
    FLETCHER, Martyn Howard
    Orbital Way
    WS11 8XW Cannock
    Orbital 7
    Staffordshire
    England
    Secrétaire
    Orbital Way
    WS11 8XW Cannock
    Orbital 7
    Staffordshire
    England
    195898180001
    GEARY, John Richard
    10 Renhold Road
    MK44 2QA Wilden
    Bedfordshire
    Secrétaire
    10 Renhold Road
    MK44 2QA Wilden
    Bedfordshire
    BritishAccountant75547930001
    HOOPER, Colin
    14 Sparrowgrove
    Otterbourne
    SO21 2DL Winchester
    Hampshire
    Secrétaire
    14 Sparrowgrove
    Otterbourne
    SO21 2DL Winchester
    Hampshire
    EnglishAccountant16491340001
    LEACH, Richard John
    3 Camborne Avenue
    HP21 7UZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    3 Camborne Avenue
    HP21 7UZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary1808250001
    PARKER, Benjamin Anthony
    Flat 4 The Mount
    21 Elm Grove Road
    SP1 1JW Salisbury
    Wilts
    Secrétaire
    Flat 4 The Mount
    21 Elm Grove Road
    SP1 1JW Salisbury
    Wilts
    British32411920001
    FLETCHER, Martyn Howard
    Outwood 35 Clifton Road
    Chesham Bois
    HP6 5PP Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Outwood 35 Clifton Road
    Chesham Bois
    HP6 5PP Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishManaging Director3730370002
    GREAVES, Richard Michael
    462 Accrington Road
    BB11 5DP Burnley
    Lancashire
    Administrateur
    462 Accrington Road
    BB11 5DP Burnley
    Lancashire
    EnglandBritishSales Director42246300002
    HAMBLIN, Brian Stanley
    St. Marlo
    Cot Lane, Chidham
    PO18 8SP Chichester
    West Sussex
    Administrateur
    St. Marlo
    Cot Lane, Chidham
    PO18 8SP Chichester
    West Sussex
    EnglandBritishSales91569480001
    LEACH, Richard John
    3 Camborne Avenue
    HP21 7UZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    3 Camborne Avenue
    HP21 7UZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary1808250001
    MCGAULEY, Kevin
    84 Angelica Way
    Whiteley
    PO15 7HZ Fareham
    Hampshire
    Administrateur
    84 Angelica Way
    Whiteley
    PO15 7HZ Fareham
    Hampshire
    EnglandBritishGeneral Manager112952170002
    PARKER, Benjamin Anthony
    Flat 4 The Mount
    21 Elm Grove Road
    SP1 1JW Salisbury
    Wilts
    Administrateur
    Flat 4 The Mount
    21 Elm Grove Road
    SP1 1JW Salisbury
    Wilts
    United KingdomBritishManaging Director32411920001
    PARKER, Jacqueline
    10 Oatlands
    Fishlake Meadows
    SO51 0GW Romsey
    Hampshire
    Administrateur
    10 Oatlands
    Fishlake Meadows
    SO51 0GW Romsey
    Hampshire
    EnglandBritishAdministration Manager78507710002
    PARKER, John Henry
    19 St Rowans Avenue
    Southsea
    Portsmouth
    Hampshire
    Administrateur
    19 St Rowans Avenue
    Southsea
    Portsmouth
    Hampshire
    BritishDirector20773890001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SOLENT FORKLIFT TRUCKS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Forkway Limited
    Orbital Way
    WS11 8XW Cannock
    Orbital 7
    Staffordshire
    England
    06 avr. 2016
    Orbital Way
    WS11 8XW Cannock
    Orbital 7
    Staffordshire
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementRegistrar Of Companies (England And Wales)
    Numéro d'enregistrement00788654
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    SOLENT FORKLIFT TRUCKS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge
    Créé le 02 mars 1992
    Livré le 05 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the credit agreements
    Brèves mentions
    All sub hiring agreements entered into at any time with customers of the company relating to goods now or hereafter owned by automotive financial services LTD but let by automotive financial services LTD to the company under lease agreements hire purchase agreements, condition all sale agreements and /or lease purchase agreements entered into at any time between automotive financial services LTD,and the company and the full benefit and advantage of and the monies payable under such sub-hiring agreement. (Please see doc M479 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Automotive Financial Services Limited.
    Transactions
    • 05 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 18 sept. 1991
    Livré le 20 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease purchase agreement dated 18/9/91
    Brèves mentions
    All sums due from erith building supplies co. LTD under equipment lease purchase agreement dated 21/8/91 and lease purchase agreement no. 1201263314 dated 18/9/91.
    Personnes ayant droit
    • Capital Asset Finance LTD
    Transactions
    • 20 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 30 avr. 1991
    Livré le 20 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease agreement of even dated.
    Brèves mentions
    All rentals and other sums due from erith building supplies LTD.
    Personnes ayant droit
    • Capital Asset Finance LTD.
    Transactions
    • 20 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 07 févr. 1991
    Livré le 13 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease purchase contract of even date.
    Brèves mentions
    All rentals and other sums due from sea route ferries LTD under equipment lease agreement dated 23/11/89 and lease purchase dated 7/2/91.
    Personnes ayant droit
    • Capital Asset Finance LTD
    Transactions
    • 13 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 31 oct. 1990
    Livré le 21 nov. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease agreement dated 28.9.90
    Brèves mentions
    All rentals and other sums due from tnt express (UK) LTD under forklift rental agreement dated 12.9.90 and lease contract no. 1191314521 thereto dated 28.9.90 with the company.
    Personnes ayant droit
    • Capital Asset Finance Limited
    Transactions
    • 21 nov. 1990Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 09 oct. 1990
    Livré le 23 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease agreement dated 9/10/90
    Brèves mentions
    All rentals and other sums due from southern water services limited under an equipment lease agreement d/d 25/9/90 and lease agreement no 11913327.28 thereto d/d 9/10/90 with solent forklift trucks limited.
    Personnes ayant droit
    • Capital Asset Finance Limited
    Transactions
    • 23 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 29 août 1990
    Livré le 03 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All rentals and other sums due from the company to the chargee under the terms of a lease agreement dated 29.8.90
    Brèves mentions
    All rentals and other sums due from pirelli general PLC under equipment lease agreement dated 13.8.90 and lease contract no. 11912600-14.
    Personnes ayant droit
    • Capital Asset Finance Limited
    Transactions
    • 03 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 26 sept. 1989
    Livré le 11 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease agreement dated 26/9/89
    Brèves mentions
    All rentals and other sums due from powder coatings southern LTD under equipment lease agreement d/d 1/9/89 and lease contract no 1190616428 thereto dated 26/9/89.
    Personnes ayant droit
    • Capital Asset Finance LTD
    Transactions
    • 11 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    • 27 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 sept. 1989
    Livré le 12 sept. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 sept. 1989Enregistrement d'une charge
    • 13 oct. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0