B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéB.I.B. UNDERWRITERS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02321506
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED ?

    • Assurance non-vie (65120) / Activités financières et d'assurance
    • Réassurance non-vie (65202) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    B.I.B. (CLEVELAND) LIMITED25 nov. 198825 nov. 1988

    Quels sont les derniers comptes de B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2021

    16 pagesAA

    legacy

    215 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2022 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    État du capital au 29 mars 2022

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Dean Clarke en tant que secrétaire le 27 janv. 2022

    1 pagesTM02

    Nomination de Ardonagh Corporate Secretary Limited en tant que secrétaire le 27 janv. 2022

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Scott William Hough en tant que directeur le 27 janv. 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Jonathan Guy Sutton en tant qu'administrateur le 27 janv. 2022

    2 pagesAP01

    Statuts

    20 pagesMA

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Statuts

    20 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    29 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    38 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Scott William Hough le 12 oct. 2020

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ARDONAGH CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Secrétaire
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement03702575
    288842300001
    COLES, Derek John
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Quay Point
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Quay Point
    South Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish114763370001
    SUTTON, Jonathan Guy, Mr
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Administrateur
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    EnglandBritish292196320001
    ATKINSON, Peter
    22 Foxglove Close
    Romanby
    DL7 8FB Northallerton
    North Yorkshire
    Secrétaire
    22 Foxglove Close
    Romanby
    DL7 8FB Northallerton
    North Yorkshire
    British8775510002
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    155742990001
    CLARKE, Dean
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Secrétaire
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    253940570001
    GOURIET, Geoffrey Costerton
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Secrétaire
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    249087740001
    GOURIET, Geoffrey Costerton
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Secrétaire
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    208512110001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Secrétaire
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    222331280001
    JOWETT, Marion
    5 Mill Croft
    DL10 4TR Richmond
    North Yorkshire
    Secrétaire
    5 Mill Croft
    DL10 4TR Richmond
    North Yorkshire
    British16445080001
    OWENS, Jennifer
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    183283520001
    ATKINSON, Peter
    22 Foxglove Close
    Romanby
    DL7 8FB Northallerton
    North Yorkshire
    Administrateur
    22 Foxglove Close
    Romanby
    DL7 8FB Northallerton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish8775510002
    BARR, Graham Maxwell
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish125097020001
    BRUCE, David James
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish171398800001
    CARTER, Christopher David
    7 Meadow Court
    Scruton
    DL7 0QU Northallerton
    North Yorkshire
    Administrateur
    7 Meadow Court
    Scruton
    DL7 0QU Northallerton
    North Yorkshire
    British8775520001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish149939610001
    DILLEY, Paul John
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish253688230001
    EGAN, Scott
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish170703910001
    EROTOCRITOU, Antonios
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    United KingdomCypriot167795710001
    HODGES, Mark Steven
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish58444370003
    HOUGH, Scott William
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Quay Point
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Quay Point
    South Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish85495940006
    KENT, Christopher John
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish253698330001
    LITTLETON, Martin Paul
    The Gill
    Harmby
    DL8 5PE Leyburn
    North Yorkshire
    Administrateur
    The Gill
    Harmby
    DL8 5PE Leyburn
    North Yorkshire
    United KingdomBritish8775530001
    MUGGE, Mark Stephen
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    EnglandBritish162920630005
    PARK, Bryan
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish113694470002
    REA, Michael Peter
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish147194830001
    RECORD, Stephen Paul
    45 Baydale Road
    DL3 8JT Darlington
    County Durham
    Administrateur
    45 Baydale Road
    DL3 8JT Darlington
    County Durham
    United KingdomBritish94239820001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueCompany Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement5216169
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    B.I.B. UNDERWRITERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of accession
    Créé le 22 févr. 2011
    Livré le 03 mars 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors (including the company) to any secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (As Agent and Trustee for Itself and the Secured Parties)
    Transactions
    • 03 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of accession
    Créé le 22 févr. 2011
    Livré le 03 mars 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors (including the company) to any secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (As Agent and Trustee for Itself and the Secured Parties)
    Transactions
    • 03 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 04 oct. 1996
    Livré le 10 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or B.I.B. (darlington) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    150,152 and 154 northgate darlington durham t/n DU51910.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 21 sept. 1990
    Livré le 05 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 24 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 19 janv. 1990
    Livré le 30 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 04 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 20 juin 1989
    Livré le 27 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 juin 1989Enregistrement d'une charge
    • 04 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0