WORLDWIDE CONNECTIONS LIMITED

WORLDWIDE CONNECTIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWORLDWIDE CONNECTIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02328710
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WORLDWIDE CONNECTIONS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe WORLDWIDE CONNECTIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WORLDWIDE CONNECTIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ELLIS TROWBRIDGE LIMITED15 déc. 198815 déc. 1988

    Quels sont les derniers comptes de WORLDWIDE CONNECTIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour WORLDWIDE CONNECTIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 mars 2012

    État du capital au 07 mars 2012

    • Capital: GBP 174
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2011

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Joanne Sarah Finch en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Richard Wolfgang Henry Schäfer en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Thomas Nowak en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Christian Allen en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2010

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Martin John Purkess le 01 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Résolutions

    Resolutions
    32 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolutions

    S175(5) 21/12/2009
    RES13
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Thomas Nowak le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christian Philip Quentin Allen le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Martin Purkess le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 mars 2009

    6 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de WORLDWIDE CONNECTIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WRIGHT, Garth Howard
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British111162790001
    FINCH, Joanne Sarah
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish158146620001
    PURKESS, Martin John
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish139360020001
    SCHÄFER, Richard Wolfgang Henry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158146600001
    GOULD, Steven Ashley Fraser
    1 Grove Avenue
    Fishponds
    BS16 2DJ Bristol
    Avon
    Secrétaire
    1 Grove Avenue
    Fishponds
    BS16 2DJ Bristol
    Avon
    British36537100001
    HOWIE, Philip Robert Sutherland
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British77939460004
    LAVER, John Michael
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    Secrétaire
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    British8207040001
    SCOTT, Stephen Roy
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    British25660590003
    TROWBRIDGE, Dawn Hilary
    Ash House 3 Beechfield Close
    Long Ashton
    BS18 9JP Bristol
    Secrétaire
    Ash House 3 Beechfield Close
    Long Ashton
    BS18 9JP Bristol
    British40342650002
    TROWBRIDGE, Kenneth John
    Ash House 3 Beechfield Close
    Long Ashton
    BS18 9JP Bristol
    Secrétaire
    Ash House 3 Beechfield Close
    Long Ashton
    BS18 9JP Bristol
    British44561600001
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British123612980001
    BREWER, Stephen
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    British79186090002
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Administrateur
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    British83126790001
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British99525280001
    EDWARDS, Peter David
    Hockets
    Oriental Road
    SL5 7AZ Sunninghill
    Berkshire
    Administrateur
    Hockets
    Oriental Road
    SL5 7AZ Sunninghill
    Berkshire
    British1908570001
    ELLIS, Donald Lionel
    Trevone Farm House
    Mabe
    TR10 9JQ Penryn
    Cornwall
    Administrateur
    Trevone Farm House
    Mabe
    TR10 9JQ Penryn
    Cornwall
    British7436930004
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British127017870001
    FREEMAN, William Ian Bede
    Herons Cottage
    Ferry Lane, Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Herons Cottage
    Ferry Lane, Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish64442870001
    GRAY, Ian
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    Administrateur
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    United KingdomBritish50246030004
    HALFORD, Andrew Nigel
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    British33951180005
    KEAYS, Helen Margaret
    Clematis Cottage
    Old Warwick Road Rowington
    CV35 7AA Warwick
    Warwickshire
    Administrateur
    Clematis Cottage
    Old Warwick Road Rowington
    CV35 7AA Warwick
    Warwickshire
    British55393460002
    KEY, Matthew David
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British62981720001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Administrateur
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritish24471140001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    NOWAK, Thomas, Dr
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomGerman174443800001
    READ, Nicholas Jonathan
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish87149560001
    SHERWOOD, Timothy Robin
    Berry Oaks
    12 Woodlands Avenue
    RG41 3HL Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    Berry Oaks
    12 Woodlands Avenue
    RG41 3HL Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish104309090001
    TOURNON, Emanuele
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomItalian103542080002
    TOWNSEND, John Raymond
    Knowle House
    Chapel Corner Hamstead Marshall
    RG20 0HP Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Knowle House
    Chapel Corner Hamstead Marshall
    RG20 0HP Newbury
    Berkshire
    British95223480001
    TROWBRIDGE, Kenneth John
    Ash House 3 Beechfield Close
    Long Ashton
    BS18 9JP Bristol
    Administrateur
    Ash House 3 Beechfield Close
    Long Ashton
    BS18 9JP Bristol
    British44561600001
    WATSON, Ian
    School House
    Oakley Park Frilford Heath
    OX13 6QW Abingdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    School House
    Oakley Park Frilford Heath
    OX13 6QW Abingdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritish117671590001
    WEBB, Denys William
    Oakfield Stud
    Whitemoor Lane, Upper Basildon
    RG8 8SF Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Oakfield Stud
    Whitemoor Lane, Upper Basildon
    RG8 8SF Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish76074580001
    WHITTLE, John Richard
    54 Stirling Road
    BH3 7JH Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    54 Stirling Road
    BH3 7JH Bournemouth
    Dorset
    British69660920001

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0